NESTOR HEALTHCARE GROUP LIMITED

NESTOR HEALTHCARE GROUP LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaNESTOR HEALTHCARE GROUP LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01992981
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de NESTOR HEALTHCARE GROUP LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica NESTOR HEALTHCARE GROUP LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Allen House
    Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de NESTOR HEALTHCARE GROUP LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    NESTOR HEALTHCARE GROUP PLC13/06/199713/06/1997
    NESTOR-BNA PUBLIC LIMITED COMPANY30/04/198630/04/1986
    FOLDEAGLE LIMITED27/02/198627/02/1986

    Quais são as últimas contas de NESTOR HEALTHCARE GROUP LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2016

    Quais são as últimas submissões para NESTOR HEALTHCARE GROUP LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    14 páginasLIQ14

    Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia

    5 páginasNDISC

    Término da nomeação de David Collison como secretário em 14/12/2018

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Carl Michael Brown como diretor em 29/11/2018

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Luca Warnke como diretor em 01/11/2018

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Joanne Machin como diretor em 01/11/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução extraordinária para a liquidação em 17/05/2018

    LRESEX

    Estado de situação patrimonial

    8 páginasLIQ02

    Declaração de confirmação apresentada em 30/05/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Endereço do domicílio registado alterado de Cavendish House Lakhpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX England para Allen House Westmead Road Sutton SM1 4LA em 18/05/2018

    1 páginasAD01

    Nomeação de Miss Joanne Machin como diretor em 01/08/2017

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de John Henry Whitehead como diretor em 16/06/2017

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Carl Michael Brown como diretor em 16/06/2017

    2 páginasAP01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de PO Box 82 the Pavilions Bridgwater Road Bristol BS99 6ZZ para Cavendish House Lakhpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX

    1 páginasAD02

    Declaração de confirmação apresentada em 30/05/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada PO Box 82 the Pavilions Bridgwater Road Bristol BS99 6ZZ

    1 páginasAD03

    Contas anuais preparadas até 31/12/2016

    15 páginasAA

    Os registos foram transferidos para o endereço do domicílio registado Cavendish House Lakhpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX

    2 páginasAD04

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    17 páginasAA

    Nomeação de Mr Luca Warnke como diretor em 26/09/2016

    2 páginasAP01

    Resoluções

    Resolutions
    20 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Término da nomeação de Catherine Lois Mason como diretor em 05/08/2016

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de NESTOR HEALTHCARE GROUP LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    COLLISON, David
    Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    England
    Secretário
    Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    England
    204215730001
    COLLISON, David
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    Secretário
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    British34835160001
    DAVIES, John
    Sandgate High Street
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Secretário
    Sandgate High Street
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    British157502960001
    HAYNES, Victoria
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Secretário
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    British182412280001
    ROBERTS THOMAS, Caroline Emma
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    Secretário
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    BritishCompany Secretary76032450005
    STRINGER, Andrew Paul
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Secretário
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    171546430001
    WOOD, John
    Pear Tree Cottage
    Bishopstone
    HP12 8SH Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretário
    Pear Tree Cottage
    Bishopstone
    HP12 8SH Aylesbury
    Buckinghamshire
    British59323380001
    ALEXANDER, Ingrid Carol
    37 Kent Road
    W4 5EY London
    Diretor
    37 Kent Road
    W4 5EY London
    BritishManagement Consultant78029330001
    BATCHELOR, Lance Henry Lowe
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Chief Executive194139680001
    BEEVOR, Anthony Romer
    20 Radipole Road
    SW6 5DL London
    Diretor
    20 Radipole Road
    SW6 5DL London
    EnglandBritishCo Directer14269200002
    BENSON, Jeremy Michael
    School Lane
    Newington
    ME9 7LB Sittingbourne , Kent
    Parsonage House
    England
    England
    Diretor
    School Lane
    Newington
    ME9 7LB Sittingbourne , Kent
    Parsonage House
    England
    England
    United KingdomBritishCompany Director158879270001
    BOOTY, Stephen Martin
    South Lodge
    Guildford Road
    KT24 5QE Effingham
    Surrey
    Diretor
    South Lodge
    Guildford Road
    KT24 5QE Effingham
    Surrey
    EnglandBritishDirector147928010001
    BRIDGEMAN, Robin John Orlando
    19 Chepstow Road
    W2 5BP London
    Diretor
    19 Chepstow Road
    W2 5BP London
    EnglandBritishCompany Director5943640001
    BROWN, Carl Michael
    Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    England
    Diretor
    Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Allen House
    England
    EnglandBritishAccountant232841280001
    BURNS, Robert Ian
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector36584260002
    CHAPMAN, Clive Richard
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    Diretor
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    United KingdomBritishFinance Director86129050001
    COCKBURN, John Jeffrey, Doctor
    Flat 14 Brompton Court
    2a Brompton Avenue Sefton Park
    L17 3BY Liverpool
    Diretor
    Flat 14 Brompton Court
    2a Brompton Avenue Sefton Park
    L17 3BY Liverpool
    BritishCompany Director11672280012
    DIXON, Patrick John Vibart
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director50086040003
    DYE, Iain Roger
    Russells Barn
    Rockwell End Hambleden
    RG9 6NG Henley On Thames
    Oxfordshire
    Diretor
    Russells Barn
    Rockwell End Hambleden
    RG9 6NG Henley On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant44532410003
    ELLIS, Martyn Anthony
    83 Boss House
    Boss Street
    SE1 2PT London
    Diretor
    83 Boss House
    Boss Street
    SE1 2PT London
    EnglandBritishFinance Director95749550002
    FOSTER, Andrew William, Sir
    269 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LZ London
    Diretor
    269 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LZ London
    United KingdomBritishDirector48364150002
    GIBSON, Darryn Stanley
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomNew ZealanderCompany Director177930490001
    GOODSELL, John Andrew
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director51490510002
    GOODSON-WICKES, Charles, Dr
    Flat 23
    37 St James's Place
    SW1A 1NS London
    Diretor
    Flat 23
    37 St James's Place
    SW1A 1NS London
    EnglandBritishPhysician28661020002
    HANN, Herbert John
    132 Rivermead Court
    Ranelagh Gardens
    SW6 3SE London
    Diretor
    132 Rivermead Court
    Ranelagh Gardens
    SW6 3SE London
    United KingdomBritishCompany Director101722570001
    HARRIS, Timothy Charles, Mr Cbe Fca Acma
    120 Paramount Court
    38-39 University Street
    WC1E 6JP London
    Diretor
    120 Paramount Court
    38-39 University Street
    WC1E 6JP London
    EnglandBritishCompany Director178982590001
    HEYWOOD, David George
    Logie Cedar Road
    GU22 0JH Woking
    Surrey
    Diretor
    Logie Cedar Road
    GU22 0JH Woking
    Surrey
    BritishCompany Director6298840001
    HOLMES, William Francis, Dr
    132 Nottingham Road
    Ravenshead
    NG15 9HL Nottingham
    Nottinghamshire
    Diretor
    132 Nottingham Road
    Ravenshead
    NG15 9HL Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDoctor7392620001
    HORGAN, Michael David
    7 Lady Yorke Park
    Seven Hills Road
    SL0 0PD Iver
    Buckinghamshire
    Diretor
    7 Lady Yorke Park
    Seven Hills Road
    SL0 0PD Iver
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector107985980001
    HOWARD, Francis John Adrian
    Flat 1
    11 Cadogan Square
    SW1X 0HT London
    Diretor
    Flat 1
    11 Cadogan Square
    SW1X 0HT London
    BritishFinancial & Business Consultant7170170002
    HOWARD, Stuart Michael
    Enbrook Park
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    Enbrook Park
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director160271430001
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Diretor
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishDirector109591300001
    IVERS, John Joseph
    Sandon Brook Manor
    Maldon Road
    CM2 7RZ Chelmsford
    Brook Lodge
    Essex
    Diretor
    Sandon Brook Manor
    Maldon Road
    CM2 7RZ Chelmsford
    Brook Lodge
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director77692980002
    JACKSON, Mark Bentley
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director61300600003
    JEWITT, Justin Allan Spaven, Professor
    The Stables
    89 Aston End Road Aston
    SG2 7EY Stevenage
    Hertfordshire
    Diretor
    The Stables
    89 Aston End Road Aston
    SG2 7EY Stevenage
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director39701670001

    Quem são as pessoas com controle significativo de NESTOR HEALTHCARE GROUP LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Allied Hc Group Limited
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    06/04/2016
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House England And Wales
    Número de registro9883584
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    NESTOR HEALTHCARE GROUP LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A security agreement
    Criado em 16/11/2009
    Entregue em 23/11/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transações
    • 23/11/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 21/07/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Security agreement
    Criado em 08/03/2006
    Entregue em 22/03/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The present and future shares being all shares in nestor primecare services limited and its interest in all shares stocks debentures bonds or other securities and investments and all fixed plant machinery goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank (The Facility Agent)
    Transações
    • 22/03/2006Registro de uma garantia (395)
    • 19/11/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal mortgage
    Criado em 26/03/1993
    Entregue em 01/04/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a new hall hospital bodenham salisbury wiltshire and the proceeds of sale and an assignment of the goodwill and connection of any business tog with the full benefit of all licences the entry in col.6 Above has this day been amended please see doc.M54.R.M.groves 5/7/93. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 01/04/1993Registro de uma garantia (395)
    • 24/11/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over credit balance.
    Criado em 10/04/1990
    Entregue em 23/04/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from thecompany* to the chargee on any account whatsoever *in relation to a specific counter indemnity by nestor-B.N.A. PLC dated 09/04/90 covering a standby letter of credit number BGTBG90E211 & dated 10/04/90 issued on behalf of british nursing association inc in favour of mrs irene thoms
    Breve descrição
    The sum of $10,200, together with interest accured now or to be held by national westminster bank PLC on account numbered 443387 no:2 a/c and earmarked or designated by reference to the company.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 23/04/1990Registro de uma garantia
    • 24/11/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over credit balance
    Criado em 10/04/1990
    Entregue em 23/04/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from thecompany* to the chargee on any account whatsoever *in relation to a specific counter indemnity by nestor B.N.A. dated 09/04/90 which covers a standby letter of credit numbered BGTBG90E210 and dated 10/04/90 issued on behalf of british nursing association in favour of mr norman thomas
    Breve descrição
    The sum of us $10,200,000 together with interest accrued now or to be held by national pank PLC on account numbered 443344 no.1 A/c and earmarked or designated by reference to the company.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 23/04/1990Registro de uma garantia
    • 24/11/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 30/04/1986
    Entregue em 09/05/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    (See doc M17). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Investors in Industry PLC
    Transações
    • 09/05/1986Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 30/04/1986
    Entregue em 09/05/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charges upon: all f/hold and l/hold property the goodwill and the uncalled capital present and future the book and other details present and future. Floating charges upon all other of the (see doc M16). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transações
    • 09/05/1986Registro de uma garantia
    Mortgage debenture
    Criado em 30/04/1984
    Entregue em 09/05/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all & f/hold and l/hold properties and/or the proceeds of sale thereof. (See doc M18). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 09/05/1986Registro de uma garantia

    NESTOR HEALTHCARE GROUP LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    17/05/2018Início da liquidação
    25/10/2019Data de dissolução
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Martin Charles Armstrong
    Turpin Barker Armstrong
    Allen House
    SM1 4LA One Westmead Road
    Sutton Surrey
    Profissional
    Turpin Barker Armstrong
    Allen House
    SM1 4LA One Westmead Road
    Sutton Surrey

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0