ARRIVA CROYDON & NORTH SURREY LIMITED

ARRIVA CROYDON & NORTH SURREY LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaARRIVA CROYDON & NORTH SURREY LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02005267
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ARRIVA CROYDON & NORTH SURREY LIMITED?

    • Outro transporte terrestre de passageiros urbano, suburbano ou metropolitano (não metro, metropolitano ou sistemas similares) (49319) / Transportes e armazenagem

    Onde fica ARRIVA CROYDON & NORTH SURREY LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ARRIVA CROYDON & NORTH SURREY LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    LONDON & COUNTRY LIMITED18/02/199318/02/1993
    LONDON COUNTRY BUS (SOUTH WEST) LIMITED01/04/198601/04/1986

    Quais são as últimas contas de ARRIVA CROYDON & NORTH SURREY LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2013

    Qual é o status da última declaração anual para ARRIVA CROYDON & NORTH SURREY LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para ARRIVA CROYDON & NORTH SURREY LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Término da nomeação de Kenneth Mcintyre Carlaw como diretor em 31/03/2016

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mrs Lorna Edwards como diretor em 31/03/2016

    2 páginasAP01

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    8 páginas4.71

    Endereço do domicílio registado alterado de 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP para 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor York YO30 4XG em 23/02/2015

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação

    LRESSP

    Término da nomeação de Richard Anthony Bowler como diretor em 18/11/2014

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Beverley Elizabeth Lawson como diretor em 18/11/2014

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Kenneth Mcintyre Carlaw como diretor em 18/11/2014

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Kevin Paul Hawkins como diretor em 18/10/2014

    1 páginasTM01

    Contas preparadas até 31/12/2013

    10 páginasAA

    Término da nomeação de Brian Barraclough como diretor em 06/08/2014

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 18/07/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital18/07/2014

    Estado do capital em 18/07/2014

    • Capital: GBP 363,394
    SH01

    Nomeação de Lorna Edwards como secretário em 16/12/2013

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Elizabeth Anne Davies como secretário em 16/12/2013

    1 páginasTM02

    Contas anuais preparadas até 31/12/2012

    12 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Richard Anthony Bowler em 16/08/2013

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 18/07/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas preparadas até 31/12/2011

    6 páginasAA

    Declaração anual preparada até 18/07/2012 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Detalhes do secretário alterados para Ms Elizabeth Anne Thorpe em 26/05/2012

    1 páginasCH03

    Contas anuais preparadas até 31/12/2010

    11 páginasAA

    Declaração anual preparada até 18/07/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Quem são os diretores de ARRIVA CROYDON & NORTH SURREY LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    EDWARDS, Lorna
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    Secretário
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    183716180001
    EDWARDS, Lorna
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    Diretor
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    EnglandBritishCompany Director205425080001
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Secretário
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    HODGETTS, Robert Ian
    10 Harewood Close
    RH2 0HE Reigate
    Surrey
    Secretário
    10 Harewood Close
    RH2 0HE Reigate
    Surrey
    English29310460002
    LAWSON, Beverley Elizabeth
    41 Rook Lane
    CR3 5AP Chaldon
    Surrey
    Secretário
    41 Rook Lane
    CR3 5AP Chaldon
    Surrey
    British67540260001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Secretário
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Secretário
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    BARKER, Neil James
    50 Woodfield Road
    B13 9UJ Kings Heath
    Birmingham
    Diretor
    50 Woodfield Road
    B13 9UJ Kings Heath
    Birmingham
    EnglandBritishCompany Director165014000001
    BARRACLOUGH, Brian
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Diretor
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishDirector63708760003
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director42058550001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Diretor
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritishCompany Director35116070003
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    Diretor
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    EnglandBritishDirector And Company Secretary161250030001
    FERNS, Stephen John
    17 Moxom Avenue
    Cheshunt
    EN8 9RN Waltham Cross
    Hertfordshire
    Diretor
    17 Moxom Avenue
    Cheshunt
    EN8 9RN Waltham Cross
    Hertfordshire
    BritishOperations Director69767310001
    GWILT, Michael Peter
    17 Telford Close
    High Shincliffe
    DH1 2YJ Durham
    Diretor
    17 Telford Close
    High Shincliffe
    DH1 2YJ Durham
    BritishCompany Director51840420005
    HAWKINS, Kevin Paul
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Diretor
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritishCompany Director46684820002
    HODGETTS, Robert Ian
    10 Harewood Close
    RH2 0HE Reigate
    Surrey
    Diretor
    10 Harewood Close
    RH2 0HE Reigate
    Surrey
    United KingdomEnglishDirector29310460002
    JACKSON, Brian Malcolm
    Cedar House Manor Court
    Barton Under Needwood
    DE13 8AU Burton On Trent
    Staffordshire
    Diretor
    Cedar House Manor Court
    Barton Under Needwood
    DE13 8AU Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishManaging Director90088220001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Director77984700001
    LAWSON, Beverley Elizabeth
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Diretor
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritishFinance Director67540260001
    LAWSON, Beverley Elizabeth
    41 Rook Lane
    CR3 5AP Chaldon
    Surrey
    Diretor
    41 Rook Lane
    CR3 5AP Chaldon
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant67540260001
    LIM, Eileen Frances
    Watling Hall
    London Road
    CT16 3DJ Temple Ewell
    Kent
    Diretor
    Watling Hall
    London Road
    CT16 3DJ Temple Ewell
    Kent
    BritishFinance Director104150450001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Diretor
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritishChartered Accountant4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Diretor
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector6874440001
    MC ARDLE, Stanley Lawrence
    Barn Ridge Cottage
    Farley
    SP5 1AH Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    Barn Ridge Cottage
    Farley
    SP5 1AH Salisbury
    Wiltshire
    BritishDirector4644990001
    MCENHILL, Peter Raymond
    Burroughs Hill
    Duck Lane, Laverstock
    SP1 1PU Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    Burroughs Hill
    Duck Lane, Laverstock
    SP1 1PU Salisbury
    Wiltshire
    BritishDirector65346840001
    MILLS, Adam Francis
    The Old Vicarage
    Great Durnford
    SP4 6AZ Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    The Old Vicarage
    Great Durnford
    SP4 6AZ Salisbury
    Wiltshire
    BritishDirector4058810001
    PIPER, John Peter
    6 Sandown Close
    TN2 4RL Tunbridge Wells
    Kent
    Diretor
    6 Sandown Close
    TN2 4RL Tunbridge Wells
    Kent
    BritishCompany Director34903290001
    PIPER, John Peter
    6 Sandown Close
    TN2 4RL Tunbridge Wells
    Kent
    Diretor
    6 Sandown Close
    TN2 4RL Tunbridge Wells
    Kent
    BritishDirector34903290001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Diretor
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishCompany Director58415290001
    SCOWEN, Robert
    9 North View Crescent
    KT18 5UW Epsom Downs
    Surrey
    Diretor
    9 North View Crescent
    KT18 5UW Epsom Downs
    Surrey
    EnglandBritishDirector150422440001
    STANLEY, Richard Morgan Oliver, The Honourable
    Wood End House
    Ridgeway Lane
    SO41 8AA Lymington
    Hampshire
    Diretor
    Wood End House
    Ridgeway Lane
    SO41 8AA Lymington
    Hampshire
    BritishCompany Director37521320001
    TARRAN, Ian Richard
    68 Paddock Mead
    CM18 7RS Harlow
    Essex
    Diretor
    68 Paddock Mead
    CM18 7RS Harlow
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director46684860001
    TOY, David James
    20 Rushfords
    RH7 6EG Lingfield
    Surrey
    Diretor
    20 Rushfords
    RH7 6EG Lingfield
    Surrey
    BritishEngineering Director58904690002
    WARD, Anthony Peter
    Green Fields Lane
    TN23 5LH Ashford
    42
    Kent
    Diretor
    Green Fields Lane
    TN23 5LH Ashford
    42
    Kent
    United KingdomBritishEngineer189969900001
    WATT, Gordon George
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director67622780002

    ARRIVA CROYDON & NORTH SURREY LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Chattels mortgage
    Criado em 11/10/1995
    Entregue em 12/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    4 used leyland national greenways coaches. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Forward Trust Limited
    Transações
    • 12/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 25/07/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 06/03/1995
    Entregue em 07/03/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Forward Trust Limited
    Transações
    • 07/03/1995Registro de uma garantia (395)
    • 25/07/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 29/12/1994
    Entregue em 29/12/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule. Or any part therof. The chattels comprising ;- fourteen used national greenway single deck buses; new reg nos pdz 6264 old reg nos erp 551T chassis nos ;05879, pdz 6265 old reg nos gpj 891N chassis no 02057., new reg no sji 5066 old reg nos nen 961R chassis 04139. please see doc for further details,.
    Pessoas com direito
    • Forward Trust Limited
    Transações
    • 29/12/1994Registro de uma garantia (395)
    • 25/07/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Letter of charge and set-off
    Criado em 15/08/1994
    Entregue em 31/08/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994
    Breve descrição
    All monies now or at any ime hereafter standing to the credit of any accountr or accounts of the company in the banks books.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 31/08/1994Registro de uma garantia (395)
    • 06/07/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 25/07/1994
    Entregue em 26/07/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Four used national greenway single deck buses. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Forward Trust Limited
    Transações
    • 26/07/1994Registro de uma garantia (395)
    • 17/09/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 04/05/1994
    Entregue em 17/05/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the charge)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The First National Bank of Boston("the Agent")
    Transações
    • 17/05/1994Registro de uma garantia (395)
    • 01/05/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 10/12/1992
    Entregue em 14/12/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The First National Bank of Boston
    Transações
    • 14/12/1992Registro de uma garantia (395)
    • 17/09/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 17/07/1992
    Entregue em 04/08/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    See form 395 ref M105. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The First National Bank of Boston
    Transações
    • 04/08/1992Registro de uma garantia (395)
    • 17/09/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 12/09/1990
    Entregue em 14/09/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor & Company of the Book of Scotland
    Transações
    • 14/09/1990Registro de uma garantia
    • 17/09/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 25/07/1989
    Entregue em 31/07/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £124,678 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    Two ploxton paramount 3500 "four star" luxurin coach bodies 127X2. W.D.
    Pessoas com direito
    • Lombord North Central PLC
    Transações
    • 31/07/1989Registro de uma garantia
    Chatter mortgage
    Criado em 01/06/1989
    Entregue em 07/06/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,452,090 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    32 volvo bus chass in s/w: 21905-21908 22180-22181 22421-22429 22445-22453 22503-22504 22308-22309.
    Pessoas com direito
    • Lambord North Central PLC
    Transações
    • 07/06/1989Registro de uma garantia
    Fixed and floating charge
    Criado em 03/05/1989
    Entregue em 23/05/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Please see more 395 M530C.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The First National Bank of Boston.
    Transações
    • 23/05/1989Registro de uma garantia
    • 17/09/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 19/02/1988
    Entregue em 01/03/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and rights and assets present and future including all debts, goodwill & uncalled capital. All intellectual property (please refer to form M395 and attached schedule thereto ref M650/2 mar/cf).
    Pessoas com direito
    • The First National Bank of Boston.
    Transações
    • 01/03/1988Registro de uma garantia
    • 17/09/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    ARRIVA CROYDON & NORTH SURREY LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    06/02/2015Início da liquidação
    07/06/2016Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Andrew Graham Mackenzie
    Unit 8b Marina Court Castle Street
    HU1 1TJ Hull
    North Humberside
    Profissional
    Unit 8b Marina Court Castle Street
    HU1 1TJ Hull
    North Humberside
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Profissional
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0