LTG GATESHEAD GROUP PLC

LTG GATESHEAD GROUP PLC

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaLTG GATESHEAD GROUP PLC
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade anónima cotada
    Número da empresa 02010022
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    Endereço do escritório registrado
    c/o IMAGELINX UK LTD
    Julias Way Station Park Lowmoor Road
    Kirkby-In-Ashfield
    NG17 7RB Nottingham
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CRABTREE GROUP PLC21/06/199321/06/1993
    SOMERSET TRUST PLC10/07/199210/07/1992
    CHILDREN'S MEDICAL CHARITY INVESTMENT TRUST PLC14/04/198614/04/1986

    Quais são as últimas contas de LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2011

    Quais são as últimas submissões para LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011

    2 páginasAA

    Nomeação de Mrs Louise Palmer como diretor em 16/11/2010

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 24/02/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital08/03/2012

    Estado do capital em 08/03/2012

    • Capital: GBP 2,028,329.9
    SH01

    Endereço do domicílio registado alterado de C/0 Imagelinx Uk Ltd Julias Way Station Park Lowmoor Road Kirkby in Ashfield Nottinghamshire NG17 5HN em 08/03/2012

    1 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2010

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 24/02/2011

    13 páginasAR01

    Término da nomeação de Albert Klein como diretor

    2 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2009

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 24/02/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Albert Kenngott Klein em 01/01/2010

    2 páginasCH01

    Contas preparadas até 31/12/2008

    6 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    Contas anuais preparadas até 31/12/2007

    11 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    Contas preparadas até 31/12/2006

    7 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Quem são os diretores de LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    PALMER, Louise
    12 The Pinfold
    Glapwell
    S44 5PU Chesterfield
    Derbyshire
    Secretário
    12 The Pinfold
    Glapwell
    S44 5PU Chesterfield
    Derbyshire
    British119011320002
    PALMER, Louise
    c/o Imagelinx Uk Ltd
    Lowmoor Road
    Kirkby-In-Ashfield
    NG17 7RB Nottingham
    Julias Way Station Park
    United Kingdom
    Diretor
    c/o Imagelinx Uk Ltd
    Lowmoor Road
    Kirkby-In-Ashfield
    NG17 7RB Nottingham
    Julias Way Station Park
    United Kingdom
    United KingdomBritish119011320002
    RAE, Alistair Kynoch
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    Diretor
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    United KingdomBritish53806830002
    BANGE, Udo Karl
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    Secretário
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    German69193840001
    CHESSER, David
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    Secretário
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    British64149560002
    DAVIDSON, Alan
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Secretário
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British30827780001
    HUNTER, Nicholas James
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    Secretário
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    British94273950001
    OURY, Richard Anthony
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    Secretário
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    British29821230002
    ROWSON, Peter Aston
    Croft Lodge
    Church Lane Great Longstone
    DE45 1TB Bakewell
    Derbyshire
    Secretário
    Croft Lodge
    Church Lane Great Longstone
    DE45 1TB Bakewell
    Derbyshire
    British94699120001
    C S INVESTMENTS LIMITED
    125 High Holborn
    WC1V 6PY London
    Secretário
    125 High Holborn
    WC1V 6PY London
    4852550001
    THROGMORTON SECRETARIES LIMITED
    42 Portman Road
    RG30 1EA Reading
    Berkshire
    Secretário
    42 Portman Road
    RG30 1EA Reading
    Berkshire
    80839850001
    ARMSTRONG, Michael John Lloyd
    Moor Mill Farm
    Lydeard,St Lawrence
    TA4 3RG Taunton
    Somerset
    Diretor
    Moor Mill Farm
    Lydeard,St Lawrence
    TA4 3RG Taunton
    Somerset
    British48330740002
    BANGE, Udo Karl
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    Diretor
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    German69193840001
    BARNETT, Joel, The Right Honourable Lord Barnett
    7 Hillingdon Road
    Whitefield
    M45 7QQ Manchester
    Lancashire
    Diretor
    7 Hillingdon Road
    Whitefield
    M45 7QQ Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish2883500001
    CHESSER, David
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    Diretor
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    EnglandBritish64149560002
    COOPER, Matthew
    Newlands
    Marchburn Lane
    NE44 6DN Riding Mill
    Northumberland
    Diretor
    Newlands
    Marchburn Lane
    NE44 6DN Riding Mill
    Northumberland
    United KingdomBritish35122920001
    DAVIDSON, Alan
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Diretor
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    EnglandBritish30827780001
    FELLERMAN, Paul
    38 Sherwood Road
    Hendon
    NW4 1AD London
    Diretor
    38 Sherwood Road
    Hendon
    NW4 1AD London
    British10266750001
    FLETCHER, Alan Thomas
    26 Loudoun Road
    NW8 0LT London
    Diretor
    26 Loudoun Road
    NW8 0LT London
    British14669590001
    HARGRAVE, Stephen Thomas
    47 Lambs Conduit Street
    WC1N 3NG London
    Diretor
    47 Lambs Conduit Street
    WC1N 3NG London
    EnglandBritish60918490001
    HOLMES, John Edwin
    45 Linden Road Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    Diretor
    45 Linden Road Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    British42461820001
    HUNTER, Nicholas James
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    Diretor
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    EnglandBritish94273950001
    JOHNSON, Luke Oliver
    28 Monmouth Road
    W2 4UT London
    Diretor
    28 Monmouth Road
    W2 4UT London
    British56699270001
    KLEIN, Albert Kenngott
    C/0 Imagelinx Uk Ltd
    Julias Way Station Park
    NG17 5HN Lowmoor Road Kirkby In Ashfield
    Nottinghamshire
    Diretor
    C/0 Imagelinx Uk Ltd
    Julias Way Station Park
    NG17 5HN Lowmoor Road Kirkby In Ashfield
    Nottinghamshire
    GermanyGerman69826640001
    LEHRER, Abraham Mayir
    13 Haslemere Gardens
    N3 3EA London
    Diretor
    13 Haslemere Gardens
    N3 3EA London
    British10008800001
    LEWINSOHN, Max Robert
    Tanyard Manor
    Horsted Lane
    RH19 4HY Sharpthorne
    Sussex
    Diretor
    Tanyard Manor
    Horsted Lane
    RH19 4HY Sharpthorne
    Sussex
    United KingdomBritish17400002
    MOWINCKEL, John Crostarosa, Mr.
    Flat 9 30 Bramham Gardens
    SW5 0HE London
    Diretor
    Flat 9 30 Bramham Gardens
    SW5 0HE London
    United KingdomAmerican42840430001
    NAPOLEON, Edward
    929 N Astor 1502
    Milwaukee Wi
    53202
    Usa
    Diretor
    929 N Astor 1502
    Milwaukee Wi
    53202
    Usa
    American50486960002
    ODELL, Frank William
    7 Ham Farm Road
    Ham Common
    TW10 5ND Richmond
    Surrey
    Diretor
    7 Ham Farm Road
    Ham Common
    TW10 5ND Richmond
    Surrey
    British2081870001
    ORR, David Alexander, Sir
    Home Farm House
    Shackleford
    GU8 6AH Godalming
    Surrey
    Diretor
    Home Farm House
    Shackleford
    GU8 6AH Godalming
    Surrey
    British38973090001
    OURY, Richard Anthony
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    Diretor
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    EnglandBritish29821230002
    PAUL, Swraj, Dr
    Caparo House 103 Baker Street
    W1M 1FD London
    Diretor
    Caparo House 103 Baker Street
    W1M 1FD London
    British40016170001
    PERLOFF, Andrew Stewart
    Friars Mead Barnet Lane
    Elstree
    WD6 3RA Borehamwood
    Hertfordshire
    Diretor
    Friars Mead Barnet Lane
    Elstree
    WD6 3RA Borehamwood
    Hertfordshire
    EnglandBritish1474150001
    ROGERS, Douglas Ernest
    46 Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    Diretor
    46 Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    British32445690002
    STEVENSON, Samuel
    149 Pavilion Road
    SW1X 0BJ London
    Diretor
    149 Pavilion Road
    SW1X 0BJ London
    British2506760001

    LTG GATESHEAD GROUP PLC possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Supplemental deed between the company (1) crabtree holdings (us) limited (2) crabtree holdings limited (3) crabtree of gateshead limited (4) and landesbank baden-wurttenberg (the bank) (2)
    Criado em 12/07/1999
    Entregue em 02/08/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    (A) the secured parties have made available to the companies a loan facility of up to dem 19,800,000 on the terms set out in a facility agreement (the" crabtree facilities agreement") dated 11 november 1998 made between the companies as borrower (1) ltg technologies PLC as guarantor (2) and the chargee (3) for the purpose of refinancing existing loan facilities of the companies.(b) the obligations of the companies to the secured parties under or pursuant to inter alia the crabtree facilities agreement are secured by a composite guarantee and debenture dated 15 december 1998
    Breve descrição
    Pursuant to the supplemental deed the debenture has been amended so that schedule 2 (properties),schedule 3 (fixed plant and machinery) and schedule 4 (intellectual property rights) to the debenture are deleted in their entirety and replaced by the respective schedules set out in annexure a of the supplemental deed. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Landesbank Baden-Wurttenberg (The Successor Entity Following the Merger on 1 January 1999 of Landesgirokasse Offentliche Bank Und Landessparkasse,Sudwestdeutsche Landesbank Girozentrale and Landeskreditbank Baden Wurttenberg)
    Transações
    • 02/08/1999Registro de uma garantia (395)
    • 21/12/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture between crabtree group PLC (1), crabtree holdings (us) limited (2), crabtree holdings limited (3), crabtree of gateshead limited (4) and landesgirokasse offentliche bank und landessparkasse (the "chargee")(5)
    Criado em 15/12/1998
    Entregue em 22/12/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies obligations and liabilities from time to time due owing or incurred by the company to the chargee under or pursuant to the "secured documents" (as defined) together and each as it may from time to time be amended varied novated supplemented or replaced
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Landesgirokasse Offentliche Bank Und Landessparkasse
    Transações
    • 22/12/1998Registro de uma garantia (395)
    • 21/12/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 27/11/1995
    Entregue em 05/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 05/12/1995Registro de uma garantia (395)
    • 18/11/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Criado em 13/10/1993
    Entregue em 28/10/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge over all the deposits, together with all interest from time to time accruing thereon, details of charged deposit contract(s)-barclays bank PLC re spmerset trust PLC (now called crabtree group PLC) gts bid deposit bid number 7568760 (for full details see form 395).
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 28/10/1993Registro de uma garantia (395)
    • 19/07/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Criado em 23/07/1993
    Entregue em 12/08/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge over all the "deposit (s)", together with all interest from time to time accruing thereon. Details of charged account(s)-barclays bank PLC re crabtree group PLC, bid deposit bid no: 62011466 (for full details see from 395).
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 12/08/1993Registro de uma garantia (395)
    • 19/07/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Criado em 21/06/1993
    Entregue em 12/07/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Barclays bank PLC re somerset trust PLC gts bid deposit bid no 7568760. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 12/07/1993Registro de uma garantia (395)
    • 09/02/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0