ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED

ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaASTEC COMMUNICATIONS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02023193
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    RANGENOW LIMITED28/05/198628/05/1986

    Quais são as últimas contas de ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2019

    Quais são as últimas submissões para ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Estado do capital em 10/03/2021

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Satisfação total da garantia 7

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 9

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 8

    1 páginasMR04

    Nomeação de Mrs Janine Butler como diretor em 23/02/2021

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de David Nigel Evans como diretor em 23/02/2021

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 14/02/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Satisfação total da garantia 3

    1 páginasMR04

    Declaração de confirmação apresentada em 14/02/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 31/03/2019

    9 páginasAA

    legacy

    256 páginasPARENT_ACC

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Nomeação de Mr Andrew Michael Yorston como diretor em 02/04/2019

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Diane Josephine Mcintyre como diretor em 16/03/2019

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 14/02/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2018

    5 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 14/02/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2017

    5 páginasAA

    Quem são os diretores de ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretário
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro2357692
    75473330004
    BUTLER, Janine
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish277534960001
    YORSTON, Andrew Michael
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish257275320001
    COTTLE, Paul
    The Old Granary
    Brimpsfield
    GL4 8LD Gloucester
    Secretário
    The Old Granary
    Brimpsfield
    GL4 8LD Gloucester
    British77894160002
    EMETULU, Lola
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secretário
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British88619360002
    HODGSON, Mark
    3 Cochran Close
    Churchdown
    GL3 2NA Gloucester
    Gloucestershire
    Secretário
    3 Cochran Close
    Churchdown
    GL3 2NA Gloucester
    Gloucestershire
    British72699060001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secretário
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Secretário
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    WRIGHT, Garth Howard
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    England
    Secretário
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    England
    British130769810001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British123612980001
    BAMFORD, Peter Richard
    Lantern House
    4a Queens Gate Place
    SW7 5NT London
    Diretor
    Lantern House
    4a Queens Gate Place
    SW7 5NT London
    British54076100002
    BARR, Robert Nicolas
    Lindfield Faringdon Road
    OX14 1BD Abingdon
    Oxfordshire
    Diretor
    Lindfield Faringdon Road
    OX14 1BD Abingdon
    Oxfordshire
    UkBritish41968920003
    BEST, Pauline Ann
    Honeysuckle Cottage
    Sutton Lane Sutton
    OX29 5RU Witney
    Oxfordshire
    Diretor
    Honeysuckle Cottage
    Sutton Lane Sutton
    OX29 5RU Witney
    Oxfordshire
    British68015830001
    BISWAS, Sumit Kumar
    21 South Street
    OX2 0BE Oxford
    Oxfordshire
    Diretor
    21 South Street
    OX2 0BE Oxford
    Oxfordshire
    British63870460001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    British79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Diretor
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British83126790001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    COTTLE, Paul
    The Old Granary
    Brimpsfield
    GL4 8LD Gloucester
    Diretor
    The Old Granary
    Brimpsfield
    GL4 8LD Gloucester
    British77894160002
    EDWARDS, Peter David
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    Diretor
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    British1908570001
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish134975040001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish158146620001
    FREEMAN, William Ian Bede
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    Diretor
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish64442870001
    GENT, Christopher Charles
    Crowshott
    Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Crowshott
    Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    British50867930001
    GRAY, Ian
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Diretor
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    United KingdomBritish50246030004
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Diretor
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    British33951180005
    HARPER, Alan Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British27272400002
    HEXT, Jane Helen
    2 Saint Katherines
    Winterbourne Bassett
    SN4 9QG Swindon
    Wiltshire
    Diretor
    2 Saint Katherines
    Winterbourne Bassett
    SN4 9QG Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish152305810001
    HILLHOUSE, George Reid
    12 Churchview Drive
    Barnwood
    GL4 7ES Gloucester
    Gloucestershire
    Diretor
    12 Churchview Drive
    Barnwood
    GL4 7ES Gloucester
    Gloucestershire
    British2899430001
    HODGSON, Mark
    2 Alcotts Green
    Sandhurst
    GL2 9PE Gloucester
    Gloucestershire
    Diretor
    2 Alcotts Green
    Sandhurst
    GL2 9PE Gloucester
    Gloucestershire
    British72699060002
    KEAYS, Helen Margaret
    Clematis Cottage
    Old Warwick Road Rowington
    CV35 7AA Warwick
    Warwickshire
    Diretor
    Clematis Cottage
    Old Warwick Road Rowington
    CV35 7AA Warwick
    Warwickshire
    British55393460002
    KEY, Matthew David
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British62981720001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Diretor
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Diretor
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    MAXWELL, Ian Ronald
    Coach House Adbury Park
    Adbury
    RG15 8HB Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Coach House Adbury Park
    Adbury
    RG15 8HB Newbury
    Berkshire
    British16186890001

    Quem são as pessoas com controle significativo de ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06/04/2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridade legalUnited Kingdom (England)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro3381659
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Deed of rent deposit
    Criado em 15/07/1996
    Entregue em 16/07/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an underlease dated 15TH july 1996
    Breve descrição
    £10,868.75 or any increased sum payable into the deposit account in the name of the landlord at lloyds babk PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Ravenseft Properties Limited
    Transações
    • 16/07/1996Registro de uma garantia (395)
    • 06/03/2021Satisfação de uma garantia (MR04)
    Rent deposit deed
    Criado em 08/07/1996
    Entregue em 19/07/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £5,000 and all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of an underlease of even date
    Breve descrição
    A rent deposit of £5,000 paid under a deed dated the 8/7/96. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Ravenseft Properties Limited
    Transações
    • 19/07/1996Registro de uma garantia (395)
    • 06/03/2021Satisfação de uma garantia (MR04)
    Rent deposit deed
    Criado em 18/08/1995
    Entregue em 05/09/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 12TH july 1995 and/or this deed
    Breve descrição
    £11,163.50.
    Pessoas com direito
    • The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty
    Transações
    • 05/09/1995Registro de uma garantia (395)
    • 06/03/2021Satisfação de uma garantia (MR04)
    Charge
    Criado em 05/09/1994
    Entregue em 10/09/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All the company`s right title and interest in and to the subscriber base al book and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 10/09/1994Registro de uma garantia (395)
    • 06/11/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge
    Criado em 05/09/1994
    Entregue em 07/09/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two agreements dated 28/93 and 3/2/93 and/or this charge
    Breve descrição
    The interest of the company in its customers from time to time as well as after as before any receiver may be appointed. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Vodafone Limited
    Transações
    • 07/09/1994Registro de uma garantia (395)
    • 17/02/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 05/09/1994
    Entregue em 07/09/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Vodafone Group PLC
    Transações
    • 07/09/1994Registro de uma garantia (395)
    • 15/08/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 06/02/1991
    Entregue em 14/02/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreements and/or this charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Telecom Securicor Cellular Radiw Limited
    Transações
    • 14/02/1991Registro de uma garantia
    • 05/10/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    • 28/07/2020Satisfação de uma garantia (MR04)
    Charge
    Criado em 17/11/1986
    Entregue em 26/11/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific charge over the benefit of all leasing rental hire purchase or credit sale agreements, all bills of exchange or promissory notes, all guarantees indemnities bonds or other securities. (For full details please see form 395 ref: M173/26NOV/ln).
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 26/11/1986Registro de uma garantia
    • 06/11/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 14/10/1986
    Entregue em 22/10/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 22/10/1986Registro de uma garantia
    • 06/11/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0