MCC LEASING (NO. 6) LIMITED

MCC LEASING (NO. 6) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaMCC LEASING (NO. 6) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02030523
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    • Arrendamento financeiro (64910) / Atividades financeiras e de seguros

    Onde fica MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2014

    Qual é o status da última declaração anual para MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    9 páginas4.71

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de 1 Churchill Place London E14 5HP para Barlcays Group Archives Dallimore Road Manchester Manchester M23 9JA

    2 páginasAD02

    Endereço do domicílio registado alterado de Churchill Plaza Churchill Way Basingstoke Hampshire RG21 7GP para Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR em 20/11/2015

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    5 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    2 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 09/11/2015

    LRESSP

    Declaração anual preparada até 01/08/2015 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital13/08/2015

    Estado do capital em 13/08/2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Término da nomeação de Mohammed Akram como diretor em 13/03/2015

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 01/01/2015 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital19/01/2015

    Estado do capital em 19/01/2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2014

    23 páginasAA

    Satisfação total da garantia 1

    6 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 2

    6 páginasMR04

    Declaração anual preparada até 01/01/2014 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital06/01/2014

    Estado do capital em 06/01/2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomeação de Gavin John Simpson como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Duncan Rowberry como diretor

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2013

    25 páginasAA

    Declaração anual preparada até 01/01/2013 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2012

    25 páginasAA

    Nomeação de Mohammed Akram como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Thomas Geoffrey Ridout como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 01/01/2012 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2011

    27 páginasAA

    Término da nomeação de Darren Hare como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 01/01/2011 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Quem são os diretores de MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Secretário
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    LEATHER, Jonathan Terence
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish69140360004
    SIMPSON, Gavin John
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish149333050001
    RUFFELL, Lara Catherine
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    Secretário
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    British69140140002
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Secretário
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    AKRAM, Mohammed
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish169142800001
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Diretor
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Diretor
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Diretor
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Diretor
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    British5529800001
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Diretor
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Diretor
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    HARE, Darren Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish147858890001
    LEWIS, Barry Randall
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    Diretor
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish145163830001
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Diretor
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    British25737780001
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British68601920003
    MILLINER, Craig
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    Diretor
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    British144700710001
    RIDOUT, Thomas Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish155056490001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Diretor
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish49237880004
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Diretor
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    British32895910001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    6 Abbotsmead Place
    Caversham
    RG4 8BB Reading
    Reading
    Diretor
    6 Abbotsmead Place
    Caversham
    RG4 8BB Reading
    Reading
    British71785600001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Diretor
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Diretor
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Diretor
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    BAROMETERS LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Diretor
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    57357300002

    MCC LEASING (NO. 6) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Sub lease security agreement
    Criado em 30/12/1992
    Entregue em 14/01/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For securing the performance of certain covenants due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sublease dated 24/11/92 and from the company under the terms of the head lease dated 24/11/92
    Breve descrição
    All the grantor's right title and interest as lessee in the head lease and as secured party in the head security agreement (see form 395 for full details).
    Pessoas com direito
    • Triborough Bridge and Tunnel Authority
    Transações
    • 14/01/1993Registro de uma garantia (395)
    • 25/09/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Secondary lease security assignment
    Criado em 30/12/1992
    Entregue em 13/01/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from i/s mardron and/or tarben J.B.olesen to the chargee under the terms of the loan agreement dated 30/12/92
    Breve descrição
    All the right title and interest in and to the assigned payments and sums paid or payable in respect thereof (see form 395 for full details).
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 13/01/1993Registro de uma garantia (395)
    • 15/09/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    First priority statutory mortgage
    Criado em 30/06/1987
    Entregue em 13/07/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or svenska handelsbanten and/or barclays bank PLC acting as agent for itself pursuant to a guarantee facility agreement dated 30/7/87
    Breve descrição
    32/64TH shares in the M.V. "st. Nicholas" registered at the port of london under official no 703472 and in her boats and appurtenances.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC and/or Svenska Handelsbanken and/or Barclays Bank PLC Actingas Agent
    Transações
    • 13/07/1987Registro de uma garantia
    • 24/04/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of covenants
    Criado em 30/06/1987
    Entregue em 13/07/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent for itself and svenska handelsbanken pursuant to a guarantees facility agreement dated 30 june 1987 and this deed.
    Breve descrição
    All the right title & interest in the vessel M.V. "st nicholas" registered at the part of london official no. 703472 and all boats machinery etc. (see doc M86/14 jul/cf for full details).
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 13/07/1987Registro de uma garantia
    • 24/04/2014Satisfação de uma garantia (MR04)

    MCC LEASING (NO. 6) LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    09/11/2015Início da liquidação
    07/07/2016Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Profissional
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profissional
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0