COFFEE POINT LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCOFFEE POINT LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02037135
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de COFFEE POINT LIMITED?

    • Outros serviços de alimentação (56290) / Alojamento, restauração e similares

    Onde fica COFFEE POINT LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    East Wing 14th Floor
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de COFFEE POINT LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CRAYGLOW LIMITED15/07/198615/07/1986

    Quais são as últimas contas de COFFEE POINT LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/03/2014

    Qual é o status da última declaração anual para COFFEE POINT LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para COFFEE POINT LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    6 páginas4.71

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 03/03/2015

    LRESSP

    Declaração anual preparada até 24/01/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital20/02/2015

    Estado do capital em 20/02/2015

    • Capital: GBP 100,941
    SH01

    Nomeação de Mr Kris Paul Ludo Geysels como diretor em 18/12/2014

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Brian Mackie como diretor em 18/12/2014

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/03/2014

    7 páginasAA

    Declaração anual preparada até 24/01/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital04/02/2014

    Estado do capital em 04/02/2014

    • Capital: GBP 100,941
    SH01

    Nomeação de Mr Daniel Henry Abrahams como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Helen Willis como diretor

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Brian Mackie em 01/05/2013

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2013

    7 páginasAA

    Declaração anual preparada até 24/01/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada

    1 páginasAD03

    Término da nomeação de War Tin como secretário

    1 páginasTM02

    O endereço de inspeção do registo foi alterado

    1 páginasAD02

    Término da nomeação de War Tin como secretário

    1 páginasTM02

    second-filing-of-form-with-form-type

    5 páginasRP04
    Anotações
    DataAnotação
    10/01/2013A second filed AP01 was registered for Helen Willis

    second-filing-of-form-with-form-type

    4 páginasRP04
    Anotações
    DataAnotação
    07/01/2013Second filed TM01 for Timothy Roe

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 01/04/2012

    7 páginasAA

    Nomeação de Mrs War War Tin como secretário

    1 páginasAP03

    Término da nomeação de Michael Greenwood como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Mrs Helen Margaret Willis como diretor

    3 páginasAP01
    Anotações
    DataAnotação
    10/01/2013A second filed AP01 was registered on the 10 January 2012

    Quem são os diretores de COFFEE POINT LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ABRAHAMS, Daniel Henry
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Diretor
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    EnglandBritish183822370001
    GEYSELS, Kris Paul Ludo
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Diretor
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    BelgiumBelgian193655140001
    COOK, Josephine Isabel
    White House
    Clinton Lane
    TN8 7PP Bough Beech
    Secretário
    White House
    Clinton Lane
    TN8 7PP Bough Beech
    British66475960002
    GREENWOOD, Michael Frank
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Secretário
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    British163171710001
    HUSSEY, Paul Nicholas
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    Secretário
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    British28010290009
    TIN, War War
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Secretário
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    174470180001
    BROTHERWOOD, Tony James
    54 Frampton Grove
    Westcroft Park
    MK4 4GE Milton Keynes
    Diretor
    54 Frampton Grove
    Westcroft Park
    MK4 4GE Milton Keynes
    EnglandBritish143546010001
    CUNNINGHAM, James Alan
    115 Broomwood Road
    SW11 6JU London
    Diretor
    115 Broomwood Road
    SW11 6JU London
    EnglandBritish51864840002
    DEMBITZ, John Andrew
    10 Crescent Road
    SW20 8EX London
    Diretor
    10 Crescent Road
    SW20 8EX London
    British15837270001
    DEMBITZ, John Andrew
    10 Crescent Road
    SW20 8EX London
    Diretor
    10 Crescent Road
    SW20 8EX London
    British15837270001
    DOBBS, Neil Stoker
    17 Elvaston Place
    SW7 5QF London
    Diretor
    17 Elvaston Place
    SW7 5QF London
    United KingdomBritish20511010001
    DRYSDALE, Harold Bruce
    6 Windsor Park
    NE28 8UQ Wallsend
    Tyne & Wear
    Diretor
    6 Windsor Park
    NE28 8UQ Wallsend
    Tyne & Wear
    British111822640001
    DRYSDALE, Harold Bruce
    Field House
    Eachwick
    NE18 0AY Newcastle
    Diretor
    Field House
    Eachwick
    NE18 0AY Newcastle
    United KingdomBritish106272340001
    HUGHES, Leonard
    50 St Margarets Street
    ME1 1TU Rochester
    Kent
    Diretor
    50 St Margarets Street
    ME1 1TU Rochester
    Kent
    British52234370002
    HUSSEY, Paul Nicholas
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    Diretor
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    EnglandBritish28010290009
    LEWIS, Gary Kenneth
    89 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    Diretor
    89 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    United KingdomBritish65266510002
    MACKIE, Brian
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Diretor
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    ScotlandBritish173446760002
    MOONEY, Andrew John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Diretor
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritish34345860002
    MURRELL, Andrew John
    5 Wood Ride
    BR5 1PZ Petts Wood
    Kent
    Diretor
    5 Wood Ride
    BR5 1PZ Petts Wood
    Kent
    EnglandBritish114514100001
    NAISMITH, Nicholas John Ewen
    Grants
    Grants Lane
    RH8 0RQ Limpsfield
    Surrey
    Diretor
    Grants
    Grants Lane
    RH8 0RQ Limpsfield
    Surrey
    British2892470011
    NEWBERRY, Charles Timothy
    56 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    Diretor
    56 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    EnglandEnglish29754260005
    PRATT, Isabelle
    1 Vicarage Close
    Colgate
    RH12 4BB Horsham
    West Sussex
    Diretor
    1 Vicarage Close
    Colgate
    RH12 4BB Horsham
    West Sussex
    French103007770001
    PRATT, Isabelle
    1 Vicarage Close
    Colgate
    RH12 4BB Horsham
    West Sussex
    Diretor
    1 Vicarage Close
    Colgate
    RH12 4BB Horsham
    West Sussex
    French103007770001
    ROE, Timothy Michael
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Diretor
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    EnglandBritish51264250001
    STRINGFELLOW, Robin John
    23a The Street
    Corton
    NR32 5HW Lowestoft
    Suffolk
    Diretor
    23a The Street
    Corton
    NR32 5HW Lowestoft
    Suffolk
    British113787560001
    THOMPSON, Peter Charles Fenton
    Long Dawkhams Station Road
    Woldingham
    CR3 7DE Caterham
    Surrey
    Diretor
    Long Dawkhams Station Road
    Woldingham
    CR3 7DE Caterham
    Surrey
    British19655110001
    THOMPSON, Peter Charles Fenton
    Long Dawkhams Station Road
    Woldingham
    CR3 7DE Caterham
    Surrey
    Diretor
    Long Dawkhams Station Road
    Woldingham
    CR3 7DE Caterham
    Surrey
    British19655110001
    TRACE, Charles Lawrence
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Diretor
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish129244340001
    TRACE, Charles Lawrence
    Sands Lane
    Small Dole
    BN5 9YL Henfield
    Ashleigh House
    West Sussex
    Diretor
    Sands Lane
    Small Dole
    BN5 9YL Henfield
    Ashleigh House
    West Sussex
    EnglandBritish129244340001
    WHITELING, Mark Argent
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Diretor
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    EnglandBritish101297630001
    WILLIS, Helen Margaret
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Diretor
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    United KingdomBritish277089380001

    COFFEE POINT LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Master assignment
    Criado em 16/11/2005
    Entregue em 29/11/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All monies due and the benefit of all guarantees, indemnities, negotiable instruments and securities in connection with the assigned agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Universal Leasing Limited
    Transações
    • 29/11/2005Registro de uma garantia (395)
    • 26/08/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Charge over shares
    Criado em 05/03/2004
    Entregue em 12/03/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The shares and security assets and includes any proceeds of sale or other realisation thereof or any part thereof, shares 14,940 ordinary shares in the share capital of sk automatics limited (no. 1394004).
    Pessoas com direito
    • Aib Group (UK) PLC
    Transações
    • 12/03/2004Registro de uma garantia (395)
    • 27/09/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over shares
    Criado em 11/02/2003
    Entregue em 19/02/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The shares and security assets and any proceeds of sale or other realisation thereof and all stocks,securities,rights,money or other property and bonus,dividend and interest accruing thereon.
    Pessoas com direito
    • Aib Group (UK) PLC
    Transações
    • 19/02/2003Registro de uma garantia (395)
    • 27/09/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 11/02/2003
    Entregue em 14/02/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • 3I Group PLC
    Transações
    • 14/02/2003Registro de uma garantia (395)
    • 02/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 11/02/2003
    Entregue em 13/02/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transações
    • 13/02/2003Registro de uma garantia (395)
    • 27/09/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 04/01/2002
    Entregue em 08/01/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Aib Group (UK) PLC
    Transações
    • 08/01/2002Registro de uma garantia (395)
    • 27/09/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 24 june 1991 issued by the company
    Criado em 26/06/2000
    Entregue em 30/06/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    Breve descrição
    By way of fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a factoring invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 4 may 1995 between confidential invoice discounting limited and the company and any deed amending or replacing the same (all such deeds being hereinafter called the charged deeds) and all book debts and other debts the subject of the charged deeds as and when the same shall become due or owing to the company upon re-vesting in the company whether pursuant to the charged deeds or otherwise.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 30/06/2000Registro de uma garantia (395)
    • 15/08/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 22/09/1999
    Entregue em 30/09/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transações
    • 30/09/1999Registro de uma garantia (395)
    • 27/09/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 24/06/1991
    Entregue em 03/07/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    (See form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 03/07/1991Registro de uma garantia
    • 10/07/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Single debenture
    Criado em 10/11/1988
    Entregue em 17/11/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 17/11/1988Registro de uma garantia
    • 09/08/1991Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    • 09/08/1991Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    COFFEE POINT LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    03/03/2015Início da liquidação
    22/03/2016Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profissional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profissional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0