RUBY DCO TEN LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaRUBY DCO TEN LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02040018
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de RUBY DCO TEN LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica RUBY DCO TEN LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Office 5, International House
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de RUBY DCO TEN LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    MEDIMART LIMITED23/07/198623/07/1986

    Quais são as últimas contas de RUBY DCO TEN LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2022

    Quais são as últimas submissões para RUBY DCO TEN LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Cessação de Admenta Holdings Limited como pessoa com controlo significativo em 31/08/2023

    1 páginasPSC07

    Notificação de Dunamis Mind Accelerator Limited como pessoa com controlo significativo em 31/08/2023

    2 páginasPSC02

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Re: change of name / company shall be entitled to appoint a sole director / such director shall have the authority to exercise all powers and discretions of the directors confered by the articles 31/08/2023
    RES13
    incorporation

    Resolução de alteração dos estatutos

    RES01

    Nomeação de Thorsten Sprank como diretor em 31/08/2023

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Graham Wiseman como diretor em 31/08/2023

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Dominik Muser como diretor em 31/08/2023

    1 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de Sapphire Court Walsgrave Triangle Coventry CV2 2TX para Office 5, International House Cray Avenue Orpington BR5 3RS em 04/09/2023

    1 páginasAD01

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed medimart LIMITED\certificate issued on 04/09/23
    3 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name04/09/2023

    Alteração do nome" por resolução

    NM01
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 29/08/2023

    • Capital: GBP 630,001
    3 páginasSH01

    Estado do capital em 29/08/2023

    • Capital: GBP 0.0001
    5 páginasSH19

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancel share premium 29/08/2023
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Nomeação de Mr Dominik Muser como diretor em 06/07/2023

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 25/01/2023 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2022

    3 páginasAA

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10
    capital

    Resoluções

    Re-removal of restriction on authorised shares capital 07/09/2022
    RES13
    capital

    Resolução de alteração dos direitos ou da designação das ações

    RES12
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Memorando e estatutos

    33 páginasMA

    Alteração do nome ou designação da classe de ações

    2 páginasSH08

    Detalhes da variação dos direitos vinculados às ações

    2 páginasSH10

    Término da nomeação de Wendy Margaret Hall como diretor em 09/09/2022

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Nichola Louise Legg como secretário em 09/09/2022

    1 páginasTM02

    Quem são os diretores de RUBY DCO TEN LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SPRANK, Thorsten
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Diretor
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    EnglandGerman203900280002
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secretário
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Secretário
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Secretário
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    LEGG, Nichola Louise
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Secretário
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    163214890001
    MURPHY, Francis Joseph
    Oakmere Murieston Road
    WA15 9SU Hale
    Cheshire
    Secretário
    Oakmere Murieston Road
    WA15 9SU Hale
    Cheshire
    British32866430003
    ROCHE, Colleen Elisabeth
    Whin View Woodacre Crescent
    Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    Whin View Woodacre Crescent
    Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    British35456530001
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Secretário
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    TWAROWSKI, Maria Elizabeth
    11 Spinners Chase
    Pudsey
    LS28 7BB Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    11 Spinners Chase
    Pudsey
    LS28 7BB Leeds
    West Yorkshire
    British47378310001
    BARCLAY, Raymond Dunbar
    23 Cheviot Close
    Wash Common
    RG14 6SQ Newbury
    Berkshire
    Diretor
    23 Cheviot Close
    Wash Common
    RG14 6SQ Newbury
    Berkshire
    British44192900001
    BEER, Thorsten
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Diretor
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGerman172030260001
    BURGAN, Lynne Frances
    Fulwood House Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    Fulwood House Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish3311690001
    BURGAN, Philip John
    Fulwood House Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    Fulwood House Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish2140090001
    ENGLAND, Philip Nicholas
    5 Park Avenue
    Peper Harrow Park
    GU8 6BA Godalming
    Surrey
    Diretor
    5 Park Avenue
    Peper Harrow Park
    GU8 6BA Godalming
    Surrey
    British43835770003
    HALL, Wendy Margaret
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Diretor
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    EnglandBritish172979860001
    HILGER, Marcus
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Diretor
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    GermanyGerman238936580003
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Diretor
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    British39644740002
    KEEN, Christian
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Diretor
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    EnglandBritish54544790004
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Diretor
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritish8991780003
    LIPP, Hanns Martin
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Diretor
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGerman220582440001
    MAJOR, Michael Evelyn
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    Diretor
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    British31230890001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Diretor
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Swiss43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Diretor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Germany62107000001
    MUSER, Dominik
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Diretor
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    GermanyGerman295759150001
    PRIDMORE, Richard
    62 Tinshill Road
    Cookridge
    LS16 7DS Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    62 Tinshill Road
    Cookridge
    LS16 7DS Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish39535850001
    ROCHE, Colleen Elisabeth
    Whin View Woodacre Crescent
    Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    Whin View Woodacre Crescent
    Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    British35456530001
    ROCHE, Patrick Joseph
    Penny Gate
    Swindon Lane Kirkby Overblow
    HG3 1HH Harrogate
    North Yorkshire
    Diretor
    Penny Gate
    Swindon Lane Kirkby Overblow
    HG3 1HH Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish126410600001
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Diretor
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Diretor
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    STEWART, Brian
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    Diretor
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritish980530001
    VIZARD, Ronald Charles, Harold
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Diretor
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    British122881190001
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Diretor
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish120451550002
    WISEMAN, Graham
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Diretor
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    EnglandBritish299860960001

    Quem são as pessoas com controle significativo de RUBY DCO TEN LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Dunamis Mind Accelerator Limited
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    31/08/2023
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    06/04/2016
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Sim
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroGreat Britain
    Autoridade legalCompanies Act 1985
    Local de registroCompanies House
    Número de registro244282
    Natureza do controle
    • A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, influência ou controle significativo sobre as atividades de uma firma que, segundo a lei que a regula, não é uma pessoa jurídica; e os membros dessa firma (na sua qualidade como tal) detêm, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    RUBY DCO TEN LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Legal mortgage
    Criado em 17/10/1994
    Entregue em 18/10/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H-goldwick pharmacy glodwick health centre goldwick road, oldham including all guarantees and covenats now or in the future subsisting in respect of the property and the benefit of all insurance policies all moneys and proceeds paid or payable inrespect of the property.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited
    Transações
    • 18/10/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 29/07/1994
    Entregue em 30/07/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage
    Breve descrição
    F/H-459 great horton road bradford west yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited
    Transações
    • 30/07/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 13/06/1994
    Entregue em 18/06/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    First charge on all stock shares bonds and securities of any kind whatsoever including all dividends interest or other distributions in respect of the same and all allotments. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transações
    • 18/06/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 13/06/1994
    Entregue em 18/06/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage
    Breve descrição
    L/H-ground floor premises 280-282 lees road oldham lancs. Floating charge over all tha moveable plant machinery equipment stock-in-trade implements utensils building materials and furniture.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transações
    • 18/06/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 05/05/1994
    Entregue em 25/05/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H-34 nostell place bessacarr doncaster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transações
    • 25/05/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 05/05/1994
    Entregue em 25/05/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H-the pharmacy sinclair house woodside view the crescent woodlands doncster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transações
    • 25/05/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 05/05/1994
    Entregue em 25/05/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H-2 princess street woodlands doncaster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transações
    • 25/05/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 05/05/1994
    Entregue em 25/05/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H- the pharmacy land and buildings on the east side of adwick road mexborough doncaster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transações
    • 25/05/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 05/05/1994
    Entregue em 20/05/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H-6 york bar york road doncaster. All moveable plant machinery equipment stock-in-trade implements utensils building materials and furniture.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transações
    • 20/05/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 03/05/1994
    Entregue em 09/05/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H-the pharmacy new street dinnington rotherham south yorkshire. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited
    Transações
    • 09/05/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 04/03/1994
    Entregue em 14/03/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H-pharmacy at the new health centre cluntergate horbury wakefield west yorkshire t/n-WYK542628, WTK459121 and WYK55116 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 14/03/1994Registro de uma garantia (395)
    • 04/03/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 28/02/1994
    Entregue em 04/03/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan and/or this charge
    Breve descrição
    First fixed charge on all stocks shares bonds and securities of any kind whatsoever including all dividends interest or other distributions paid or payable or made in respect of the same and allotments accreations offers rights benefits and advantages on all stocks shares rights money or property accruing or offered at any time by way of conversion redemption bonus preference option or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transações
    • 04/03/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 31/01/1994
    Entregue em 01/02/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan and/or this mortgage
    Breve descrição
    L/H-48 cheapside barnsley south yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited
    Transações
    • 01/02/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 24/01/1994
    Entregue em 26/01/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan and/or under the terms of the debenture and security
    Breve descrição
    L/H-3A far lane wadsley and land on the south side of wadsley lane and land on the N.E. of far lane sheffield t/n-SYK210526 and SYK313104. All moveable plant machinery equipment stock-in-trade implements utensils building materials and furniture by way of floating charge.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited
    Transações
    • 26/01/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 13/12/1993
    Entregue em 18/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or aah pharmaceuticals limited to the chargee under the terms of a loan and/or this mortgage
    Breve descrição
    L/H-the pharmacy minden centre st.johns garden the rock bury t/n-GM633326. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Statim Finanace Limited
    Transações
    • 18/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 13/12/1993
    Entregue em 18/12/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or aah pharmaceuticals limited to the chargee under the terms of a loan and/or this charge
    Breve descrição
    L/H-unit 3 ribblesdale house market street bury t/n-GM512146. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Statim Finanace Limited
    Transações
    • 18/12/1993Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 06/09/1993
    Entregue em 14/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee
    Breve descrição
    F/H-86 burgoyne road sheffield t/n-SYK113360. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties
    Transações
    • 14/09/1993Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 05/07/1993
    Entregue em 07/07/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal mortgage
    Breve descrição
    L/H-13 halifax road dewsbury west yorkshire and stock-in-trade. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transações
    • 07/07/1993Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 01/06/1993
    Entregue em 07/06/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H-50-52 high street idle bradford west yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transações
    • 07/06/1993Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 01/04/1993
    Entregue em 06/04/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H-property hereinafter described and the proceeds of sale thereof together with a at any time placed upon or used in or about the property and an assignment of the goodwill and connection of any business or businesses from time to time carried on in or upon the property or any part or parts thereof together with the full benefit of all licences including any registrations viz: 21 and 21A chapeltown pudsey leeds west yorkshire t/n-WYK24687. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 06/04/1993Registro de uma garantia (395)
    • 04/03/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 01/03/1993
    Entregue em 08/03/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    (For full details see form 395 and contd sheets attached). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited
    Transações
    • 08/03/1993Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 01/02/1993
    Entregue em 04/02/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited
    Transações
    • 04/02/1993Registro de uma garantia (395)
    • 07/11/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 22/09/1992
    Entregue em 07/10/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H-26 main street garforth leeds west yorshire (see form 395 for full details).
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited
    Transações
    • 07/10/1992Registro de uma garantia (395)
    • 22/06/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 01/06/1992
    Entregue em 05/06/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited
    Transações
    • 05/06/1992Registro de uma garantia (395)
    • 25/08/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 13/04/1992
    Entregue em 22/04/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    (For full details of property see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Statim Finance Limited
    Transações
    • 22/04/1992Registro de uma garantia (395)
    • 25/08/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0