HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 02084578 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
- desenvolvimento de projetos de construção (41100) / Construção
Onde fica HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 8 Canada Square London E14 5HQ |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| CHARTERHOUSE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | 01/06/1992 | 01/06/1992 |
| CHARTERHOUSE PROPERTY SERVICES LIMITED | 20/02/1987 | 20/02/1987 |
| BROADSTENCE LIMITED | 17/12/1986 | 17/12/1986 |
Quais são as últimas contas de HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2014 |
Qual é o status da última declaração anual para HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Declaração anual |
|
|---|
Quais são as últimas submissões para HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado do capital em 16/05/2016
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração anual preparada até 23/03/2016 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Mr Michael Connelly Anderson como diretor em 19/01/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de David John Cavanna como diretor em 31/12/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Ms Romana Lewis como secretário em 13/08/2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Hannah Elizabeth Shepherd como secretário em 13/08/2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 23/03/2015 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Hannah Elizabeth Shepherd como secretário em 05/01/2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Tony Bhambhra como secretário em 05/01/2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2013 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Tony Bhambhra como secretário em 13/08/2014 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Katherine Dean como secretário em 13/08/2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 23/03/2014 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de David John Cavanna como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2012 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Karen Lyon como secretário | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Katherine Dean como secretário | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 23/03/2013 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Quem são os diretores de HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, Romana | Secretário | Canada Square 14th Floor Canary Wharf E145HQ London, Greater London 8 England England | 200248640001 | |||||||
| ANDERSON, Michael Connelly | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 269666390001 | |||||
| COLE, Richard John | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 32663530001 | |||||
| MARLOW, Jonathan Peter | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 159417990001 | |||||
| BHAMBHRA, Tony | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 190151450001 | |||||||
| BLACK, Nicola Suzanne | Secretário | Springfield 24 Drovers Way CM23 4GF Bishops Stortford Hertfordshire | British | 52160130002 | ||||||
| DEAN, Katherine | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 177181780001 | |||||||
| JENKINSON, Louisa Jane | Secretário | Lindenwood Malacca Farm GU4 7UG West Clandon Surrey | British | 106060330003 | ||||||
| LYON, Karen | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 161199760001 | |||||||
| MILLER, Philip | Secretário | Sutton Court Fauconberg Road W4 3JF London 87 | Other | 128209650001 | ||||||
| OWEN, Stephen | Secretário | Clayton Croft Road Wilmington DA2 7AU Kent 11 United Kingdom | Other | 132334270001 | ||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 194218020001 | |||||||
| PATERNOSTER SECRETARIES LIMITED | Secretário nomeado | 1 Paternoster Row St Paul's EC4M 7DH London | 900015820001 | |||||||
| BOND, Iain Douglas | Diretor | 40 St Peters Square W6 9NR London | England | British | 68687180001 | |||||
| CAVANNA, David John | Diretor | 8 Canada Square London E14 5HQ | United Kingdom | British | 180384720001 | |||||
| DE ALBUQUERQUE, Simon Peter | Diretor | 15 Fielding Mews Barnes SW13 9EY London | England | British | 150525130001 | |||||
| DIX, Robert William | Diretor | Springfield The Ridge Woodcote Park KT18 7ET Epsom Surrey | British | 2067980005 | ||||||
| EDGCUMBE, John Charles | Diretor | 20 Charles Babbage Close KT9 2SA Chessington Surrey | British | 85343720002 | ||||||
| EVANS, Anthony John | Diretor | 55 Crown Street Redbourn AL3 7PF St Albans Hertfordshire | British | 21280530001 | ||||||
| GILL, Christopher Paul | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 43569560001 | |||||
| GLOVER, Edward Douglas | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 121380002 | |||||
| HUXTABLE, Christopher John | Diretor | The Cottage Golf Club Drive KT2 7DF Kingston Surrey | British | 50657810002 | ||||||
| IMPEY, Peter Henry | Diretor | Oak House Newick BN8 4SB Lewis East Sussex | United Kingdom | British | 88861820001 | |||||
| MACKEY, Paul Emmanuel | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 11264820014 | |||||
| MOFFAT, Andrew David John | Diretor | 6 Queen Annes Grove Ealing W5 3XR London | England | British | 34399870003 | |||||
| MOFFAT, Andrew David John | Diretor | 6 Queen Annes Grove Ealing W5 3XR London | England | British | 34399870003 | |||||
| PARISH, David William | Diretor | Michanda Spring Road Kinsbourne Green AL5 3PP Harpenden Hertfordshire | British | 2894070001 | ||||||
| RINGER, Simon David | Diretor | 115 Fawe Park Road SW15 2EG London | British | 52267810002 | ||||||
| SHORT, Jeanne Elizabeth | Diretor | Manor Cottage Speldhurst Road Langton Green TN3 0JL Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 27753070001 | |||||
| TAYLOR, Christopher Mark | Diretor | 25 Felden Street Fulham SW6 5AE London | England | British | 159396060001 | |||||
| THORP, Timothy Geoffrey | Diretor | 3 St George's Road TN13 3ND Sevenoaks Kent | England | British | 66923730003 | |||||
| THORP, Timothy Geoffrey | Diretor | 3 St George's Road TN13 3ND Sevenoaks Kent | England | British | 66923730003 | |||||
| TSOUROUS, Lucy Anna | Diretor | 87 Elgin Mansions Elgin Avenue Maida Vale W9 1JN London | British | 63852340001 | ||||||
| VON GUIONNEAU, Werner Marc Friedrich | Diretor | 33 Lansdowne Road W11 2LQ London | England | German, | 110089200001 |
HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Third party charge of deposit account | Criado em 03/04/1996 Entregue em 06/04/1996 | Pendente | Montante garantido 50 per cent of (a) any quarterly amortisation amount payable by geranium properties limited or which geranium properties limited is bound to procure be paid into the escrow deposit account on each fixed portion interest payment date and which, at any relevant time has not been paid by geranium properties limited; and (b) the annual amortisation amount payable by geranium properties limited to wurttembergische hypothekenbank aktiengesellschaft on the second anniversary of the effective date (as defined in the facility agreement) and on each anniversary thereafter and which, at any relevant time has not been paid by geranium properties limited; in each case when and as the same shall become due in accordance with the terms and conditions of the facility agreement or in the case of (b) only on occurance of an event of default as defined in the facility agreement, if earlier. | |
Breve descrição All of the right title benefit and interest of the chargor in and to all monies standing from time to time to the credit of the deposit account of the chargor with the royal bank of scotland PLC. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0