KEARS GROUP LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaKEARS GROUP LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02101165
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de KEARS GROUP LIMITED?

    • Atividades de organizações e organismos extraterritoriais (99000) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica KEARS GROUP LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de KEARS GROUP LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    RJT 62 LIMITED18/02/198718/02/1987

    Quais são as últimas contas de KEARS GROUP LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até27/09/2013

    Qual é o status da última declaração anual para KEARS GROUP LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para KEARS GROUP LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    13 páginas4.71

    Endereço do domicílio registado alterado de Greencore Group Uk Centre Midland Way Barlborough Links Business Park Barlborough Chesterfield S43 4XA para Town Wall House Balkerne Hill Colchester Essex CO3 3AD em 22/05/2015

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    9 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    2 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 27/04/2015

    LRESSP

    Declaração anual preparada até 26/03/2015 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital27/03/2015

    Estado do capital em 27/03/2015

    • Capital: GBP 218.82
    SH01

    Contas anuais preparadas até 27/09/2013

    11 páginasAA

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 05/06/2014

    • Capital: GBP 218.82
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluções

    Cancel share prem a/c 02/06/2014
    RES13

    Declaração anual preparada até 26/03/2014 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01

    Término da nomeação de Diane Walker como diretor

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 28/09/2012

    11 páginasAA

    Declaração anual preparada até 26/03/2013 com lista completa de acionistas

    9 páginasAR01

    Nomeação de Ms. Jolene Anna Gacquin como diretor

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2011

    12 páginasAA

    Declaração anual preparada até 26/03/2012 com lista completa de acionistas

    9 páginasAR01

    Término da nomeação de Patrick Coveney como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Alan Richard Williams como diretor

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 24/09/2010

    12 páginasAA

    Declaração anual preparada até 26/03/2011 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01

    Término da nomeação de William Barratt como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Ms Diane Walker como diretor

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de KEARS GROUP LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    OLEARY, Conor
    Carrigabruce
    Enniscorthy
    Ard Na Laoi
    Co Wexford
    Ireland
    Secretário
    Carrigabruce
    Enniscorthy
    Ard Na Laoi
    Co Wexford
    Ireland
    British151166570001
    EVANS, Michael
    Midland Way
    Barlborough Links Business Park
    S43 4XA Barlborough
    Uk Centre
    Chesterfield
    United Kingdom
    Diretor
    Midland Way
    Barlborough Links Business Park
    S43 4XA Barlborough
    Uk Centre
    Chesterfield
    United Kingdom
    United KingdomBritish148060720001
    GACQUIN, Jolene Anna, Ms.
    c/o Greencore Group Plc
    Northwood Avenue
    Northwood Business Park
    Santry
    No 2
    Dublin9
    Ireland
    Diretor
    c/o Greencore Group Plc
    Northwood Avenue
    Northwood Business Park
    Santry
    No 2
    Dublin9
    Ireland
    IrelandIrish176849210001
    O'LEARY, Conor
    Carrigabruce
    Enniscorthy
    Ard Na Laoi
    Co Wexford
    Ireland
    Diretor
    Carrigabruce
    Enniscorthy
    Ard Na Laoi
    Co Wexford
    Ireland
    IrelandIrish143778250002
    ODLUM, Philip Edwin
    109 Anglesea Road
    IRISH Ballisbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Diretor
    109 Anglesea Road
    IRISH Ballisbridge
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish144667960001
    WILLIAMS, Alan Richard, Mr.
    2 Northwood Avenue
    Northwood Business Park
    9 Santry
    Greencore Group Plc
    Dublin
    Ireland
    Diretor
    2 Northwood Avenue
    Northwood Business Park
    9 Santry
    Greencore Group Plc
    Dublin
    Ireland
    EnglandBritish137582690001
    BELL, David Anthony
    49 Hollybank Avenue Lower
    IRISH Rathgar
    Dublin 6
    Republic Of Ireland
    Secretário
    49 Hollybank Avenue Lower
    IRISH Rathgar
    Dublin 6
    Republic Of Ireland
    Irish89468330001
    HATCHER, Mark Jon
    Elmleigh
    Wainlode Lane
    GL2 9LN Norton
    Gloucestershire
    Secretário
    Elmleigh
    Wainlode Lane
    GL2 9LN Norton
    Gloucestershire
    British9437690002
    BARRATT, William Harrison
    3 Sycamore Close
    DN22 7JP Retford
    Nottinghamshire
    Diretor
    3 Sycamore Close
    DN22 7JP Retford
    Nottinghamshire
    EnglandBritish100531360001
    BERGIN, Caroline Margaret
    8 Holyrood Park
    Sandymount
    Dublin 4
    Dublin 4
    Republic Of Ireland
    Diretor
    8 Holyrood Park
    Sandymount
    Dublin 4
    Dublin 4
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish89332200002
    COVENEY, Patrick Francis
    6 Leinster Square
    Rathmines
    IRISH Dublin
    6
    Ireland
    Diretor
    6 Leinster Square
    Rathmines
    IRISH Dublin
    6
    Ireland
    IrelandIrish143778240001
    DILGER, David John
    Lauriston Cenacle Grove
    Killiney Hill Road
    Killiney
    Co Dublin
    Ireland
    Diretor
    Lauriston Cenacle Grove
    Killiney Hill Road
    Killiney
    Co Dublin
    Ireland
    Irish74455510001
    ELSMORE, Brenda Jean
    The Hermitage
    Staunton
    GL16 8NY Coleford
    Gloucestershire
    Diretor
    The Hermitage
    Staunton
    GL16 8NY Coleford
    Gloucestershire
    EnglandBritish27571940002
    GARAVAN, Charles
    Curragrean
    Oranmore
    IRISH Co Galway
    Republic Of Ireland
    Diretor
    Curragrean
    Oranmore
    IRISH Co Galway
    Republic Of Ireland
    Irish9725560001
    HATCHER, Mark Jon
    Elmleigh
    Wainlode Lane
    GL2 9LN Norton
    Gloucestershire
    Diretor
    Elmleigh
    Wainlode Lane
    GL2 9LN Norton
    Gloucestershire
    United KingdomBritish9437690002
    HYNES, Anthony Martin
    The Piggeries Hassop
    DE45 1NW Bakewell
    Derbyshire
    Diretor
    The Piggeries Hassop
    DE45 1NW Bakewell
    Derbyshire
    EnglandIrish100467690002
    KEAR, Harry James
    The Hollies
    Church Road Clearwell
    GL16 8QT Coleford
    Gloucestershire
    Diretor
    The Hollies
    Church Road Clearwell
    GL16 8QT Coleford
    Gloucestershire
    United KingdomBritish8126880001
    KEAR, Ronald
    Indra House Chepstow Road
    NP5 2EN Raglan
    Gwent
    Diretor
    Indra House Chepstow Road
    NP5 2EN Raglan
    Gwent
    British9319170001
    KENNEDY, Patrick Thomas
    61 Dartmouth Square
    Dublin 6
    Ireland
    Diretor
    61 Dartmouth Square
    Dublin 6
    Ireland
    Irish74455540001
    KNIGHT, Vivian Robert
    Hollymead House
    Smithers Cross
    GL17 9TT Ruardean
    Gloucestershire
    Diretor
    Hollymead House
    Smithers Cross
    GL17 9TT Ruardean
    Gloucestershire
    British27522440001
    O'SULLIVAN, Kevin Clive
    17 Elgin Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    Diretor
    17 Elgin Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    British3562130002
    ODLUM, Philip Edwin
    109 Anglesea Road
    IRISH Ballisbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Diretor
    109 Anglesea Road
    IRISH Ballisbridge
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish144667960001
    POWER, Benjamin John
    The Moorings
    Church Road
    IRISH Killiney
    County Dublin
    Ireland
    Diretor
    The Moorings
    Church Road
    IRISH Killiney
    County Dublin
    Ireland
    Irish45422850002
    SMITH, Gerard Arthur
    158 Bawtry Road
    Bassacarr
    DN4 7BT Doncaster
    South Yorkshire
    Diretor
    158 Bawtry Road
    Bassacarr
    DN4 7BT Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish111889550001
    TAYLOR, Philip John
    Orchard House
    Main Road
    WR2 6PW Ombersley
    Worcestershire
    Diretor
    Orchard House
    Main Road
    WR2 6PW Ombersley
    Worcestershire
    British105805650001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Diretor
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    British37845970003
    WALKER, Diane Susan
    Manton Wood Enterprise Park
    Retford Road
    S80 2RS Worksop
    Greencore Food To Go
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Diretor
    Manton Wood Enterprise Park
    Retford Road
    S80 2RS Worksop
    Greencore Food To Go
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish156683540001
    YEATES, Paul
    10 Belle Baulk
    NN12 6YH Towcester
    Northamptonshire
    Diretor
    10 Belle Baulk
    NN12 6YH Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritish71252220001

    KEARS GROUP LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Single debenture
    Criado em 10/11/1994
    Entregue em 28/11/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 28/11/1994Registro de uma garantia (395)
    • 29/12/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 10/11/1994
    Entregue em 28/11/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a claremont house and the bakery yorkley lydney gloucester t/no.GR151773 and all buildings fixtures and goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 28/11/1994Registro de uma garantia (395)
    • 29/12/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Collateral floating charge
    Criado em 16/01/1992
    Entregue em 20/01/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from starbake yorkshire limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Floating charge over all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • 3I Group PLC
    Transações
    • 20/01/1992Registro de uma garantia (395)
    • 22/04/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 02/05/1991
    Entregue em 03/05/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H, the bakery, rogerstone, newport, gwent title no wa 239100. assigns goodwill (if any) (see form 395 and continuation sheets relevant to this charge).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 03/05/1991Registro de uma garantia
    • 29/12/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 17/04/1989
    Entregue em 25/04/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H the bakery, rogerstone, gwent title no wa 239100 assigns goodwill (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 25/04/1989Registro de uma garantia
    • 29/12/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Single debenture
    Criado em 17/12/1987
    Entregue em 23/12/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Inc: all heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 23/12/1987Registro de uma garantia
    • 11/09/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    KEARS GROUP LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    27/04/2015Início da liquidação
    06/04/2016Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Lee De'Ath
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Profissional
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Richard Howard Toone
    Cvr Global Llp
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LB London
    Profissional
    Cvr Global Llp
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LB London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0