CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED

CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02110320
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    • Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio

    Onde fica CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    RENTCO INTERNATIONAL LIMITED25/09/198725/09/1987
    VISORHEAD LIMITED13/03/198713/03/1987

    Quais são as últimas contas de CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    VencidoSim
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em30/06/2015
    Próximas contas vencem em31/03/2016
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2014

    Quais são as últimas submissões para CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    8 páginas4.71

    Segunda apresentação para a nomeação de Neil Smith como administrador

    6 páginasRP04AP01

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 páginasAD03

    O endereço de inspeção do registo foi alterado para 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 páginasAD02

    Endereço do domicílio registado alterado de 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT para 1 More London Place London SE1 2AF em 25/04/2016

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    2 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 31/03/2016

    LRESSP

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Término da nomeação de T I P Europe Limited como diretor em 05/02/2016

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de David Cakebread como diretor em 01/02/2016

    1 páginasTM01

    Nomeação de Neil Campbell Smith como diretor em 05/02/2016

    3 páginasAP01
    Anotações
    DataAnotação
    06/10/2016Clarification A second filed AP01 was registered on 06/10/2016

    Declaração anual preparada até 31/10/2015 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital04/11/2015

    Estado do capital em 04/11/2015

    • Capital: GBP .1
    SH01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2014

    16 páginasAA

    Detalhes da variação dos direitos vinculados às ações

    2 páginasSH10

    Alteração do nome ou designação da classe de ações

    2 páginasSH08

    Subdivisão de ações em 01/12/2014

    8 páginasSH02

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01
    capital

    Resolução de alteração dos direitos ou da designação das ações

    RES12
    capital

    Resoluções

    11,000,000 issued cumulative redeemable preference shares of £1 be sub-divided into 110,000,000 cumulative redeemable preference shares of £0.10 each 01/12/2014
    RES13

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado do capital em 09/12/2014

    • Capital: GBP 0.10
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluções

    Reduction of share premium account to nil 01/12/2014
    RES13

    Declaração anual preparada até 31/10/2014 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital01/12/2014

    Estado do capital em 01/12/2014

    • Capital: GBP 356,027,000
    SH01

    Diversos

    Section 519
    3 páginasMISC

    Renúncia do auditor

    3 páginasAUD

    Quem são os diretores de CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretário
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro7038430
    146358090001
    SMITH, Neil Campbell
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Diretor
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish183029170001
    SWITHENBANK, Joseph Preston
    Rue Pillet Will
    75009 Paris
    2-4
    France
    Diretor
    Rue Pillet Will
    75009 Paris
    2-4
    France
    FranceUs Citizen183236480001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Secretário
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    PRICE, Philip Ian
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    Secretário
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    British75578650002
    SMITH, Nicholas Handran
    Flat 2
    19 Netherhall Gardens
    NW3 5RL Hampstead
    London
    Secretário
    Flat 2
    19 Netherhall Gardens
    NW3 5RL Hampstead
    London
    Australian50914130001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretário
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Secretário
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    50087010001
    BEADLE, Paul Laurence
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    Diretor
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United KingdomBritish100238650001
    CAKEBREAD, David
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    Diretor
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    United KingdomBritish183172770001
    CAMFIELD, Ronald Frederick
    Nicholas House
    14 Creekview Road
    CM3 5GU South Woodham Ferrers
    Essex
    Diretor
    Nicholas House
    14 Creekview Road
    CM3 5GU South Woodham Ferrers
    Essex
    British81395090001
    CHANDLER, Andrew Philip
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    Diretor
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    British53832740001
    CITRON, Zachary Joseph
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    Diretor
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    British91783950001
    CLARK, Roy Graham
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    Diretor
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    British65257100001
    CLUBB, Ian Mcmaster
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    Diretor
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    British3485960001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Diretor
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    EnglandBritish61314280001
    FOSTER, Roy Garvin
    16 Thameside
    RG9 1BH Henley On Thames
    Oxfordshire
    Diretor
    16 Thameside
    RG9 1BH Henley On Thames
    Oxfordshire
    British37099790001
    GOODWIN, Eric
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    Diretor
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    EnglandBritish45623310001
    GOODWIN, Stephen Keith
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    Diretor
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    British5343520001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Diretor
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Diretor
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish109591300001
    IRVING, Ian Richard
    3 Warrington Crescent
    Little Venice
    W9 1ED London
    Diretor
    3 Warrington Crescent
    Little Venice
    W9 1ED London
    EnglandBritish41228040001
    MATTHEWS, Terence
    Flat 6
    Fleming House 20 Danvers Street Chel
    SW3 London
    Diretor
    Flat 6
    Fleming House 20 Danvers Street Chel
    SW3 London
    British31419450002
    MONTAGUE, Robert Joel
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    Diretor
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    British65130630002
    OSBORNE, Richard Wallace Gollin Osborne
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Diretor
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Australian17452320001
    PALMER, Christopher Antony
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    British4764800001
    RAINE, Richard Denby
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    Diretor
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    British50519950001
    RIEDIJK, Hans Arie
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Diretor
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Dutch57483360001
    SMITS, Robert Anthony
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Diretor
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Dutch54592350001
    STONE, Richard
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    Diretor
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    British75179060001
    THRASHER III, Barrie Holt
    Flat 10
    25 Queensgate Gardens
    SW7 5RR London
    Diretor
    Flat 10
    25 Queensgate Gardens
    SW7 5RR London
    American65472750001
    WILSON, Peter Samuel
    5 Thorn Close
    RG11 4SQ Wokingham
    Berkshire
    Diretor
    5 Thorn Close
    RG11 4SQ Wokingham
    Berkshire
    British59565220001
    T I P EUROPE LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Diretor
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    65164760003

    CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 26/07/1996
    Entregue em 30/07/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.as Security Trustee for the Secured Parties
    Transações
    • 30/07/1996Registro de uma garantia (395)
    • 03/05/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Account charge
    Criado em 15/03/1994
    Entregue em 23/03/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to an indemnity contained in a sale agreement dated 14TH december 1989 and this deed (as defined therein)
    Breve descrição
    All right title and interest of the company in and to both of the company's accounts no: 76653161 and 7943407. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC Barclays Mercantile Limited and Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transações
    • 23/03/1994Registro de uma garantia (395)
    • 04/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 15/03/1994
    Entregue em 21/03/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a credit agreement dated 13TH february 1994 as amended on 15TH february 1994 and an agreement dated 15TH march 1994 (as defined) and any other related security documents
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.("the Security Trustee")as Security Trustee for Itself and for the Secured Parties (As Defined in the Debenture)
    Transações
    • 21/03/1994Registro de uma garantia (395)
    • 05/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 18/05/1987
    Entregue em 26/05/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as agent and trustee for the banks and/ohe overdraft bank as defined in the deed
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Bank and Overdraft Bank
    Transações
    • 26/05/1987Registro de uma garantia
    • 10/12/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 18/05/1987
    Entregue em 26/05/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever agent and turstee for the banks and/or the overdroft bank as defired in the deed
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Banks and the Overdraft Bank
    Transações
    • 26/05/1987Registro de uma garantia
    • 10/12/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    31/03/2016Início da liquidação
    16/04/2017Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profissional
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profissional
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0