LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED

LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaLE PAIN CROUSTILLANT LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02116902
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    • Fabricação de pão; fabricação de produtos frescos de pastelaria e bolos (10710) / Indústrias transformadoras

    Onde fica LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    PINGATE CATERING LIMITED30/03/198730/03/1987

    Quais são as últimas contas de LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2011

    Quais são as últimas submissões para LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 15/09/2012 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital26/09/2012

    Estado do capital em 26/09/2012

    • Capital: GBP 1,248
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011

    7 páginasAA

    Nomeação de Emmett Mcevoy como diretor em 20/04/2012

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Antony David Smith como diretor em 20/04/2012

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Andrew Mcdonald como diretor em 15/11/2011

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Suzanne Elizabeth Wise como diretor em 15/11/2011

    1 páginasTM01

    Resoluções

    Resolutions
    34 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10

    Declaração dos objetos da sociedade

    2 páginasCC04

    Aviso de remoção da restrição sobre os estatutos da sociedade

    2 páginasCC02

    Declaração anual preparada até 15/09/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Declaração anual preparada até 01/07/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Ms Suzanne Elizabeth Wise em 01/07/2011

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Mr Simon Nicholas Wilbraham em 01/07/2011

    1 páginasCH03

    Detalhes do diretor alterados para Mr Andrew Michael Peeler em 01/07/2011

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2010

    7 páginasAA

    Nomeação de Mr Antony David Smith como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Andrew Peeler como diretor

    2 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 15/10/2010 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Nomeação de Mr Simon Nicholas Wilbraham como diretor

    2 páginasAP01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2009

    7 páginasAA

    Declaração anual preparada até 12/11/2009 com lista completa de acionistas

    11 páginasAR01

    Término da nomeação de Robert Lawson como diretor

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Secretário
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    MCDONALD, Andrew John
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Diretor
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritishGeneral Counsel & Company Secretary164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrishDirector168590540001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary125719290002
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretário
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    Secretário
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Secretário
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    HOLLOWAY, David John
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    Secretário
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    BritishGroup Finance Director66183100001
    VANBERGEN, Charles Albert
    The White Cottage Childsbridge Lane
    Seal
    TN15 0BS Sevenoaks
    Kent
    Secretário
    The White Cottage Childsbridge Lane
    Seal
    TN15 0BS Sevenoaks
    Kent
    British7384900001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secretário
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Secretário
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Diretor
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    BritishFinance Director Chartered Acc73003300001
    BARRY, Peter Nigel George
    Hall Farmhouse
    The Street
    NR16 1EZ Ashwellthorpe
    Norfolk
    Diretor
    Hall Farmhouse
    The Street
    NR16 1EZ Ashwellthorpe
    Norfolk
    EnglandBritishDirector84886660001
    CARTER, Ian Paul
    2 Hedley Gardens
    Hedge End
    SO30 2WT Southampton
    Hampshire
    Diretor
    2 Hedley Gardens
    Hedge End
    SO30 2WT Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritishAccountant79314210001
    CHARTERIS, Derek William
    Belswains Lane
    HP3 9PT Hemel Hempstead
    111
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Belswains Lane
    HP3 9PT Hemel Hempstead
    111
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director136986090001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    Diretor
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant98818450001
    CROSSLEY, Nigel
    Tempsford
    34 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    Tempsford
    34 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director145901880001
    DARA, Alireza
    23 Lynwood Road
    W5 1JQ London
    Diretor
    23 Lynwood Road
    W5 1JQ London
    United KingdomBritishManagement Consultant22461240001
    DAVIES, Lyn Theodore
    Cheridene
    65 Bowham Avenue
    CF31 3PA Bridgend
    Mid Glamorgan
    Diretor
    Cheridene
    65 Bowham Avenue
    CF31 3PA Bridgend
    Mid Glamorgan
    BritishCompany Director34304310003
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Diretor
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritishCompany Director27300002
    FORREST, Keith Robert Mckenzie
    18 St Andrews Close
    Moreton On Lugg
    HR4 8DD Hereford
    Hereford & Worcester
    Diretor
    18 St Andrews Close
    Moreton On Lugg
    HR4 8DD Hereford
    Hereford & Worcester
    BritishManaging Director45838740001
    HARRIS, Gareth Addison
    18 Painters Pightle
    Hook
    RG27 9SS Basingstoke
    Hampshire
    Diretor
    18 Painters Pightle
    Hook
    RG27 9SS Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritishDirector152131210001
    HOLLOWAY, David John
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    Diretor
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishGroup Finance Director66183100001
    HOLROYD, Dean
    51 Grove Road
    SL4 1JD Windsor
    Berkshire
    Diretor
    51 Grove Road
    SL4 1JD Windsor
    Berkshire
    BritishDirector64875220002
    HYDE, Trevor John
    158 Jerounds
    CM19 4HH Harlow
    Essex
    Diretor
    158 Jerounds
    CM19 4HH Harlow
    Essex
    BritishCompany Director71827110001
    JONES, Martin William
    Rose Cottage
    Eathorpe
    CV33 9DE Leamington Spa
    Warwickshire
    Diretor
    Rose Cottage
    Eathorpe
    CV33 9DE Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishSales Director26034610001
    LAWSON, Robert
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    Diretor
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    EnglandBritishDirector99991140001
    MALPUS, John James
    Armitage House
    Armitage Road
    WS15 4AZ Armitage
    Staffordshire
    Diretor
    Armitage House
    Armitage Road
    WS15 4AZ Armitage
    Staffordshire
    BritishDirector6799180003
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishDirector/Company Secretary26880001
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishGeneral Counsel76945730001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Diretor
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    BritishChartered Accountant114414690002
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Controller87359710001
    RELF, Russell Alan
    113 The Chase
    SS6 8QP Rayleigh
    Essex
    Diretor
    113 The Chase
    SS6 8QP Rayleigh
    Essex
    BritishDistributor Director59133030001
    RUDDICK, Ian William
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    Diretor
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector98350001

    LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Borrower deed of charge between the chargors, the issuer, the working capital facility provider, the obligor account banks and the borrower security trustee (each as defined)
    Criado em 28/02/2001
    Entregue em 20/03/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    An amount equal to the borrower secured liabilities defined as all present and future obligations and liabilities (whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the borrower secured creditors (or any of them) under the transaction documents (or any of them) in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the transaction documents for which any obligor is liable under the transaction documents on a full indemnity basis.
    Breve descrição
    All property assets and other rights the subject of the security interests created in favour of the borrower security trustee pursuant to the borrower security documents. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Chase Manhattan Bank (As Borrower Security Trustee)
    Transações
    • 20/03/2001Registro de uma garantia (395)
    • 03/09/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined)
    Criado em 11/09/2000
    Entregue em 23/09/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996.
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York (As "Security Agent")
    Transações
    • 23/09/2000Registro de uma garantia (395)
    • 10/09/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattel mortgage
    Criado em 18/11/1997
    Entregue em 21/11/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,620,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    1 x gouet automatic production line comprising 3 x make-up limited, 3 x sogen transfer conveyors, 3 x resting chambers and various other items and goods as listed on the form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lombard North Central PLC
    Transações
    • 21/11/1997Registro de uma garantia (395)
    • 21/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattel mortgage
    Criado em 14/11/1997
    Entregue em 18/11/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,475,118.98 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    Various chattels as specified in agreement no. 355-970448-14 dated 14TH november 1997 between the company and the chargee. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lombard North Central PLC
    Transações
    • 18/11/1997Registro de uma garantia (395)
    • 21/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed charge
    Criado em 19/03/1997
    Entregue em 20/03/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £708,265 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    First fixed charge over:- 1 x jackstone manufacturing line, including 3 spiral coolers, 3 spiral freezers with full interconnecting conveyor system, insulation and controls serial no: A193/14.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transações
    • 20/03/1997Registro de uma garantia (395)
    • 13/07/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed charge
    Criado em 07/03/1997
    Entregue em 08/03/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £311,802 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    1 x abb power factor corrector serial no.C861407/1-5, 32 x artofex stainless steel equipment, 4 x chilled water fan coil units. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transações
    • 08/03/1997Registro de uma garantia (395)
    • 13/07/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattel mortgage
    Criado em 10/12/1996
    Entregue em 13/12/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,460,285.64 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The items as set out on the schedule attached to form 395 together with all books manuals handbooks technical data drawings schedules and other documentation (or any amendments to them). Some of the items are one GA18-7.5 Air compressor, 2 40' dry van containers stainless steel, one ADV20-60 and one ADV16-66 condenser and one ADS2-26 and one ADS1-26 dry air cooler. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transações
    • 13/12/1996Registro de uma garantia (395)
    • 02/09/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattel mortgage
    Criado em 15/07/1996
    Entregue em 20/07/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £444,520.70 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    Various chattels as specified in form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lombard North Central PLC
    Transações
    • 20/07/1996Registro de uma garantia (395)
    • 02/09/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 11/07/1996
    Entregue em 11/07/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule attached to form 395 being:- one new deltamatic DV50 water meter serial number 6497, one new sprint 300 ri mixer serial number 24999, one new generator serial number CO62137/01. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Forward Trust Limited
    Transações
    • 11/07/1996Registro de uma garantia (395)
    • 02/09/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattel mortgage
    Criado em 09/05/1996
    Entregue em 11/05/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £936,432 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage
    Breve descrição
    Various goods comprising 1 x new gouet product line (line number 3). see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lombard North Central PLC
    Transações
    • 11/05/1996Registro de uma garantia (395)
    • 02/09/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattel mortgage
    Criado em 02/10/1995
    Entregue em 04/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £518,495.13 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this chattel mortgage
    Breve descrição
    1 x microsearch metal detect sys serial number-73734A. 1 x microsearch metal detect sys serial number 73734B. 2 x caseweighers with cintex serial number 2509A.. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lombard North Central PLC
    Transações
    • 04/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 02/09/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed charge
    Criado em 01/08/1995
    Entregue em 02/08/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £312,406 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    Various items of plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transações
    • 02/08/1995Registro de uma garantia (395)
    • 13/07/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Credit agreement
    Criado em 26/08/1993
    Entregue em 07/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £40486.30 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Breve descrição
    All right title & interest in & to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Close Brothers Limited
    Transações
    • 07/09/1993Registro de uma garantia (395)
    • 12/07/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Collateral debenture
    Criado em 27/11/1991
    Entregue em 29/11/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the london superstores limited on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • 3I Group PLC
    Transações
    • 29/11/1991Registro de uma garantia (395)
    • 02/09/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 15/10/1988
    Entregue em 04/11/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 04/11/1988Registro de uma garantia
    • 11/08/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0