BRAITRIM GROUP LIMITED

BRAITRIM GROUP LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaBRAITRIM GROUP LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02125675
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de BRAITRIM GROUP LIMITED?

    • Atividades de consultoria de gestão, exceto gestão financeira (70229) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica BRAITRIM GROUP LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Central Working White City Translation And Innovation Hub
    80 Wood Lane
    W12 0BZ London
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de BRAITRIM GROUP LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    BRAITRIM LIMITED28/05/198728/05/1987
    BRACKENBOND PLC23/04/198723/04/1987

    Quais são as últimas contas de BRAITRIM GROUP LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2018

    Quais são as últimas submissões para BRAITRIM GROUP LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória

    1 páginasGAZ2

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2018

    17 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2017

    16 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Endereço do domicílio registado alterado de Braitrim House 98 Victoria Road London NW10 6NB para Central Working White City Translation and Innovation Hub 80 Wood Lane London W12 0BZ em 08/01/2018

    1 páginasAD01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2016

    17 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2015

    16 páginasAA

    Declaração anual preparada até 31/12/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital08/03/2016

    Estado do capital em 08/03/2016

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Declaração anual preparada até 31/12/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital12/02/2015

    Estado do capital em 12/02/2015

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de 6Th Floor 10 Dominion Street London EC2M 2EE para Braitrim House 98 Victoria Road London NW10 6NB

    1 páginasAD02

    Os registos foram transferidos para o endereço do domicílio registado Braitrim House 98 Victoria Road London NW10 6NB

    1 páginasAD04

    Detalhes do diretor alterados para Mr Graeme Andrew Scott Rutherford em 03/03/2014

    2 páginasCH01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2014

    16 páginasAA

    Declaração anual preparada até 31/12/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital13/02/2014

    Estado do capital em 13/02/2014

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2013

    16 páginasAA

    Satisfação total da garantia 021256750007

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 021256750006

    4 páginasMR04

    Registo da garantia 021256750007

    20 páginasMR01

    Término da nomeação de Joseph Murphy como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Ben James Hunt como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Nicholas Ente como diretor

    2 páginasTM01

    Quem são os diretores de BRAITRIM GROUP LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HUNT, Ben James
    Translation And Innovation Hub
    80 Wood Lane
    W12 0BZ London
    Central Working White City
    England
    Diretor
    Translation And Innovation Hub
    80 Wood Lane
    W12 0BZ London
    Central Working White City
    England
    Hong KongBritishExecutive183265190001
    RUTHERFORD, Graeme Andrew Scott
    Translation And Innovation Hub
    80 Wood Lane
    W12 0BZ London
    Central Working White City
    England
    Diretor
    Translation And Innovation Hub
    80 Wood Lane
    W12 0BZ London
    Central Working White City
    England
    EnglandBritishDirector137560120005
    BLANCHARD, Jonathan Neil
    1 Little Gaddesden House
    Little Gaddesden
    HP4 1PL Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secretário
    1 Little Gaddesden House
    Little Gaddesden
    HP4 1PL Berkhamsted
    Hertfordshire
    British67243220003
    BONGIORNO, John Joseph
    19a Selborne Road
    3142 Toorak
    3142 Victoria
    Australia
    Secretário
    19a Selborne Road
    3142 Toorak
    3142 Victoria
    Australia
    AustralianDirector94637000002
    CARSTENS, Andre
    Callantina Road
    3122 Hawthorn
    17
    Victoria
    Australia
    Secretário
    Callantina Road
    3122 Hawthorn
    17
    Victoria
    Australia
    AustralianChief Financial Officer122830070002
    DAVIS, Harold
    34 Connaught Drive
    NW11 6BJ London
    Secretário
    34 Connaught Drive
    NW11 6BJ London
    British3420850001
    DONEGAN, Steven Michael
    Fitzgibbon Crescent
    3161 Caulfield North
    28
    Victoria
    Australia
    Secretário
    Fitzgibbon Crescent
    3161 Caulfield North
    28
    Victoria
    Australia
    AustralianGroup Treasurer137561570001
    GIVONI, Michael Nathan
    Unit 2/6a St Leonard's Avenue
    3182 St Kilda
    3182
    Australia
    Secretário
    Unit 2/6a St Leonard's Avenue
    3182 St Kilda
    3182
    Australia
    AustralianGroup General Legal Counsel122829370001
    MCDONALD, Wayne Douglas
    13 Balfour Street
    Doncaster
    Victoria 3108
    Australia
    Secretário
    13 Balfour Street
    Doncaster
    Victoria 3108
    Australia
    AustralianSecretary94637090001
    O'SULLIVAN, Judith-Anne
    Level 3, 350 Queen St
    Melbourne
    Victoria 3000
    Australia
    Secretário
    Level 3, 350 Queen St
    Melbourne
    Victoria 3000
    Australia
    BritishCompany Secretary95244390004
    ALLEN, Frank John
    Kevali 13 Jeffries Court
    Hedsor Road
    SL8 5DY Bourne End
    Buckinghamshire
    Diretor
    Kevali 13 Jeffries Court
    Hedsor Road
    SL8 5DY Bourne End
    Buckinghamshire
    BritishDirector42023240003
    BLANCHARD, Jonathan Neil
    1 Little Gaddesden House
    Little Gaddesden
    HP4 1PL Berkhamsted
    Hertfordshire
    Diretor
    1 Little Gaddesden House
    Little Gaddesden
    HP4 1PL Berkhamsted
    Hertfordshire
    EnglandBritishFinance Director67243220003
    BLYTHE, Brian Stuart
    3568 Point Nepean Road
    Portsea
    Victoria 3944
    Australia
    Diretor
    3568 Point Nepean Road
    Portsea
    Victoria 3944
    Australia
    AustralianDirector94637020001
    BONGIORNO, John Joseph
    19a Selborne Road
    3142 Toorak
    3142 Victoria
    Australia
    Diretor
    19a Selborne Road
    3142 Toorak
    3142 Victoria
    Australia
    AustralianDirector94637000002
    CARSTENS, Andre
    Callantina Road
    3122 Hawthorn
    17
    Victoria
    Australia
    Diretor
    Callantina Road
    3122 Hawthorn
    17
    Victoria
    Australia
    AustraliaAustralianChief Financial Officer122830070002
    CLOUGH, Gavin Darrell
    17a Marlow Road
    HP11 1TA High Wycombe
    Buckinghamshire
    Diretor
    17a Marlow Road
    HP11 1TA High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishEuropean Finance & Admin Direc91650720001
    COLEMAN, John Ashley
    Everington House
    Everington Hill
    RG18 0UD Yattendon
    Berkshire
    Diretor
    Everington House
    Everington Hill
    RG18 0UD Yattendon
    Berkshire
    EnglandBritishManaging Director62128080003
    DAVIDSON, Steven
    Hollyhurst
    Sandy Lane
    KT20 6NE Tadworth
    Surrey
    Diretor
    Hollyhurst
    Sandy Lane
    KT20 6NE Tadworth
    Surrey
    EnglandEnglishOverseas Director150579140001
    ENTE, Nicholas Johan
    Braitrim House
    98 Victoria Road
    NW10 6NB London
    Diretor
    Braitrim House
    98 Victoria Road
    NW10 6NB London
    AustraliaAustralianCeo168888010001
    ENTE, Nicholas Johan
    Pacific Place
    88 Queensway
    Admiralty
    Apt 2500
    Hong Kong
    Diretor
    Pacific Place
    88 Queensway
    Admiralty
    Apt 2500
    Hong Kong
    Hong KongAustralianCeo137561470003
    EVANS, Ronald Barry
    Apartment 11 Cairns Apartments
    131 Hotham Street
    East Melbourne
    Victoria 3002
    Australia
    Diretor
    Apartment 11 Cairns Apartments
    131 Hotham Street
    East Melbourne
    Victoria 3002
    Australia
    AustralianDirector94637070001
    FARNIK, Josef Peter
    Garden Street
    3141 South Yarra
    44
    Victoria
    Australia
    Diretor
    Garden Street
    3141 South Yarra
    44
    Victoria
    Australia
    AustraliaAustralianChief Executive Officer123638990003
    MONTEITH, James Henry George
    145 Rosendale Road
    Dulwich
    SE21 8HE London
    Diretor
    145 Rosendale Road
    Dulwich
    SE21 8HE London
    EnglandBritishChartered Accountant103511470001
    MOORE, Peter Augustine
    Orchards
    Milton Bryan
    MK17 9HS Milton Keynes
    Bedfordshire
    Diretor
    Orchards
    Milton Bryan
    MK17 9HS Milton Keynes
    Bedfordshire
    BritishCompany Director39904050001
    MURPHY, Joseph
    Stuyvestant
    Circle East
    Setauket
    1
    New York
    United States Of America
    Diretor
    Stuyvestant
    Circle East
    Setauket
    1
    New York
    United States Of America
    UsaAmericanDirector137559970001
    NICHOLSON, Maurice Raymond Lawrence
    41 Polygon Road
    St Heliers
    Auckland
    New Zealand
    Diretor
    41 Polygon Road
    St Heliers
    Auckland
    New Zealand
    New ZealanderDirector107215540001
    PADDISON, Jack Thomas Russell
    Not Applicable
    148 Evelyn Avenue
    HA4 8AA Ruislip
    Middlesex
    Diretor
    Not Applicable
    148 Evelyn Avenue
    HA4 8AA Ruislip
    Middlesex
    BritishCompany Director49157890003
    SHALSON, Peter
    26 Upper Brook Street
    W1K 7QE London
    Diretor
    26 Upper Brook Street
    W1K 7QE London
    Great BritainBritishCompany Director76379940001
    SHEPLEY, Martyn James
    8 Myrtle Street
    Clifton Hill
    Victoria 3068
    Australia
    Diretor
    8 Myrtle Street
    Clifton Hill
    Victoria 3068
    Australia
    BritishDirector107220470001
    SOLOMON, Peter Loris
    Braitrim House
    98 Victoria Road
    NW10 6NB London
    Diretor
    Braitrim House
    98 Victoria Road
    NW10 6NB London
    Hong KongAustralianChief Executive Officer164227750001
    UNITE, Roger William
    Braitrim House
    98 Victoria Road
    NW10 6NB London
    Diretor
    Braitrim House
    98 Victoria Road
    NW10 6NB London
    BritishFinance Director39501820001
    WHITE, William Peter Ramsey
    10 The Nurseries
    Eaton Bray
    LU6 2AX Dunstable
    Bedfordshire
    Diretor
    10 The Nurseries
    Eaton Bray
    LU6 2AX Dunstable
    Bedfordshire
    BritishDirector38970090001
    WILSON, Peter Alexander
    25 Black Street
    Brighton
    Victoria
    3186
    Australia
    Diretor
    25 Black Street
    Brighton
    Victoria
    3186
    Australia
    AustralianChief Executive Officer75563740002

    Quem são as pessoas com controle significativo de BRAITRIM GROUP LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Mr Graeme Andrew Scott Rutherford
    Translation And Innovation Hub
    80 Wood Lane
    W12 0BZ London
    Central Working White City
    England
    06/04/2016
    Translation And Innovation Hub
    80 Wood Lane
    W12 0BZ London
    Central Working White City
    England
    Não
    Nacionalidade: British
    País de residência: England
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 25% mas não mais de 50% das ações da empresa.

    BRAITRIM GROUP LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 29/11/2013
    Entregue em 06/12/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Pep Services Pty LTD as Security Trustee
    Transações
    • 06/12/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 19/12/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 01/11/2013
    Entregue em 11/11/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Pep Services Pty LTD as Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transações
    • 11/11/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 19/12/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Pledge agreement
    Criado em 08/05/1998
    Entregue em 21/05/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever existing at the date of the pledge agreement
    Breve descrição
    The pledged shares means 499 registered shares of frf 100 each together with the returns and proceeds in all currencies under the pledge agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 21/05/1998Registro de uma garantia (395)
    • 07/04/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge
    Criado em 08/05/1998
    Entregue em 19/05/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and the secured parties under the financing documents (as defined)
    Breve descrição
    2500 ord shares of held by the chargor in the capital of the company with all the chargor's present and future rights including all securities all allotments all repayments all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 19/05/1998Registro de uma garantia (395)
    • 07/04/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge
    Criado em 08/05/1998
    Entregue em 19/05/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and the secured parties under the financing documents (as defined)
    Breve descrição
    1470 ord shares of $1 held by the chargor in the capital of the company with all the chargor's present and future rights including all securities all allotments all repayments all dividends.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 19/05/1998Registro de uma garantia (395)
    • 07/04/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Share pledge agreement
    Criado em 06/05/1998
    Entregue em 20/05/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies, obligations and liabilities at the date of the share pledge agreement or thereafter due owing or incurred by the company to the chargee pursuant to the guarantee and debenture
    Breve descrição
    One share of the nominal amount of DM24.000 Of the company the future shares and all ancillary rights and claims with respect to the shares in particular the rights to dividends and liquidation proceeds and the right to subscribe for newly issued shares.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 20/05/1998Registro de uma garantia (395)
    • 07/04/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 13/03/1998
    Entregue em 21/03/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the chargee as agent and security trustee for itself and each of the secured parties (as defined) under the financing documents (as defined)
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 21/03/1998Registro de uma garantia (395)
    • 07/04/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0