CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED

CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Declarações de pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED
    Estado da empresaLiquidação
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02196821
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    • construção de edifícios comerciais (41201) / Construção

    Onde fica CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    10 Fleet Place
    EC4M 7QS London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CASTLEOAK CONSTRUCTION LIMITED15/05/199615/05/1996
    CASTLE CONSTRUCTION (SOUTH WALES) LIMITED08/02/198808/02/1988
    NETUNIQUE LIMITED20/11/198720/11/1987

    Quais são as últimas contas de CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    VencidoSim
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em30/09/2020
    Próximas contas vencem em30/09/2021
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2019

    Qual é o status da última declaração de confirmação para CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    VencidoSim
    Última declaração de confirmação elaborada até10/05/2022
    Próxima declaração de confirmação vence24/05/2022
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até10/05/2021
    VencidoSim

    Quais são as últimas submissões para CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 27/10/2025

    23 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 27/10/2024

    29 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 27/10/2023

    26 páginasLIQ03

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Remoção do liquidatário por ordem judicial

    19 páginasLIQ10

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 27/10/2022

    35 páginasLIQ03

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Remoção do liquidatário por ordem judicial

    104 páginasLIQ10

    Endereço do domicílio registado alterado de 15 Canada Square London E14 5GL para 10 Fleet Place London EC4M 7QS em 20/12/2021

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução extraordinária para a liquidação em 28/10/2021

    LRESEX

    Estado de situação patrimonial

    14 páginasLIQ02

    Endereço do domicílio registado alterado de Raglan House Malthouse Avenue Cardiff Gate Business Park Cardiff South Glamorgan CF23 8RA para 15 Canada Square London E14 5GL em 11/11/2021

    2 páginasAD01

    Registo da garantia 021968210012, criada em 30/09/2021

    13 páginasMR01

    Nomeação de Mr Robert John Smith como diretor em 03/06/2021

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 10/05/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr Colwyn Roy Knight como diretor em 03/06/2021

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Lisa Veronica Gledhill como diretor em 03/06/2021

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Andrew Norman Duggan como diretor em 03/06/2021

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Katie Michelle Elizabeth Still como diretor em 24/04/2021

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Andrew Norman Duggan como diretor em 07/05/2021

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Robert John Smith como diretor em 07/05/2021

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Colwyn Roy Knight como diretor em 07/05/2021

    1 páginasTM01

    Nomeação de Miss Lisa Veronica Gledhill como diretor em 07/05/2021

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mrs Katie Michelle Elizabeth Still como diretor em 14/09/2020

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    DUGGAN, Andrew Norman
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Diretor
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    WalesBritish103404260001
    FOSTER, Paul Guy
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Diretor
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    EnglandBritish138480900001
    KNIGHT, Colwyn Roy
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Diretor
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    WalesBritish228144720001
    SMITH, Robert John
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Diretor
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    EnglandBritish284046520001
    COAKLEY, Calvin Lloyd
    44 Pentwyn
    Radyr
    CF15 8RE Cardiff
    Secretário
    44 Pentwyn
    Radyr
    CF15 8RE Cardiff
    British19312940002
    COAKLEY, Calvin Lloyd
    44 Pentwyn
    Radyr
    CF15 8RE Cardiff
    Secretário
    44 Pentwyn
    Radyr
    CF15 8RE Cardiff
    British19312940002
    JOHN, Dafydd Rhys
    Gwehelog
    NP15 1RB Usk
    Mulberry House
    Monmouthshire
    Secretário
    Gwehelog
    NP15 1RB Usk
    Mulberry House
    Monmouthshire
    British130454010002
    KNIGHT, Amanda Jayne
    Wood Farm
    Gwehelog
    NP15 1RD Usk
    Secretário
    Wood Farm
    Gwehelog
    NP15 1RD Usk
    British78119010002
    KNIGHT, Amanda Jayne
    Llanberis
    Monmouth Road
    NP15 2LA Raglan
    Monmouthshire
    Secretário
    Llanberis
    Monmouth Road
    NP15 2LA Raglan
    Monmouthshire
    British78119010001
    KNIGHT, Melville William
    Wood Farm
    Gwehelog
    NP15 1RD Usk
    Secretário
    Wood Farm
    Gwehelog
    NP15 1RD Usk
    British23297750005
    ROWLES, Paul
    23 Hazel Close
    New Inn
    NP4 0RR Pontypool
    Torfaen
    Secretário
    23 Hazel Close
    New Inn
    NP4 0RR Pontypool
    Torfaen
    British47041550002
    COAKLEY, Calvin Lloyd
    44 Pentwyn
    Radyr
    CF15 8RE Cardiff
    Diretor
    44 Pentwyn
    Radyr
    CF15 8RE Cardiff
    United KingdomBritish19312940002
    CURRIE, Craig
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Diretor
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    EnglandBritish90119310003
    DUGGAN, Andrew Norman
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Diretor
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish103404260001
    GLEDHILL, Lisa Veronica
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Diretor
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish178456550002
    GREENSTREET, Simon David John
    Rumpus House
    Llandenny
    NP15 1DL Usk
    Monmouthshire
    Diretor
    Rumpus House
    Llandenny
    NP15 1DL Usk
    Monmouthshire
    WalesBritish47041540007
    HOAD, Roger John
    4 Priory Way
    Langstone
    NP18 2JE Newport
    Diretor
    4 Priory Way
    Langstone
    NP18 2JE Newport
    United KingdomBritish112194240001
    JOHN, Dafydd Rhys
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Diretor
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish130454010002
    JONES, Douglas Mark
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Diretor
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish61496560003
    KNIGHT, Colwyn Roy
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Diretor
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish228144720001
    KNIGHT, Colwyn Roy
    The Mount
    Castle Road
    NP15 2JZ Raglan
    Monmouthshire
    Diretor
    The Mount
    Castle Road
    NP15 2JZ Raglan
    Monmouthshire
    WalesBritish23297760001
    KNIGHT, Melville William
    Wood Farm
    Gwehelog
    NP15 1RD Usk
    Diretor
    Wood Farm
    Gwehelog
    NP15 1RD Usk
    United KingdomBritish23297750005
    KNIGHT, Melville Roy
    4 Barton Bridge Rise
    NP5 2JU Raglan
    Gwent
    Diretor
    4 Barton Bridge Rise
    NP5 2JU Raglan
    Gwent
    British9732680002
    LOUDEN, Nicholas William
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Diretor
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish137252480001
    MARCH, Eric Francis
    27 White Street
    SN10 4DP Market Lavington
    Wiltshire
    Diretor
    27 White Street
    SN10 4DP Market Lavington
    Wiltshire
    EnglandBritish15192030002
    ROSSER, Karen Catherine
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Diretor
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish161080070001
    SMITH, Jonathan Mark
    3 Wellfield Close
    NP4 0SS Coed Y Paen
    Jasmine House
    Monmouthshire
    Diretor
    3 Wellfield Close
    NP4 0SS Coed Y Paen
    Jasmine House
    Monmouthshire
    United KingdomBritish138228700001
    SMITH, Robert John
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Diretor
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    EnglandBritish284046520001
    STEPHENS, Paul
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Diretor
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish95528060002
    STILL, Katie Michelle Elizabeth
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Diretor
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish269327810001
    SWAIN, Brian Macvicar
    Laheen
    Cansiron Lane
    RH19 3SD Ashurst Wood
    West Sussex
    Diretor
    Laheen
    Cansiron Lane
    RH19 3SD Ashurst Wood
    West Sussex
    United KingdomAmerican22219950002
    WATKINS, Nigel Kenneth
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    Diretor
    Raglan House Malthouse Avenue
    Cardiff Gate Business Park
    CF23 8RA Cardiff
    South Glamorgan
    EnglandBritish187325680001

    Quem são as pessoas com controle significativo de CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Malthouse Avenue
    Pontprennau
    CF23 8RA Cardiff
    Raglan House
    Wales
    06/04/2016
    Malthouse Avenue
    Pontprennau
    CF23 8RA Cardiff
    Raglan House
    Wales
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridade legalCompanies Act
    Local de registroCompanies House
    Número de registro04188115
    Natureza do controle
    • A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, uma influência ou controle significativo sobre a empresa.

    Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Declarações de pessoas com controle significativo
    Notificado emCessado emDeclaração
    10/05/201710/05/2017A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa.

    CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 30/09/2021
    Entregue em 04/10/2021
    Pendente
    Breve descrição
    Security over cash deposit.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transações
    • 04/10/2021Registro de uma garantia (MR01)
    Chattels mortgage
    Criado em 31/10/2002
    Entregue em 31/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and singular the chattels plant machinery and things being 1 x hp 9100C digital sender s/no. SJPX8001847, 1 x hp colour laserjet 8550N printer s/no. SJPMC438853, 1 x dell precision 340 dt P4 1.7GHZ/256K workstation/pc s/no. BD22HOJ (for further details of property charged please see schedule to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transações
    • 31/10/2002Registro de uma garantia (395)
    • 31/05/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 31/05/2002
    Entregue em 01/06/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/Hold property known as icon house,cardiff gate business park,cardiff. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 01/06/2002Registro de uma garantia (395)
    • 31/05/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 22/05/2002
    Entregue em 30/05/2002
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 30/05/2002Registro de uma garantia (395)
    • 31/05/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    • 27/06/2008
    Assignment
    Criado em 02/03/2001
    Entregue em 02/03/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a construction contract
    Breve descrição
    With full title guarantee assigns to the chargee the deposit of £150,000 credited to account number 21561102, designation royal bank of scotland re castle oak construction limited.
    Pessoas com direito
    • Ledbury Health Limited
    Transações
    • 02/03/2001Registro de uma garantia (395)
    • 31/05/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over cash deposits
    Criado em 18/06/1999
    Entregue em 26/06/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the secured agreements referred to in this charge and/or the charge.
    Breve descrição
    Fixed charge on the deposit of £4,000.00 per calendar month for twelve months commencing on the 1ST july 1999, and all entitlements to interest and the right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the said deposit.
    Pessoas com direito
    • Technical & General Guarantee Company Limited
    Transações
    • 26/06/1999Registro de uma garantia (395)
    • 31/05/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 03/03/1999
    Entregue em 10/03/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or castleoak PLC to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Flat 32 endy mion mews hatfield herts. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 10/03/1999Registro de uma garantia (395)
    • 31/05/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 17/07/1998
    Entregue em 23/07/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,350 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    The rent deposit of £1,350. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Mole Valley District Council
    Transações
    • 23/07/1998Registro de uma garantia (395)
    • 31/05/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 03/10/1994
    Entregue em 13/10/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    4 barton bridge rise, raglan, gwent. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 13/10/1994Registro de uma garantia (395)
    • 31/05/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 24/09/1993
    Entregue em 28/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a plot 1 castle meadows raglan gwent with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 28/09/1993Registro de uma garantia (395)
    • 31/05/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 30/11/1988
    Entregue em 20/12/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land and buildings on south side of station road abergavenny. Title no wa 359129 and/or the proceeds of sale (see doc M395-ref M289 for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 20/12/1988Registro de uma garantia
    • 31/05/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 05/11/1988
    Entregue em 22/11/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book and other debits uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 22/11/1988Registro de uma garantia
    • 31/05/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    CASTLEOAK CARE PARTNERSHIPS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    28/10/2021Início da liquidação
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Ryan Kevin Grant
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Profissional
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Howard Smith
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Profissional
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profissional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Sarah Elizabeth Collins
    2 Forbury Place, 33 Forbury Road
    Reading
    Profissional
    2 Forbury Place, 33 Forbury Road
    Reading

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0