TRIBAL ADVERTISING LIMITED

TRIBAL ADVERTISING LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTRIBAL ADVERTISING LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02214955
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de TRIBAL ADVERTISING LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica TRIBAL ADVERTISING LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Kings Orchard Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de TRIBAL ADVERTISING LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    MUSTOES LIMITED10/12/200210/12/2002
    MUSTOE MERRIMAN LEVY LIMITED22/06/200122/06/2001
    MUSTOE MERRIMAN HERRING LEVY LIMITED03/09/199303/09/1993
    ADDITION MARKETING LIMITED02/08/198802/08/1988
    BEALAW (208) LIMITED28/01/198828/01/1988

    Quais são as últimas contas de TRIBAL ADVERTISING LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2014

    Qual é o status da última declaração anual para TRIBAL ADVERTISING LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para TRIBAL ADVERTISING LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Estado do capital em 28/01/2016

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluções

    Share premium & capital redemption reserve reduced 18/12/2015
    RES13

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 11/07/2015 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital07/08/2015

    Estado do capital em 07/08/2015

    • Capital: GBP 485,250
    SH01

    Nomeação de Mr Robert Charles Garner como diretor em 01/07/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Keith Martin Evans como diretor em 30/06/2015

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014

    5 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Stephen Derrick Breach em 05/06/2014

    2 páginasCH01

    Endereço do domicílio registado alterado de 1-4 Portland Square Bristol BS2 8RR para Kings Orchard Queen Street St. Philips Bristol BS2 0HQ em 04/08/2014

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 11/07/2014 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital18/07/2014

    Estado do capital em 18/07/2014

    • Capital: GBP 485,250
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 11/07/2013 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital24/07/2013

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 24/07/2013

    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012

    6 páginasAA

    Declaração anual preparada até 11/07/2012 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011

    7 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de * 87-91 Newman Street London W1T 3EY United Kingdom* em 09/03/2012

    1 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2010

    7 páginasAA

    Declaração anual preparada até 11/07/2011 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01

    Término da nomeação de Lorraine Davis como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Dr Keith Martin Evans como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Peter Martin como diretor

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de TRIBAL ADVERTISING LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BREACH, Stephen Derrick
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    Diretor
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    EnglandBritishFinance Director174695940001
    GARNER, Robert Charles
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    Diretor
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    United KingdomBritishCompany Director53391420003
    COLLINS, Richard Hawke
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United Kingdom
    Secretário
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United Kingdom
    British53398040001
    DAVIS, Lorraine Anne
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United Kingdom
    Secretário
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United Kingdom
    150580820001
    DSOUZA, Sevellon
    24 Gloucester Circus
    SE10 8RY London
    Secretário
    24 Gloucester Circus
    SE10 8RY London
    British13570330001
    JACKSON, Ingrid
    1 Woodbine Lane
    BN8 4LH Newick
    East Sussex
    Secretário
    1 Woodbine Lane
    BN8 4LH Newick
    East Sussex
    BritishAccountant39821430001
    BEACH SECRETARIES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Secretário nomeado
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    900002710001
    HEXAGON REGISTRARS LIMITED
    Ten Dominion Street
    EC2M 2EE London
    Secretário
    Ten Dominion Street
    EC2M 2EE London
    4004080002
    AMADEO, Andrew
    148 Weston Park
    N8 9PN London
    Diretor
    148 Weston Park
    N8 9PN London
    BritishAdvertising Creative Director79817990001
    CLARK, Nigel Culliford
    10 Weltje Road
    W6 4TJ London
    Diretor
    10 Weltje Road
    W6 4TJ London
    BritishAdvertising15454020001
    DIVER, William Paul
    Flat 4
    2 Kempsford Gardens
    SW5 9LH London
    Diretor
    Flat 4
    2 Kempsford Gardens
    SW5 9LH London
    United KingdomBritishAdvertising Copywriter68328530001
    DSOUZA, Sevellon
    24 Gloucester Circus
    SE10 8RY London
    Diretor
    24 Gloucester Circus
    SE10 8RY London
    BritishAdvertising Executive13570330001
    EVANS, Keith Martin, Dr
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    Diretor
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    United KingdomBritishDirector159812510001
    FAIR, Howard
    29 Canons Close
    WD7 7ER Radlett
    Hertfordshire
    Diretor
    29 Canons Close
    WD7 7ER Radlett
    Hertfordshire
    BritishAdvertising Executive75764390001
    FIELD, Andrew
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United Kingdom
    Diretor
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector61471170001
    HARDING, Matthew
    55 Corbyn Street
    N4 3BY London
    Diretor
    55 Corbyn Street
    N4 3BY London
    BritishAdvertising Services41428120004
    HERRING, Christopher
    54 Chestnut Avenue
    KT10 8JF Esher
    Surrey
    Diretor
    54 Chestnut Avenue
    KT10 8JF Esher
    Surrey
    BritishAdvertising39820940002
    HORNER, Damian
    Flat 170c Walm Lane
    Willesden Green
    NW2 3AX London
    Diretor
    Flat 170c Walm Lane
    Willesden Green
    NW2 3AX London
    BritishBusiness Development Director87850780001
    JACKSON, Ingrid
    1 Woodbine Lane
    BN8 4LH Newick
    East Sussex
    Diretor
    1 Woodbine Lane
    BN8 4LH Newick
    East Sussex
    BritishAccountant39821430001
    JACKSON, Ingrid
    1 Woodbine Lane
    BN8 4LH Newick
    East Sussex
    Diretor
    1 Woodbine Lane
    BN8 4LH Newick
    East Sussex
    BritishAdvertising39821430001
    JITSUKAWA, Haruhiko
    3-7-13 Nishigaoka Izumi-Ku
    Yokohama-Shi
    Kanagawa
    Japan
    Diretor
    3-7-13 Nishigaoka Izumi-Ku
    Yokohama-Shi
    Kanagawa
    Japan
    JapaneseExecutive77517640001
    KATO, Toshiaki
    Chu 2-42-12-103
    Nakano-Ku
    FOREIGN Tokyo
    Japan
    Diretor
    Chu 2-42-12-103
    Nakano-Ku
    FOREIGN Tokyo
    Japan
    JapanJapaneseGm151039390001
    KATSUI, Ryoichi
    Flat 14 Cresta House
    133 Finchley Road
    NW3 6HT London
    Diretor
    Flat 14 Cresta House
    133 Finchley Road
    NW3 6HT London
    JapaneseExecutive66326810003
    LAWTON, Simon Marcus
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United Kingdom
    Diretor
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector68807890004
    LEVY, Andrew Paul
    Brambles
    Common Lane
    WD4 9HP Kings Langley
    Hertfordshire
    Diretor
    Brambles
    Common Lane
    WD4 9HP Kings Langley
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director57420490002
    LEVY, Andrew Paul
    Brambles
    Common Lane
    WD4 9HP Kings Langley
    Hertfordshire
    Diretor
    Brambles
    Common Lane
    WD4 9HP Kings Langley
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccounts Planner57420490002
    MAHONEY, Michael
    11 Althorpe Road
    Wandsworth
    SW17 London
    Diretor
    11 Althorpe Road
    Wandsworth
    SW17 London
    BritishExecutive Creative Director102797480001
    MAHONEY, Michael
    11 Althorpe Road
    Wandsworth
    SW17 London
    Diretor
    11 Althorpe Road
    Wandsworth
    SW17 London
    BritishExecutive Creative Director102797480001
    MAHONEY, Michael
    11 Althorpe Road
    Wandsworth
    SW17 London
    Diretor
    11 Althorpe Road
    Wandsworth
    SW17 London
    BritishAdvertising Creative Director102797480001
    MARTIN, Peter John
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United Kingdom
    Diretor
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector176044430001
    MATSUMOTO, Shu
    2-5-5-1202 Yushima
    Bunkyo-Ku
    Tokyo
    Japan
    Diretor
    2-5-5-1202 Yushima
    Bunkyo-Ku
    Tokyo
    Japan
    JapaneseExecutive86746990001
    MCTAVISH, Douglas Gilchrist
    15 Moneyhill Road
    WD3 2EG Rickmansworth
    Hertfordshire
    Diretor
    15 Moneyhill Road
    WD3 2EG Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAdvertising Executive178889810001
    MERRIMAN, John
    35 Clovelly Road
    Ealing
    W5 5HF London
    Diretor
    35 Clovelly Road
    Ealing
    W5 5HF London
    BritishArt Director39820750003
    MIYAZAKI, Yasuhisa
    Tamako-Cho 1-1-75
    FOREIGN Higashi Murayama Gty
    Tokyo
    Japan
    Diretor
    Tamako-Cho 1-1-75
    FOREIGN Higashi Murayama Gty
    Tokyo
    Japan
    JapaneseCorporate Officer112054100001
    MORRICE, Alan Forbes
    Flat 1 6 Kings Avenue
    SW4 8BD London
    Diretor
    Flat 1 6 Kings Avenue
    SW4 8BD London
    BritishAdvertising Director63090100001

    TRIBAL ADVERTISING LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Legal charge
    Criado em 04/11/2002
    Entregue em 13/11/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The f/h property k/a 2 and 4 bucknall street 12 dyott street and part of castlewood house 77 to 91 (odd) new oxford street london borough of camden t/n 392196. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 13/11/2002Registro de uma garantia (395)
    • 12/06/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 01/10/1999
    Adquirido em 20/12/2000
    Entregue em 22/12/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due
    Breve descrição
    F/H property k/a 12 dyott st london WC1A 1DF t/no 392196.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 22/12/2000Registro de uma aquisição (400)
    • 12/06/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 01/10/1999
    Entregue em 05/10/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 05/10/1999Registro de uma garantia (395)
    • 13/08/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 18/08/1993
    Entregue em 25/08/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Coutts & Company
    Transações
    • 25/08/1993Registro de uma garantia (395)
    • 08/10/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 23/09/1988
    Entregue em 29/09/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Coutts & Company
    Transações
    • 29/09/1988Registro de uma garantia
    • 08/10/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0