LOOMIS TECHNICAL LIMITED

LOOMIS TECHNICAL LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaLOOMIS TECHNICAL LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02221162
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de LOOMIS TECHNICAL LIMITED?

    • Outras atividades de serviços de tecnologia da informação (62090) / Informação e comunicação

    Onde fica LOOMIS TECHNICAL LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Suite A, 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de LOOMIS TECHNICAL LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    SECURITAS MICRO-ROUTE LIMITED28/06/200028/06/2000
    MICRO-ROUTE LIMITED19/04/199019/04/1990
    RR TRANSPORT SERVICES LIMITED15/02/198815/02/1988

    Quais são as últimas contas de LOOMIS TECHNICAL LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2012

    Qual é o status da última declaração anual para LOOMIS TECHNICAL LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para LOOMIS TECHNICAL LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    11 páginas4.71

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 09/09/2014

    15 páginas4.68

    Endereço do domicílio registado alterado de The Poynt 45 Wollaton Street Nottingham NG1 5FW em 07/07/2014

    2 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Browne Jacobson Llp 77 Gracechurch Street London EC3V 0AS England em 20/09/2013

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação

    LRESSP

    Contas anuais preparadas até 31/12/2012

    28 páginasAA

    Declaração anual preparada até 11/04/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital23/04/2013

    Estado do capital em 23/04/2013

    • Capital: GBP 80,000
    SH01

    Nomeação de Mr Kenneth Gustav Roger Hogman como diretor em 31/12/2012

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Ashley Lawrence Bailey como diretor em 31/12/2012

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2011

    25 páginasAA

    Detalhes do secretário alterados para Castlegate Secretaries Limited em 03/07/2012

    3 páginasCH04

    Término da nomeação de Peter John Chippendale como diretor em 31/05/2012

    1 páginasTM01

    Nomeação de Timothy David Gibbs como diretor em 31/05/2012

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 11/04/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2010

    25 páginasAA

    Declaração anual preparada até 11/04/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Browne Jacobson Llp Cna House 77 Gracechurch Street London EC3V 0AS United Kingdom em 04/05/2011

    1 páginasAD01

    Detalhes do diretor alterados para Peter John Chippendale em 04/03/2011

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Anne Lewis como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Anne Elizabeth Lewis como diretor

    3 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2009

    25 páginasAA

    Declaração anual preparada até 11/04/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Quem são os diretores de LOOMIS TECHNICAL LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CASTLEGATE SECRETARIES LIMITED
    Castle Meadow Road
    NG2 1BJ Nottingham
    Mowbray House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Secretário
    Castle Meadow Road
    NG2 1BJ Nottingham
    Mowbray House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro3730056
    128872830001
    GIBBS, Timothy David
    Alder Court
    Rennie Hogg Road
    NG2 1RX Nottingham
    1
    England
    Diretor
    Alder Court
    Rennie Hogg Road
    NG2 1RX Nottingham
    1
    England
    EnglandBritishHead Of Finance & Administration169677720001
    HOGMAN, Kenneth Gustav Roger
    City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Suite A, 7th Floor
    Diretor
    City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Suite A, 7th Floor
    EnglandSwedishDirector174779330001
    BATCHELOR, Michael Sydney
    15a Keswick Road
    Fetcham
    KT22 9HQ Leatherhead
    Surrey
    Secretário
    15a Keswick Road
    Fetcham
    KT22 9HQ Leatherhead
    Surrey
    BritishEngineer66995830001
    BOWE, Anthony
    21 Whoberley Avenue
    CV5 8ER Coventry
    West Midlands
    Secretário
    21 Whoberley Avenue
    CV5 8ER Coventry
    West Midlands
    IrishCompany Director119865320002
    GRAHM, Mikael
    5th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretário
    5th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Swedish105063680001
    LARSSON, Bjorn
    Securitas Cash Management Limited
    5th Floor City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Nottingham
    Secretário
    Securitas Cash Management Limited
    5th Floor City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Nottingham
    SwedishDirector51140290005
    MAYES, Edward Herbert
    121 Kenmore Avenue
    HA3 8PB Harrow
    Middlesex
    Secretário
    121 Kenmore Avenue
    HA3 8PB Harrow
    Middlesex
    British1507540001
    BAILEY, Ashley Lawrence
    c/o Browne Jacobson Llp
    Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    77
    England
    Diretor
    c/o Browne Jacobson Llp
    Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    77
    England
    United KingdomBritishDirector180376930001
    BATCHELOR, Michael Sydney
    15a Keswick Road
    Fetcham
    KT22 9HQ Leatherhead
    Surrey
    Diretor
    15a Keswick Road
    Fetcham
    KT22 9HQ Leatherhead
    Surrey
    BritishEngineer66995830001
    BATCHELOR, Michael Sydney
    15a Keswick Road
    Fetcham
    KT22 9HQ Leatherhead
    Surrey
    Diretor
    15a Keswick Road
    Fetcham
    KT22 9HQ Leatherhead
    Surrey
    BritishEngineer66995830001
    BOWE, Anthony
    21 Whoberley Avenue
    CV5 8ER Coventry
    West Midlands
    Diretor
    21 Whoberley Avenue
    CV5 8ER Coventry
    West Midlands
    EnglandIrishCompany Director119865320002
    CHIPPENDALE, Peter John
    c/o Browne Jacobson Llp
    Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    77
    England
    Diretor
    c/o Browne Jacobson Llp
    Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    77
    England
    United KingdomBritishFinancial Director128144340002
    EDMUNDS, Roderick James
    48 Bembridge Drive
    PO11 9LU Hayling Island
    Hampshire
    Diretor
    48 Bembridge Drive
    PO11 9LU Hayling Island
    Hampshire
    BritishCompany Director43504320002
    ERIKSSON, Per Johan
    5th Floor
    City Gate East, Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Diretor
    5th Floor
    City Gate East, Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    SwedishMng Director79793760004
    GRAHM, Mikael
    5th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Diretor
    5th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomSwedishDirector Hr & Legal105063680001
    HULME, Geoffrey
    Elizabeth House 4 Paddock End
    SN14 6QL Kington St Michael
    Wiltshire
    Diretor
    Elizabeth House 4 Paddock End
    SN14 6QL Kington St Michael
    Wiltshire
    BritishCompany Director58184320001
    LARSSON, Bjorn
    Securitas Cash Management Limited
    5th Floor City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Nottingham
    Diretor
    Securitas Cash Management Limited
    5th Floor City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Nottingham
    SwedishDirector51140290005
    LEAT, Christopher
    64 Doneraile Street
    SW6 6EP London
    Diretor
    64 Doneraile Street
    SW6 6EP London
    BritishCompany Director18213800001
    LEWIS, Anne Elizabeth
    Opal Drive
    Fox Milne
    MK15 0DF Milton Keynes
    Vega House
    Buckinghamshire
    Diretor
    Opal Drive
    Fox Milne
    MK15 0DF Milton Keynes
    Vega House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishManaging Director153497670001
    LEWIS, Anne Elizabeth
    The Holding
    Shipton Road
    OX20 1LW Woodstock
    Oxfordshire
    Diretor
    The Holding
    Shipton Road
    OX20 1LW Woodstock
    Oxfordshire
    BritishManaging Director105063730001
    MAYES, Edward Herbert
    121 Kenmore Avenue
    HA3 8PB Harrow
    Middlesex
    Diretor
    121 Kenmore Avenue
    HA3 8PB Harrow
    Middlesex
    BritishAccountant1507540001
    O'BRIEN, Conor
    251 Brompton Road
    SW3 2EP London
    Diretor
    251 Brompton Road
    SW3 2EP London
    BritishAccountant65483200001
    RICKARD, Anthony Gregory
    Uplands Cottage Pains Hill
    Limpsfield
    RH8 0RF Oxted
    Surrey
    Diretor
    Uplands Cottage Pains Hill
    Limpsfield
    RH8 0RF Oxted
    Surrey
    BritishCompany Director2306400001
    SCOTT, Melville Blair
    23 Forge End
    Chiswell Green
    AL2 3EQ St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    23 Forge End
    Chiswell Green
    AL2 3EQ St Albans
    Hertfordshire
    BritishDirector52213940002
    SIMPSON, John Edward
    9 Barton Crescent
    RH19 4NR East Grinstead
    West Sussex
    Diretor
    9 Barton Crescent
    RH19 4NR East Grinstead
    West Sussex
    BritishAccountant36782660002

    LOOMIS TECHNICAL LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    All assets debenture deed
    Criado em 26/03/1999
    Entregue em 27/03/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transações
    • 27/03/1999Registro de uma garantia (395)
    • 05/03/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 12/09/1996
    Entregue em 14/09/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H property k/a europa 2000 heathcote industrial estate, heathcote way, warwick together with all buildings and fixtures thereon. And the goodwill of the business (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 14/09/1996Registro de uma garantia (395)
    • 05/03/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Single debenture
    Criado em 14/05/1996
    Entregue em 15/05/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 15/05/1996Registro de uma garantia (395)
    • 05/03/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of assignment
    Criado em 27/10/1995
    Entregue em 28/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All of the company's title rights and interest of whatever nature in and to all the sub hire agreements including,without limitation,the right to receive the sub hire debts. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Internationale Nederlanden Lease (UK) Limited
    Transações
    • 28/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 15/04/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Assignment
    Criado em 24/10/1995
    Entregue em 28/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The customer as beneficial owner hereby assigns and agrees to assign absolutely to ing all its rights benefits and interest in and to the account (as defined in the assignment) in whatsoever currency denominaytion.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Internationale Nederlanden Lease (UK) Limited
    Transações
    • 28/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 15/04/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 25/07/1990
    Entregue em 09/08/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    8 bert road, thornton heath, surrey with buildings and fixtures assigns goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 09/08/1990Registro de uma garantia
    • 05/03/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    LOOMIS TECHNICAL LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    15/04/2015Data de dissolução
    10/09/2013Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Jill Sandford
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Nottinghamshire
    Profissional
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Nottinghamshire
    Patrick B Ellward
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Profissional
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0