MINORIES GARAGES LIMITED

MINORIES GARAGES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaMINORIES GARAGES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02245228
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de MINORIES GARAGES LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica MINORIES GARAGES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    770 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de MINORIES GARAGES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ALLERIM LIMITED18/04/198818/04/1988

    Quais são as últimas contas de MINORIES GARAGES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2018

    Quais são as últimas submissões para MINORIES GARAGES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Estado do capital em 30/07/2020

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    legacy

    49 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasAGREEMENT1

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2019 com atualizações

    4 páginasCS01

    Término da nomeação de Matthew Bishop como diretor em 01/01/2019

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr David John Muir como diretor em 01/01/2019

    2 páginasAP01

    legacy

    44 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasAGREEMENT1

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    legacy

    3 páginasAGREEMENT1

    legacy

    49 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    legacy

    51 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasAGREEMENT1

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    Quem são os diretores de MINORIES GARAGES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    FINCH, Mark
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Secretário
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    175736280001
    FINCH, Mark Charles
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary175612870001
    MUIR, David John
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director254017640001
    MACNAMARA, Richard James
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Secretário
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    149316250001
    WARD, Andrew Ian
    6 Coniston Way
    LS22 6TT Wetherby
    West Yorkshire
    Secretário
    6 Coniston Way
    LS22 6TT Wetherby
    West Yorkshire
    British360770001
    WATSON, Deirdre Mary Alison
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Secretário
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Uk74385360001
    MATHESON & CO LIMITED
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Secretário
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    1947590001
    ANDERSON, James Michael
    43 Kingswell
    NE61 2TY Morpeth
    Northumberland
    Diretor
    43 Kingswell
    NE61 2TY Morpeth
    Northumberland
    EnglandBritishAccountant11487420001
    ATKIN, John Richard
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    Diretor
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    BritishFinancial Director20102900001
    BANHAM, Gillian
    2 Dye House Meadow Liston Lane
    CO10 9LD Long Melford
    Suffolk
    Diretor
    2 Dye House Meadow Liston Lane
    CO10 9LD Long Melford
    Suffolk
    BritishGroup Hr Director56735910001
    BEATTIE, Craig Alan
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director177627900001
    BEYNON, Peter
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    Diretor
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritishGroup Finance Director38504390006
    BISHOP, Matthew
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director206755450002
    CHAMBERS, Paul Jonathan
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    Diretor
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    BritishFinance Director1188140001
    COXON, Jeffrey Lance
    Whitehill Hall Gardens
    DH2 2NE Chester Le Street
    2
    Co Durham
    United Kingdom
    Diretor
    Whitehill Hall Gardens
    DH2 2NE Chester Le Street
    2
    Co Durham
    United Kingdom
    United KingdomBritishManager135123710001
    ELIAS, Symon
    11 Deyncourt
    Ponteland
    NE20 9RP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Diretor
    11 Deyncourt
    Ponteland
    NE20 9RP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishManager28841470001
    HERBERT, Mark Philip
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director123285980005
    HOUSTON, Samuel George
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    Diretor
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    BritishFinance Director75730290003
    JONES, Alun Morton
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Fen House
    Suffolk
    United Kingdom
    Diretor
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Fen House
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector12785600004
    MACLAREN, Niall Craig
    Oak House Hollies Lane
    SK9 2BW Wilmslow
    Cheshire
    Diretor
    Oak House Hollies Lane
    SK9 2BW Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishManager32232190002
    MACNAMARA, Richard James
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary149294820002
    POTTS, Derek
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    Diretor
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishFinance Director52485510001
    RITCHIE, John Muir
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    Diretor
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    BritishDirector22325820001
    TAYLOR, Phillip
    63 Cornmoor Road
    Whickham
    NE16 4PU Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Diretor
    63 Cornmoor Road
    Whickham
    NE16 4PU Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    BritishCompany Director83887910001
    WATSON, Deirdre Mary Alison
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Diretor
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    EnglandUkCompany Secretary74385360001
    WILLIAMS, Steven Wyn
    199 Finchampstead Road
    RG40 3HE Wokingham
    Berkshire
    Diretor
    199 Finchampstead Road
    RG40 3HE Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director54580940001
    WILLIAMSON, Michael Granville
    Church Green
    Old Church Lane Pateley Bridge
    HG3 5LZ Harrogate
    North Yorkshire
    Diretor
    Church Green
    Old Church Lane Pateley Bridge
    HG3 5LZ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishChairman & Chief Executive57360160001
    WITT, John Raymond
    28 Westerfield Road
    IP4 2YJ Ipswich
    Suffolk
    Diretor
    28 Westerfield Road
    IP4 2YJ Ipswich
    Suffolk
    CanadianFinance Director51303670001

    Quem são as pessoas com controle significativo de MINORIES GARAGES LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    06/04/2016
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro192238
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    MINORIES GARAGES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 18/04/1994
    Entregue em 05/05/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the debenture
    Breve descrição
    All those monies which may be owing to the company by vag (united kingdom) limited. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transações
    • 05/05/1994Registro de uma garantia (395)
    • 05/10/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Used vehicle charge
    Criado em 14/12/1992
    Entregue em 15/12/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    All its interests in any used cars and unused vehicles under the terms of the used vehicle sale agreement.
    Pessoas com direito
    • Psa Wholesale Limited
    Transações
    • 15/12/1992Registro de uma garantia (395)
    • 02/02/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 19/04/1991
    Entregue em 23/04/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    All monies which from time to time be owing to the company. See form 395 (ref 55) for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transações
    • 23/04/1991Registro de uma garantia
    • 15/09/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 11/08/1988
    Entregue em 15/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a consignment agreement dated 11.8.88
    Breve descrição
    All the chargor's interst (if any) in any vehicle delivered to it under the terms of the said consignment agreement and any monies received therefor.
    Pessoas com direito
    • Psa Wholesale Limited
    Transações
    • 15/08/1988Registro de uma garantia
    • 02/02/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Floating charge
    Criado em 21/07/1988
    Entregue em 10/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 15.7.88
    Breve descrição
    Floating charge over the undertaking & all other property assets & rights including stock in trade.
    Pessoas com direito
    • Berton Finance Limited.
    Transações
    • 10/08/1988Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 15/07/1988
    Adquirido em 22/07/1988
    Entregue em 12/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88
    Breve descrição
    Part of dragonville garage alma place, gilesgate moor durham.
    Pessoas com direito
    • Berton Finance Limited.
    Transações
    • 12/08/1988Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 15/07/1988
    Adquirido em 22/07/1988
    Entregue em 12/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88
    Breve descrição
    F/H land at church road stockton on tees, together with buildings thereon.
    Pessoas com direito
    • Berton Finance Limited.
    Transações
    • 12/08/1988Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 15/07/1988
    Adquirido em 22/07/1988
    Entregue em 12/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88
    Breve descrição
    Land on south side of alma place durham title no du 107256.
    Pessoas com direito
    • Berton Finance Limited.
    Transações
    • 12/08/1988Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 15/07/1988
    Adquirido em 22/07/1988
    Entregue em 12/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88
    Breve descrição
    F/H land and buildings at beneton road ethershore avenue newcastle upon tyne.
    Pessoas com direito
    • Berton Finance Limited.
    Transações
    • 12/08/1988Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 15/07/1988
    Adquirido em 22/07/1988
    Entregue em 12/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88
    Breve descrição
    Land on N.e side of dixons bank.
    Pessoas com direito
    • Berton Finance Limited.
    Transações
    • 12/08/1988Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 15/07/1988
    Adquirido em 22/07/1988
    Entregue em 12/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88
    Breve descrição
    Part of dragonville garage alma place, gilesgate moor durham.
    Pessoas com direito
    • Berton Finance Limited.
    Transações
    • 12/08/1988Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 15/07/1988
    Adquirido em 22/07/1988
    Entregue em 12/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88
    Breve descrição
    Land on east side of newcastle road, sunderland title no ty 100340.
    Pessoas com direito
    • Berton Finance Limited.
    Transações
    • 12/08/1988Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 15/07/1988
    Adquirido em 22/07/1988
    Entregue em 12/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88
    Breve descrição
    F/H land on S.w side of dixons bnak marton.
    Pessoas com direito
    • Berton Finance Limited.
    Transações
    • 12/08/1988Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 15/07/1988
    Adquirido em 22/07/1988
    Entregue em 12/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due pursuant to a loan agreement dated 15.7.88
    Breve descrição
    Land in newcastle road, sunderland tyne and wear.
    Pessoas com direito
    • Berton Finance Limited
    Transações
    • 12/08/1988Registro de uma garantia
    Charge
    Criado em 15/07/1988
    Adquirido em 22/07/1988
    Entregue em 12/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due
    Breve descrição
    F/H land at station road ashington northumberland.
    Pessoas com direito
    • Berton Finance Limited
    Transações
    • 12/08/1988Registro de uma garantia
    Charge
    Criado em 15/07/1988
    Adquirido em 22/07/1988
    Entregue em 12/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due
    Breve descrição
    F/H land k/a grandstord garage kenton road gosforth t/no ty 27338.
    Pessoas com direito
    • Berton Finance Limited
    Transações
    • 12/08/1988Registro de uma garantia
    Charge
    Criado em 15/07/1988
    Adquirido em 22/07/1988
    Entregue em 12/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due
    Breve descrição
    Land together with the garage erected thereon and k/a north hylton garage.
    Pessoas com direito
    • Berton Finance Limited
    Transações
    • 12/08/1988Registro de uma garantia
    Charge
    Criado em 15/07/1988
    Adquirido em 22/07/1988
    Entregue em 12/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due
    Breve descrição
    L/H factory & land being site number BT1/R386 team valley trading estate gateshead t/no ty 200404.
    Pessoas com direito
    • Berton Finance Limited
    Transações
    • 12/08/1988Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0