MINORIES GARAGES LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | MINORIES GARAGES LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 02245228 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de MINORIES GARAGES LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica MINORIES GARAGES LIMITED?
Endereço do escritório registrado | 770 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de MINORIES GARAGES LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
ALLERIM LIMITED | 18/04/1988 | 18/04/1988 |
Quais são as últimas contas de MINORIES GARAGES LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2018 |
Quais são as últimas submissões para MINORIES GARAGES LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado do capital em 30/07/2020
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2019 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Matthew Bishop como diretor em 01/01/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr David John Muir como diretor em 01/01/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
legacy | 44 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2018 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 49 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
legacy | 51 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
Quem são os diretores de MINORIES GARAGES LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINCH, Mark | Secretário | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 175736280001 | |||||||
FINCH, Mark Charles | Diretor | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 175612870001 | ||||
MUIR, David John | Diretor | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | Company Director | 254017640001 | ||||
MACNAMARA, Richard James | Secretário | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 149316250001 | |||||||
WARD, Andrew Ian | Secretário | 6 Coniston Way LS22 6TT Wetherby West Yorkshire | British | 360770001 | ||||||
WATSON, Deirdre Mary Alison | Secretário | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | Uk | 74385360001 | ||||||
MATHESON & CO LIMITED | Secretário | 3 Lombard Street EC3V 9AQ London | 1947590001 | |||||||
ANDERSON, James Michael | Diretor | 43 Kingswell NE61 2TY Morpeth Northumberland | England | British | Accountant | 11487420001 | ||||
ATKIN, John Richard | Diretor | Baillie Gate Queens Drive LS29 9QW Ilkley West Yorkshire | British | Financial Director | 20102900001 | |||||
BANHAM, Gillian | Diretor | 2 Dye House Meadow Liston Lane CO10 9LD Long Melford Suffolk | British | Group Hr Director | 56735910001 | |||||
BEATTIE, Craig Alan | Diretor | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 177627900001 | ||||
BEYNON, Peter | Diretor | Stonehurst Elm Lane Copdock IP8 3ET Ipswich Suffolk | England | British | Group Finance Director | 38504390006 | ||||
BISHOP, Matthew | Diretor | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 206755450002 | ||||
CHAMBERS, Paul Jonathan | Diretor | 24 Constable Road Ben Rhydding LS29 8RW Ilkley West Yorkshire | British | Finance Director | 1188140001 | |||||
COXON, Jeffrey Lance | Diretor | Whitehill Hall Gardens DH2 2NE Chester Le Street 2 Co Durham United Kingdom | United Kingdom | British | Manager | 135123710001 | ||||
ELIAS, Symon | Diretor | 11 Deyncourt Ponteland NE20 9RP Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | Manager | 28841470001 | |||||
HERBERT, Mark Philip | Diretor | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | Company Director | 123285980005 | ||||
HOUSTON, Samuel George | Diretor | Flat 59 Medland House 11 Branch Road E14 7JT London | British | Finance Director | 75730290003 | |||||
JONES, Alun Morton | Diretor | Fen Walk IP12 4BG Woodbridge Fen House Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 12785600004 | ||||
MACLAREN, Niall Craig | Diretor | Oak House Hollies Lane SK9 2BW Wilmslow Cheshire | England | British | Manager | 32232190002 | ||||
MACNAMARA, Richard James | Diretor | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 149294820002 | ||||
POTTS, Derek | Diretor | 55 East Street Coggeshall CO6 1SJ Colchester Essex | United Kingdom | British | Finance Director | 52485510001 | ||||
RITCHIE, John Muir | Diretor | High House Snipe Farm Road IP13 6SL Clopton Suffolk | British | Director | 22325820001 | |||||
TAYLOR, Phillip | Diretor | 63 Cornmoor Road Whickham NE16 4PU Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | British | Company Director | 83887910001 | |||||
WATSON, Deirdre Mary Alison | Diretor | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | England | Uk | Company Secretary | 74385360001 | ||||
WILLIAMS, Steven Wyn | Diretor | 199 Finchampstead Road RG40 3HE Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 54580940001 | ||||
WILLIAMSON, Michael Granville | Diretor | Church Green Old Church Lane Pateley Bridge HG3 5LZ Harrogate North Yorkshire | British | Chairman & Chief Executive | 57360160001 | |||||
WITT, John Raymond | Diretor | 28 Westerfield Road IP4 2YJ Ipswich Suffolk | Canadian | Finance Director | 51303670001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de MINORIES GARAGES LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appleyard Group Limited | 06/04/2016 | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
MINORIES GARAGES LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Criado em 18/04/1994 Entregue em 05/05/1994 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the debenture | |
Breve descrição All those monies which may be owing to the company by vag (united kingdom) limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Used vehicle charge | Criado em 14/12/1992 Entregue em 15/12/1992 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descrição All its interests in any used cars and unused vehicles under the terms of the used vehicle sale agreement. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 19/04/1991 Entregue em 23/04/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descrição All monies which from time to time be owing to the company. See form 395 (ref 55) for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Charge | Criado em 11/08/1988 Entregue em 15/08/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a consignment agreement dated 11.8.88 | |
Breve descrição All the chargor's interst (if any) in any vehicle delivered to it under the terms of the said consignment agreement and any monies received therefor. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Floating charge | Criado em 21/07/1988 Entregue em 10/08/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 15.7.88 | |
Breve descrição Floating charge over the undertaking & all other property assets & rights including stock in trade. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 15/07/1988 Adquirido em 22/07/1988 Entregue em 12/08/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Breve descrição Part of dragonville garage alma place, gilesgate moor durham. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 15/07/1988 Adquirido em 22/07/1988 Entregue em 12/08/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Breve descrição F/H land at church road stockton on tees, together with buildings thereon. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 15/07/1988 Adquirido em 22/07/1988 Entregue em 12/08/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Breve descrição Land on south side of alma place durham title no du 107256. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 15/07/1988 Adquirido em 22/07/1988 Entregue em 12/08/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Breve descrição F/H land and buildings at beneton road ethershore avenue newcastle upon tyne. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 15/07/1988 Adquirido em 22/07/1988 Entregue em 12/08/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Breve descrição Land on N.e side of dixons bank. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 15/07/1988 Adquirido em 22/07/1988 Entregue em 12/08/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Breve descrição Part of dragonville garage alma place, gilesgate moor durham. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 15/07/1988 Adquirido em 22/07/1988 Entregue em 12/08/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Breve descrição Land on east side of newcastle road, sunderland title no ty 100340. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 15/07/1988 Adquirido em 22/07/1988 Entregue em 12/08/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Breve descrição F/H land on S.w side of dixons bnak marton. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 15/07/1988 Adquirido em 22/07/1988 Entregue em 12/08/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due pursuant to a loan agreement dated 15.7.88 | |
Breve descrição Land in newcastle road, sunderland tyne and wear. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Charge | Criado em 15/07/1988 Adquirido em 22/07/1988 Entregue em 12/08/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due | |
Breve descrição F/H land at station road ashington northumberland. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Charge | Criado em 15/07/1988 Adquirido em 22/07/1988 Entregue em 12/08/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due | |
Breve descrição F/H land k/a grandstord garage kenton road gosforth t/no ty 27338. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Charge | Criado em 15/07/1988 Adquirido em 22/07/1988 Entregue em 12/08/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due | |
Breve descrição Land together with the garage erected thereon and k/a north hylton garage. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Charge | Criado em 15/07/1988 Adquirido em 22/07/1988 Entregue em 12/08/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due | |
Breve descrição L/H factory & land being site number BT1/R386 team valley trading estate gateshead t/no ty 200404. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0