ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED

ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02247801
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED?

    • Outras atividades de saúde humana (86900) / Atividades de saúde humana e ação social

    Onde fica ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    SUN HEALTHCARE GROUP EUROPE LIMITED17/09/199717/09/1997
    POOLTOWN HOME LIMITED17/05/199017/05/1990
    SOLDBIND LIMITED25/04/198825/04/1988

    Quais são as últimas contas de ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2010

    Quais são as últimas submissões para ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Término da nomeação de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretário em 09/10/2012

    1 páginasTM02

    Aviso da conclusão do acordo voluntário

    6 páginas1.4

    Término da nomeação de Timothy James Bolot como diretor em 17/08/2012

    1 páginasTM01

    Aviso ao Registo Comercial do acordo voluntário de empresas que entra em vigor

    4 páginas1.1

    Declaração anual preparada até 15/01/2012 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital18/01/2012

    Estado do capital em 18/01/2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Término da nomeação de William James Buchan como diretor em 15/11/2011

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de David Andrew Smith como diretor em 01/11/2011

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Stephen Jonathan Taylor como diretor em 26/10/2011

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Timothy James Bolot como diretor em 26/10/2011

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2010

    28 páginasAA

    legacy

    7 páginasMG01

    Término da nomeação de William Mcleish como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretário

    1 páginasAP03

    Declaração anual preparada até 15/01/2011 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01

    Término da nomeação de Richard Midmer como diretor

    1 páginasTM01

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Enter agreements 14/05/2010
    RES13

    Contas anuais preparadas até 27/09/2009

    24 páginasAA

    Declaração anual preparada até 15/01/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Mr David Andrew Smith em 07/01/2010

    2 páginasCH01

    Nomeação de Mr David Andrew Smith como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de David Smith como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr David Andrew Smith como diretor

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    COPELAND, Robert Nigel
    Cherry Tree Cottage Hearns Lane
    Gallows Tree Common
    RG4 9DE Reading
    Berkshire
    Secretário
    Cherry Tree Cottage Hearns Lane
    Gallows Tree Common
    RG4 9DE Reading
    Berkshire
    British5690880001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Secretário
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    British53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Secretário
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Secretário
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Secretário
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Secretário
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretário
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304900001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretário
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Secretário
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    MURRAY, Karen Mary
    Willerton Trumpsgreen Road
    GU25 4HH Virginia Water
    Surrey
    Secretário
    Willerton Trumpsgreen Road
    GU25 4HH Virginia Water
    Surrey
    British27248850001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Secretário
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Diretor
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    British57906600001
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    Diretor
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish66559170001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BRADEEN, Chester Howard
    Barberry Cottage Cheapside Road
    SL5 7QR Ascot
    Berkshire
    Diretor
    Barberry Cottage Cheapside Road
    SL5 7QR Ascot
    Berkshire
    Us Citizen44958580001
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Diretor
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    COPELAND, Robert Nigel
    Cherry Tree Cottage Hearns Lane
    Gallows Tree Common
    RG4 9DE Reading
    Berkshire
    Diretor
    Cherry Tree Cottage Hearns Lane
    Gallows Tree Common
    RG4 9DE Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish5690880001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    Diretor
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    British14241020001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Diretor
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish53915080001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Diretor
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Diretor
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Diretor
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    British79846610001
    HEAPS, Ann
    8 Oakwood Close
    BL8 1DD Bury
    Lancashire
    Diretor
    8 Oakwood Close
    BL8 1DD Bury
    Lancashire
    British124068050001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Diretor
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    LAWRENCE, Stephen John
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    Diretor
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    EnglandBritish5579020001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Diretor
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MALHAM, Janette
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish91088900004
    MARK, Larry Edward
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    Diretor
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    New Zealander5076900001
    MCINTEER, Warren Hill
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    Diretor
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100131200001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MORETON, John Ernest
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    Diretor
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    New Zealander80392940001
    MOSS, John Rhys
    Bryn Y Gwynt
    Graigfechan
    LL15 2EY Ruthin
    Clwyd
    Diretor
    Bryn Y Gwynt
    Graigfechan
    LL15 2EY Ruthin
    Clwyd
    British36148600001

    ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Supplemental legal mortgage
    Criado em 06/05/2011
    Entregue em 20/05/2011
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Land on the south side of downshaw road ashton-under-lyne t/no GM552182 and 502 to 506 (eben) oldham road ashton-under-lyne t/no GM590569 see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transações
    • 20/05/2011Registro de uma garantia (MG01)
    Deed of accession and charge
    Criado em 21/08/2008
    Entregue em 02/09/2008
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transações
    • 02/09/2008Registro de uma garantia (395)
    Legal charge
    Criado em 02/11/1994
    Entregue em 18/11/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a downshaw lodge oldham road ashton-under-lyne tameside t/nos. Gm 590569, gm 599553, gm 228120, gm 552182 gm 599547 .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Ucb Bank PLC
    Transações
    • 18/11/1994Registro de uma garantia (395)
    • 01/09/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 02/11/1994
    Entregue em 18/11/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Ucb Bank PLC
    Transações
    • 18/11/1994Registro de uma garantia (395)
    • 01/09/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Single debenture
    Criado em 02/11/1992
    Entregue em 13/11/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 13/11/1992Registro de uma garantia (395)
    • 01/09/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 06/12/1990
    Entregue em 13/12/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from exceler health care limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descrição
    F/H property k/a whitby house nursing home pooltown road whitby cheshire t/n ch 239105 with all buildings & fixtures thereon. By way of assignment the goodwill of the business and the full benefit of all present and future licences (see form 395 for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Ucb Bank PLC
    Transações
    • 13/12/1990Registro de uma garantia
    • 14/11/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 12/01/1989
    Entregue em 20/01/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    99 pooltown road ellesmere port south wirral cheshire t/n ch 239105.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 20/01/1989Registro de uma garantia
    • 10/07/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    20/06/2012Data da reunião para aprovar o CVA
    20/08/2012Data de finalização ou terminação do CVA
    Acordo voluntário de reestruturação empresarial (CVA)
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Profissional
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profissional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0