ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 02247801 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED?
- Outras atividades de saúde humana (86900) / Atividades de saúde humana e ação social
Onde fica ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| SUN HEALTHCARE GROUP EUROPE LIMITED | 17/09/1997 | 17/09/1997 |
| POOLTOWN HOME LIMITED | 17/05/1990 | 17/05/1990 |
| SOLDBIND LIMITED | 25/04/1988 | 25/04/1988 |
Quais são as últimas contas de ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 30/09/2010 |
Quais são as últimas submissões para ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretário em 09/10/2012 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Aviso da conclusão do acordo voluntário | 6 páginas | 1.4 | ||||||||||
Término da nomeação de Timothy James Bolot como diretor em 17/08/2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Aviso ao Registo Comercial do acordo voluntário de empresas que entra em vigor | 4 páginas | 1.1 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 15/01/2012 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de William James Buchan como diretor em 15/11/2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de David Andrew Smith como diretor em 01/11/2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Stephen Jonathan Taylor como diretor em 26/10/2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Timothy James Bolot como diretor em 26/10/2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 30/09/2010 | 28 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 7 páginas | MG01 | ||||||||||
Término da nomeação de William Mcleish como secretário | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretário | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 15/01/2011 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Término da nomeação de Richard Midmer como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 27/09/2009 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 15/01/2010 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr David Andrew Smith em 07/01/2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nomeação de Mr David Andrew Smith como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de David Smith como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr David Andrew Smith como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Quem são os diretores de ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Diretor | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| COPELAND, Robert Nigel | Secretário | Cherry Tree Cottage Hearns Lane Gallows Tree Common RG4 9DE Reading Berkshire | British | 5690880001 | ||||||
| FEENEY, Martin | Secretário | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | 53915080001 | ||||||
| FORD, Colin Andrew | Secretário | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
| HURRELL, Steven Alfred | Secretário | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
| KIME, Sean Thomas | Secretário | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| MACFARLANE, Rona Jane | Secretário | 2/2 5 Doune Quadrant G20 6DL Glasgow | British | 62509960001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Secretário | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158304900001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Secretário | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| MURPHY, Charles Furber | Secretário | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | 69603410001 | ||||||
| MURRAY, Karen Mary | Secretário | Willerton Trumpsgreen Road GU25 4HH Virginia Water Surrey | British | 27248850001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Secretário | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| ABLETT, Julie | Diretor | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | 57906600001 | ||||||
| BARLOW, George Edward | Diretor | 41 Nidd Approach LS22 7UJ Wetherby West Yorkshire | England | British | 66559170001 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Diretor | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BRADEEN, Chester Howard | Diretor | Barberry Cottage Cheapside Road SL5 7QR Ascot Berkshire | Us Citizen | 44958580001 | ||||||
| BUCHAN, William James | Diretor | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Diretor | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| COPELAND, Robert Nigel | Diretor | Cherry Tree Cottage Hearns Lane Gallows Tree Common RG4 9DE Reading Berkshire | United Kingdom | British | 5690880001 | |||||
| FARRALL, Elaine Ann | Diretor | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | 14241020001 | ||||||
| FEENEY, Martin | Diretor | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | Scotland | British | 53915080001 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Diretor | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Diretor | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GOSLING, Mark David | Diretor | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| HAMILTON, Thomas Banks | Diretor | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | 79846610001 | ||||||
| HEAPS, Ann | Diretor | 8 Oakwood Close BL8 1DD Bury Lancashire | British | 124068050001 | ||||||
| JAP, Chee Miau | Diretor | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 | |||||
| LAWRENCE, Stephen John | Diretor | The Old Barn Littleton SO22 6QS Winchester Hants | England | British | 5579020001 | |||||
| LOCK, Jason David | Diretor | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MALHAM, Janette | Diretor | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 91088900004 | |||||
| MARK, Larry Edward | Diretor | 29 Cedar Drive SL5 0UA Sunningdale Berkshire | New Zealander | 5076900001 | ||||||
| MCINTEER, Warren Hill | Diretor | 11 Thorn Road Bearsden G61 4PP Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 100131200001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Diretor | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 110640170001 | |||||
| MORETON, John Ernest | Diretor | The Old Farm Winkfield Row RG12 6NG Reading Berkshire | New Zealander | 80392940001 | ||||||
| MOSS, John Rhys | Diretor | Bryn Y Gwynt Graigfechan LL15 2EY Ruthin Clwyd | British | 36148600001 |
ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental legal mortgage | Criado em 06/05/2011 Entregue em 20/05/2011 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Land on the south side of downshaw road ashton-under-lyne t/no GM552182 and 502 to 506 (eben) oldham road ashton-under-lyne t/no GM590569 see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of accession and charge | Criado em 21/08/2008 Entregue em 02/09/2008 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 02/11/1994 Entregue em 18/11/1994 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H property k/a downshaw lodge oldham road ashton-under-lyne tameside t/nos. Gm 590569, gm 599553, gm 228120, gm 552182 gm 599547 .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Mortgage debenture | Criado em 02/11/1994 Entregue em 18/11/1994 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Single debenture | Criado em 02/11/1992 Entregue em 13/11/1992 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 06/12/1990 Entregue em 13/12/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from exceler health care limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descrição F/H property k/a whitby house nursing home pooltown road whitby cheshire t/n ch 239105 with all buildings & fixtures thereon. By way of assignment the goodwill of the business and the full benefit of all present and future licences (see form 395 for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 12/01/1989 Entregue em 20/01/1989 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição 99 pooltown road ellesmere port south wirral cheshire t/n ch 239105. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
ASHBOURNE GROUP EUROPE LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Acordo voluntário de reestruturação empresarial (CVA) |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0