CORE DESIGN LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCORE DESIGN LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02257936
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CORE DESIGN LIMITED?

    • Edição de jogos de computador (58210) / Informação e comunicação

    Onde fica CORE DESIGN LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o SQUARE ENIX LTD
    240 Blackfriars Road, 12 & 13th Floors
    SE1 8NW London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CORE DESIGN LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    MEGABRITE LIMITED13/05/198813/05/1988

    Quais são as últimas contas de CORE DESIGN LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2016

    Quais são as últimas submissões para CORE DESIGN LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2016

    6 páginasAA

    Declaração anual preparada até 10/01/2016 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/02/2016

    Estado do capital em 02/02/2016

    • Capital: GBP 9,010
    SH01

    Detalhes do secretário alterados para Mr Amit Chokshi em 07/01/2016

    1 páginasCH03

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2015

    6 páginasAA

    Nomeação de Mr Amit Chokshi como secretário em 14/05/2015

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Chantal Reid como secretário em 14/05/2015

    1 páginasTM02

    Declaração anual preparada até 10/01/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital15/01/2015

    Estado do capital em 15/01/2015

    • Capital: GBP 9,010
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2014

    6 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Square Enix Ltd Wimbledon Bridge House 1 Hartfield Road London SW19 3RU para C/O Square Enix Ltd 240 Blackfriars Road, 12 & 13Th Floors London SE1 8NW em 17/09/2014

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 10/01/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital30/01/2014

    Estado do capital em 30/01/2014

    • Capital: GBP 9,010
    SH01

    Nomeação de Chantal Reid como secretário

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Jonathan Ball como secretário

    1 páginasTM02

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/03/2013

    3 páginasAA

    Declaração anual preparada até 10/01/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Término da nomeação de Anthony Price como diretor

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2012

    6 páginasAA

    Declaração anual preparada até 10/01/2012 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2011

    6 páginasAA

    Declaração anual preparada até 10/01/2011 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2010

    6 páginasAA

    Detalhes do secretário alterados para Jonathan Andre Stoner Ball em 14/07/2010

    3 páginasCH03

    Término da nomeação de Robert Brent como diretor

    2 páginasTM01

    Quem são os diretores de CORE DESIGN LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CHOKSHI, Amit
    c/o Square Enix Ltd
    Blackfriars Road, 12 & 13th Floors
    SE1 8NW London
    240
    Secretário
    c/o Square Enix Ltd
    Blackfriars Road, 12 & 13th Floors
    SE1 8NW London
    240
    197961520001
    ROGERS, Philip Timo
    Upper Red Cross Road
    RG8 9BT Goring On Thames
    Green Court
    Oxfordshire
    Diretor
    Upper Red Cross Road
    RG8 9BT Goring On Thames
    Green Court
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director102536020002
    ARNAOUTI, Michael
    87 Ditton Road
    KT6 6RJ Surbiton
    Surrey
    Secretário
    87 Ditton Road
    KT6 6RJ Surbiton
    Surrey
    British539040004
    BALL, Jonathan Andre Stoner
    Huntsham
    EX16 7QH Tiverton
    Three Gates Farm
    Devon
    Secretário
    Huntsham
    EX16 7QH Tiverton
    Three Gates Farm
    Devon
    British41360300003
    BROWN, Norman Cecil
    21 Amington Close
    Four Oaks
    B75 5UB Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secretário
    21 Amington Close
    Four Oaks
    B75 5UB Sutton Coldfield
    West Midlands
    British3331990001
    HEATH-SMITH, Tracey Victoria
    12 Cavendish Avenue
    Dore
    S17 3NJ Sheffield
    South Yorkshire
    Secretário
    12 Cavendish Avenue
    Dore
    S17 3NJ Sheffield
    South Yorkshire
    British40707310002
    NORBURN, Kevin George
    Rose Cottage Derby Road
    Old Tupton
    S42 6LA Chesterfield
    Derbyshire
    Secretário
    Rose Cottage Derby Road
    Old Tupton
    S42 6LA Chesterfield
    Derbyshire
    British22199830001
    PRICE, Anthony John
    133 Lauderdale Tower
    Barbican
    EC2Y 8BY London
    Secretário
    133 Lauderdale Tower
    Barbican
    EC2Y 8BY London
    British107892990001
    REID, Chantal
    Baldslow Road
    TN34 2EZ Hastings
    Hilton House
    East Sussex
    England
    Secretário
    Baldslow Road
    TN34 2EZ Hastings
    Hilton House
    East Sussex
    England
    183741910001
    ALDWYCH SECRETARIES LIMITED
    6th Floor
    81 Aldwych
    WC2B 4RP London
    Secretário
    6th Floor
    81 Aldwych
    WC2B 4RP London
    4238520001
    ADAMS, David Alexander Robertson
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    Diretor
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    EnglandBritishAccountant55757700003
    BARCLAY, Richard John
    9 Bushfield Road
    Albrighton
    WV7 3PE Wolverhampton
    Shropshire
    Diretor
    9 Bushfield Road
    Albrighton
    WV7 3PE Wolverhampton
    Shropshire
    BritishMarketing Executive33102730001
    BRENT, Robert Charles
    Hoadly Road
    SW16 1AF London
    10
    Diretor
    Hoadly Road
    SW16 1AF London
    10
    EnglandBritishCompany Director133037640001
    BROWN, Geoffrey William
    Bradfield House
    Rising Lane
    B94 6HP Lapworth
    Warwickshire
    Diretor
    Bradfield House
    Rising Lane
    B94 6HP Lapworth
    Warwickshire
    BritishCompany Director5353520002
    CAVANAGH, Fiona Jane
    16 Woodborough Road
    Putney
    SW15 6PZ London
    Diretor
    16 Woodborough Road
    Putney
    SW15 6PZ London
    EnglandBritishDirector12436320002
    CORNWALL, Charles Henry
    Flat 3 25 Stanhope Gardens
    SW7 5QX London
    Diretor
    Flat 3 25 Stanhope Gardens
    SW7 5QX London
    BritishCeo34733180002
    CRUICKSHANK, Stuart
    13 Gloucester Road
    W5 4JB London
    Diretor
    13 Gloucester Road
    W5 4JB London
    EnglandBritishAccountant114599790001
    ENNIS, Bryan Joseph
    16 Woodborough Road
    Putney
    SW15 6PZ London
    Diretor
    16 Woodborough Road
    Putney
    SW15 6PZ London
    EnglandBritishDirector48558000002
    GORDON, Sharon Beverley
    1 High Street
    OX6 9JJ Souldern
    Oxfordshire
    Diretor
    1 High Street
    OX6 9JJ Souldern
    Oxfordshire
    BritishSales Director37779820002
    HEATH SMITH, Jeremy
    37 Links Road
    Lower Parkstone
    BH14 9QS Poole
    Dorset
    Diretor
    37 Links Road
    Lower Parkstone
    BH14 9QS Poole
    Dorset
    BritishDirector107355120001
    LEES, Jonathon
    26 Huntsmans Meadow
    SL5 7PF Ascot
    Berkshire
    Diretor
    26 Huntsmans Meadow
    SL5 7PF Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director52330160001
    LEWIS, Jeremy Michael James
    5 Ruvigny Gardens
    SW15 1JR London
    Diretor
    5 Ruvigny Gardens
    SW15 1JR London
    EnglandBritishCompany Director142203850001
    LIVINGSTONE, Ian, Sir
    2 Scarth Road
    Barnes
    SW13 0ND London
    Diretor
    2 Scarth Road
    Barnes
    SW13 0ND London
    EnglandBritishExec Chairman48915460004
    MCGARVEY, Michael Patrick
    38 Roehampton Gate
    SW15 5JS London
    Diretor
    38 Roehampton Gate
    SW15 5JS London
    AmericanBusiness Man55486370003
    MURPHY, Robert John
    1 Warmington Road
    SE24 9LA London
    Diretor
    1 Warmington Road
    SE24 9LA London
    United KingdomEnglishChartered Accountant52529860004
    NORBURN, Kevin George
    Rose Cottage Derby Road
    Old Tupton
    S42 6LA Chesterfield
    Derbyshire
    Diretor
    Rose Cottage Derby Road
    Old Tupton
    S42 6LA Chesterfield
    Derbyshire
    BritishDirector22199830001
    PRICE, Anthony John
    133 Lauderdale Tower
    Barbican
    EC2Y 8BY London
    Diretor
    133 Lauderdale Tower
    Barbican
    EC2Y 8BY London
    United KingdomBritishCompany Secretary107892990001
    SMITH, Adrian Emmett
    The Old Hall
    Bleasby
    NG14 7FU Nottingham
    Nottinghamshire
    Diretor
    The Old Hall
    Bleasby
    NG14 7FU Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishOperations Manager100729980001
    STEEL, Victor John
    Heath Corner
    Rough Road
    GU22 0RB Woking
    Surrey
    Diretor
    Heath Corner
    Rough Road
    GU22 0RB Woking
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director46804230002
    VAN KUFFELER, John Philip De Blocq
    Little Chester Street
    SW1X 7AL London
    5
    Diretor
    Little Chester Street
    SW1X 7AL London
    5
    United KingdomNetherlandsCompany Director91594040001

    CORE DESIGN LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Supplemental debenture
    Criado em 25/04/2008
    Entregue em 29/04/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transações
    • 29/04/2008Registro de uma garantia (395)
    • 28/05/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 31/01/2008
    Entregue em 11/02/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Finance Parties)
    Transações
    • 11/02/2008Registro de uma garantia (395)
    • 28/05/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 05/05/2006
    Entregue em 09/05/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 09/05/2006Registro de uma garantia (395)
    • 08/02/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge of intellectual property
    Criado em 02/05/2006
    Entregue em 04/05/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of first fixed charge trademarks,. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 04/05/2006Registro de uma garantia (395)
    • 08/02/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 14/03/2005
    Entregue em 24/03/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any chargor to the lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 24/03/2005Registro de uma garantia (395)
    • 07/09/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating security document dated 3RD august 2000 which by an amendment and restatement agreement dated 31ST may 2001 the company acknowledged that the security document would continue to apply to a loan agreement dated 3RD august 2000 as amended by the amendment and restatement agreement
    Criado em 31/05/2001
    Entregue em 19/06/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any finance document (as defined therein)
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 19/06/2001Registro de uma garantia (395)
    • 07/09/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Criado em 03/08/2000
    Entregue em 18/08/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any finance document (as defined therein)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 18/08/2000Registro de uma garantia (395)
    • 07/09/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Criado em 11/11/1999
    Entregue em 22/11/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any finance document (as defined)
    Breve descrição
    The property trademark core country UK application/registration no 1475768 status registered trademark core country UK application/registration no.2202100 Status uncertain book debts uncalled capital and goodwill for further details of property see ch microfiche. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transações
    • 22/11/1999Registro de uma garantia (395)
    • 09/12/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Assignment and charge
    Criado em 10/10/1995
    Entregue em 27/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies obligations and liabilites due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of an assignment and charge of even date
    Breve descrição
    Assigns absolutely to the bank :- the copyright all causes of action and by way of fixed charge all intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 27/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 09/12/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 21/09/1995
    Entregue em 03/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 03/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 09/12/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 05/06/1995
    Entregue em 07/06/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 07/06/1995Registro de uma garantia (395)
    • 21/02/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deposit agreement
    Criado em 11/10/1993
    Entregue em 15/10/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made all debts owing to the company on account with lloyds bank PLC re core design limited designated premier interest account and numbered 7125289 as a fixed charge.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 15/10/1993Registro de uma garantia (395)
    • 04/04/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 03/08/1990
    Entregue em 22/08/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lesley Barnes
    Transações
    • 22/08/1990Registro de uma garantia
    • 19/10/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 25/01/1990
    Entregue em 07/02/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    And heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 07/02/1990Registro de uma garantia
    • 28/03/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0