BMBF (NO.12) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaBMBF (NO.12) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02259175
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de BMBF (NO.12) LIMITED?

    • Arrendamento financeiro (64910) / Atividades financeiras e de seguros

    Onde fica BMBF (NO.12) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Hill House 1
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de BMBF (NO.12) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2015

    Quais são as últimas submissões para BMBF (NO.12) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    12 páginasLIQ13

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de 1 Churchill Place London E14 5HP para Barclays Group Archives Dallimore Road Wythenshawe Manchester M23 9JA

    2 páginasAD02

    Endereço do domicílio registado alterado de , 1 Churchill Place, London, E14 5HP, England para Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR em 16/05/2017

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 27/04/2017

    LRESSP

    Declaração de confirmação apresentada em 01/03/2017 com atualizações

    6 páginasCS01

    Os registos foram transferidos para o endereço do domicílio registado 1 Churchill Place London E14 5HP

    1 páginasAD04

    Endereço do domicílio registado alterado de , Churchill Plaza, Churchill Way, Basingstoke, Hampshire, RG21 7GP para Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR em 19/09/2016

    1 páginasAD01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    28 páginasAA

    Declaração anual preparada até 01/06/2016 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital24/06/2016

    Estado do capital em 24/06/2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomeação de Mr Vukkalam Rangaswami Praveen Kumar como diretor em 20/05/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Ketan Dhirendra Merchant como diretor em 16/02/2016

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Jonathan Terence Leather como diretor em 23/11/2015

    2 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    34 páginasAA

    Nomeação de Mr Ketan Dhirendra Merchant como diretor em 12/08/2015

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 01/08/2015 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital12/08/2015

    Estado do capital em 12/08/2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Declaração anual preparada até 01/05/2015 com lista completa de acionistas

    8 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital12/05/2015

    Estado do capital em 12/05/2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    32 páginasAA

    Nomeação de David Charles Hawkins como diretor

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 01/05/2014 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital16/05/2014

    Estado do capital em 16/05/2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Término da nomeação de Andrew Asquith como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Andrew Martin Granville Asquith como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Duncan Rowberry como diretor

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de BMBF (NO.12) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Secretário
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    BOLTON, Stephen Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish177906520001
    HAWKINS, David Charles
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish188138870001
    KUMAR, Vukkalam Rangaswami Praveen
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    IndiaIndian207316480001
    OTTAWAY, Angela Nicole
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish169152200001
    LEATHER, Jonathan Terence
    57 The Crofts
    Hatch Warren
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    Secretário
    57 The Crofts
    Hatch Warren
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    British69140360001
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Secretário
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    ABLITT, Denis Raymond
    Woodcocks
    38 Park Avenue, Old Basing
    RG24 7HT Basingstoke
    Hampshire
    Diretor
    Woodcocks
    38 Park Avenue, Old Basing
    RG24 7HT Basingstoke
    Hampshire
    British71782000001
    ASQUITH, Andrew Martin Granville
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish77784310001
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Diretor
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Diretor
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Diretor
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    CALVERT, Ashley
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish166501700001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Diretor
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    British5529800001
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Diretor
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Diretor
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    EVANS, Christopher Hewitt
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British121774150001
    HARE, Darren Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish127470250001
    HASSELL, Brian Charles
    10 Blenheim Close
    CM21 0BE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Diretor
    10 Blenheim Close
    CM21 0BE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Great BritainBritish45384250002
    HILLS, Richard Allan
    11 Countess Gardens
    Littledown
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    Diretor
    11 Countess Gardens
    Littledown
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritish71778800001
    LEATHER, Jonathan Terence
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish69140360004
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Diretor
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    British25737780001
    MARCHANT, Jeremy
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish154144600001
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British68601920003
    MERCHANT, Ketan Dhirendra
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    IndiaIndian200060960001
    MILES, Martin Graham
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish108439150001
    RIDOUT, Thomas Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish155056490001
    ROSE, Stephen George
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British143870380001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Diretor
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish49237880004
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Diretor
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    British32895910001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Diretor
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandIrish122291210001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Diretor
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Diretor
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Diretor
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001

    Quem são as pessoas com controle significativo de BMBF (NO.12) LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    06/04/2016
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland & Wales
    Autoridade legalEngland And Wales
    Local de registroCompanies House
    Número de registro898129
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    BMBF (NO.12) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A first preferred vanuatu ship mortgage
    Criado em 16/04/2004
    Entregue em 26/04/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Right title and interest in and to the vessel. (Motor vessel 'gsf jack ryan' registered under the vanuatu flag with official number 1561). see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Globalsantafe International Drilling Corporation
    Transações
    • 26/04/2004Registro de uma garantia (395)
    • 01/12/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Account assignment schedule no:52/5050 5371-3
    Criado em 22/01/2001
    Entregue em 25/01/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The obligations of the company to make payment to the chargee of any and all moneys by way of rebate of rental in accordance with clauses 10.2 and 20.2 of the lease (as defined)
    Breve descrição
    The account which means the account of the company withe the account bank with account number 10353817 and designated "global marine inc.,glomar jack ryan" and the amount standing to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Global Marine International Drilling Corporation
    Transações
    • 25/01/2001Registro de uma garantia (395)
    • 01/12/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    First preferred panamanian naval mortgage
    Criado em 26/10/2000
    Entregue em 10/11/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee to effect a transfer of title to the vessel being the M.V. "glomar jack ryan" under any sale contract entered into in accordance with clause 19.2 of the head lease being a lease agreement dated 8TH december 1998 between the company and chargee in respect of the vessel and all moneys by way of rebate of rental under clause 20.2 of said head lease
    Breve descrição
    All the company's right title benefit and interest in and to the vessel in accordance with the provisions of chapter v title iv of book second of the code of commerce of the republic of panama.
    Pessoas com direito
    • Global Marine International Drilling Corporation
    Transações
    • 10/11/2000Registro de uma garantia (395)
    • 01/12/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Secondary lease security assignment
    Criado em 30/12/1992
    Entregue em 13/01/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due from i/s oktober-gruppen and /or kim F. rasmussen under the terms of the loan agreement dated 30/12/92
    Breve descrição
    All th elessees right title interest in and to the assigned payments.see form 395 for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 13/01/1993Registro de uma garantia (395)
    • 15/09/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Sublessee security agreement
    Criado em 30/12/1992
    Entregue em 14/01/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sublease dated and the head lease both dated 24/11/92
    Breve descrição
    All rights title interest in and to the head lease and head security agreement.see form 395 for full details.
    Pessoas com direito
    • Triborough Bridge and Tunnel Authority
    Transações
    • 14/01/1993Registro de uma garantia (395)
    • 25/09/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    BMBF (NO.12) LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    2
    DataTipo
    27/04/2017Início da liquidação
    22/11/2017Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Ian Harvey Dean
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Profissional
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profissional
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0