BMBF (NO.12) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | BMBF (NO.12) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 02259175 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de BMBF (NO.12) LIMITED?
- Arrendamento financeiro (64910) / Atividades financeiras e de seguros
Onde fica BMBF (NO.12) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de BMBF (NO.12) LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2015 |
Quais são as últimas submissões para BMBF (NO.12) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 12 páginas | LIQ13 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado de 1 Churchill Place London E14 5HP para Barclays Group Archives Dallimore Road Wythenshawe Manchester M23 9JA | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de , 1 Churchill Place, London, E14 5HP, England para Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR em 16/05/2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Declaração de solvência | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/03/2017 com atualizações | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Os registos foram transferidos para o endereço do domicílio registado 1 Churchill Place London E14 5HP | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de , Churchill Plaza, Churchill Way, Basingstoke, Hampshire, RG21 7GP para Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR em 19/09/2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2015 | 28 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/06/2016 com lista completa de acionistas | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Mr Vukkalam Rangaswami Praveen Kumar como diretor em 20/05/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Ketan Dhirendra Merchant como diretor em 16/02/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Jonathan Terence Leather como diretor em 23/11/2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2014 | 34 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mr Ketan Dhirendra Merchant como diretor em 12/08/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/08/2015 com lista completa de acionistas | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração anual preparada até 01/05/2015 com lista completa de acionistas | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2013 | 32 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de David Charles Hawkins como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/05/2014 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de Andrew Asquith como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Andrew Martin Granville Asquith como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Duncan Rowberry como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Quem são os diretores de BMBF (NO.12) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCOSEC LIMITED | Secretário | 1 Churchill Place E14 5HP London | 49004930002 | |||||||
| BOLTON, Stephen Geoffrey | Diretor | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 177906520001 | |||||
| HAWKINS, David Charles | Diretor | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 188138870001 | |||||
| KUMAR, Vukkalam Rangaswami Praveen | Diretor | Churchill Place E14 5HP London 1 England | India | Indian | 207316480001 | |||||
| OTTAWAY, Angela Nicole | Diretor | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 169152200001 | |||||
| LEATHER, Jonathan Terence | Secretário | 57 The Crofts Hatch Warren RG22 4RE Basingstoke Hampshire | British | 69140360001 | ||||||
| SHOOLBRED, Charles Frederick | Secretário | Timbers Dean Oak Lane RH2 8PZ Leigh Surrey | British | 540290002 | ||||||
| ABLITT, Denis Raymond | Diretor | Woodcocks 38 Park Avenue, Old Basing RG24 7HT Basingstoke Hampshire | British | 71782000001 | ||||||
| ASQUITH, Andrew Martin Granville | Diretor | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 77784310001 | |||||
| BOOBYER, Christopher Leslie Richard | Diretor | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 92233050001 | ||||||
| BOX, Sarah | Diretor | Court Lodge Lower Road West Farleigh ME15 0PD Maidstone Kent | British | 47381630004 | ||||||
| CALLENDER, John Dalrymple | Diretor | Fairway Heights GU15 1NJ Camberley 14 Surrey | United Kingdom | British | 2444200001 | |||||
| CALVERT, Ashley | Diretor | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 166501700001 | |||||
| CLARK, Thomas Martin | Diretor | Hatch Hill Hatch Lane Kingsley Green GU27 3LJ Haslemere Surrey | British | 5529800001 | ||||||
| DOWDING, Eric Robert | Diretor | 23 Waldorf Heights Blackwater Howley Hill GU17 9JH Camberley Surrey | British | 46728970001 | ||||||
| ELLIS, David James | Diretor | Batts Row Cottage Laverstoke Lane, Laverstoke RG28 7PA Whitchurch Hampshire | England | British | 113760650001 | |||||
| EVANS, Christopher Hewitt | Diretor | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 121774150001 | ||||||
| HARE, Darren Mark | Diretor | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 127470250001 | |||||
| HASSELL, Brian Charles | Diretor | 10 Blenheim Close CM21 0BE Sawbridgeworth Hertfordshire | Great Britain | British | 45384250002 | |||||
| HILLS, Richard Allan | Diretor | 11 Countess Gardens Littledown BH7 7RR Bournemouth Dorset | United Kingdom | British | 71778800001 | |||||
| LEATHER, Jonathan Terence | Diretor | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | British | 69140360004 | |||||
| MACINTOSH, Gordon Paterson | Diretor | 7 Paddock Field Chilbolton SO20 6AU Stockbridge Hampshire | British | 25737780001 | ||||||
| MARCHANT, Jeremy | Diretor | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 154144600001 | |||||
| MCMILLAN, Richard John | Diretor | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 68601920003 | ||||||
| MERCHANT, Ketan Dhirendra | Diretor | Churchill Place E14 5HP London 1 England | India | Indian | 200060960001 | |||||
| MILES, Martin Graham | Diretor | 1 Churchill Place E14 5HP London | United Kingdom | British | 108439150001 | |||||
| RIDOUT, Thomas Geoffrey | Diretor | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 155056490001 | |||||
| ROSE, Stephen George | Diretor | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 143870380001 | ||||||
| ROWAN, Charles Paul | Diretor | 32 Queens Park West Drive Queens Park BH8 9DD Bournemouth Dorset | British | 49237910001 | ||||||
| ROWBERRY, Duncan John | Diretor | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | British | 49237880004 | |||||
| SILCOCK, Frank Avis | Diretor | Charleston 74 Wellhouse Road Beech GU34 4AG Alton Hampshire | British | 32895910001 | ||||||
| WATSON, Hazel Anne Marie | Diretor | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | Irish | 122291210001 | |||||
| WEAL, Barry | Diretor | Orchard Gate Mill Lane Bramley GU5 0HW Guildford Surrey | British | 40203100001 | ||||||
| WEAVING, John Martin | Diretor | 57 Bridle Way Colehill BH21 2UP Wimborne Dorset | British | 58523120001 | ||||||
| BARCOSEC LIMITED | Diretor | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 49004930001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de BMBF (NO.12) LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays Mercantile Business Finance Limited | 06/04/2016 | Churchill Place E14 5HP London 1 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
BMBF (NO.12) LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A first preferred vanuatu ship mortgage | Criado em 16/04/2004 Entregue em 26/04/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Right title and interest in and to the vessel. (Motor vessel 'gsf jack ryan' registered under the vanuatu flag with official number 1561). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Account assignment schedule no:52/5050 5371-3 | Criado em 22/01/2001 Entregue em 25/01/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido The obligations of the company to make payment to the chargee of any and all moneys by way of rebate of rental in accordance with clauses 10.2 and 20.2 of the lease (as defined) | |
Breve descrição The account which means the account of the company withe the account bank with account number 10353817 and designated "global marine inc.,glomar jack ryan" and the amount standing to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| First preferred panamanian naval mortgage | Criado em 26/10/2000 Entregue em 10/11/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee to effect a transfer of title to the vessel being the M.V. "glomar jack ryan" under any sale contract entered into in accordance with clause 19.2 of the head lease being a lease agreement dated 8TH december 1998 between the company and chargee in respect of the vessel and all moneys by way of rebate of rental under clause 20.2 of said head lease | |
Breve descrição All the company's right title benefit and interest in and to the vessel in accordance with the provisions of chapter v title iv of book second of the code of commerce of the republic of panama. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Secondary lease security assignment | Criado em 30/12/1992 Entregue em 13/01/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due from i/s oktober-gruppen and /or kim F. rasmussen under the terms of the loan agreement dated 30/12/92 | |
Breve descrição All th elessees right title interest in and to the assigned payments.see form 395 for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Sublessee security agreement | Criado em 30/12/1992 Entregue em 14/01/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sublease dated and the head lease both dated 24/11/92 | |
Breve descrição All rights title interest in and to the head lease and head security agreement.see form 395 for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
BMBF (NO.12) LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0