NEURO THERAPY CENTRE LTD

NEURO THERAPY CENTRE LTD

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Declarações de pessoas com controle significativo
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaNEURO THERAPY CENTRE LTD
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada por garantia sem capital social
    Número da empresa 02269526
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosNão
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de NEURO THERAPY CENTRE LTD?

    • Atividades de trabalho social sem alojamento para idosos e pessoas com deficiência (88100) / Atividades de saúde humana e ação social

    Onde fica NEURO THERAPY CENTRE LTD?

    Endereço do escritório registrado
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de NEURO THERAPY CENTRE LTD?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    MULTIPLE SCLEROSIS SUPPORT CENTRE LTD19/05/199319/05/1993
    CHESTER AND NORTH WALES FRIENDS OF ARMS LIMITED21/06/198821/06/1988

    Quais são as últimas contas de NEURO THERAPY CENTRE LTD?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/03/2025
    Próximas contas vencem em31/12/2025
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2024

    Qual é o status da última declaração de confirmação para NEURO THERAPY CENTRE LTD?

    Última declaração de confirmação elaborada até21/06/2025
    Próxima declaração de confirmação vence05/07/2025
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até21/06/2024
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para NEURO THERAPY CENTRE LTD?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Término da nomeação de Barbara Mary Burke como diretor em 29/10/2024

    1 páginasTM01

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2024

    38 páginasAA

    Nomeação de Mr Paul Crossland como diretor em 11/09/2024

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Michael Lawrence Sayer Martin como diretor em 11/09/2024

    2 páginasAP01

    Nomeação de Dr David James Purdell-Lewis como diretor em 11/09/2024

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 21/06/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Michael George Dennis Robinson como diretor em 25/03/2024

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Norman Charles Holladay como diretor em 14/09/2023

    2 páginasAP01

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2023

    39 páginasAA

    Término da nomeação de Joanne Louise Perry como diretor em 15/08/2023

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Joanne Louise Perry como secretário em 15/08/2023

    1 páginasTM02

    Declaração de confirmação apresentada em 21/06/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Christopher Jones como diretor em 08/01/2023

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Derek William Sanders em 19/10/2022

    2 páginasCH01

    Nomeação de Dr Hilary Harris como diretor em 14/09/2022

    2 páginasAP01

    Contas de isenção total preparadas até 31/03/2022

    36 páginasAA

    Término da nomeação de Edward Leslie Rose como diretor em 08/07/2022

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 21/06/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Jane Elizabeth Hubbard como diretor em 07/02/2022

    1 páginasTM01

    Memorando e estatutos

    28 páginasMA

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Company business 20/08/2021
    RES13

    Término da nomeação de Justin Clayton como diretor em 16/09/2021

    1 páginasTM01

    Memorando e estatutos

    28 páginasMA

    Memorando e estatutos

    25 páginasMA

    Quem são os diretores de NEURO THERAPY CENTRE LTD?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BRIERLEY, John
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Diretor
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    EnglandBritishRetired163516390001
    CROSSLAND, Paul
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Diretor
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    United KingdomBritishRetired159003240002
    DODD, Lorraine Antonia Carrol
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Diretor
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    United KingdomBritishRetired12179800004
    ECCLESTON, Louise
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Diretor
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    United KingdomBritishSolicitor170418950001
    HARRIS, Hilary, Dr
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Diretor
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    EnglandBritishRetired199773420001
    HOLLADAY, Norman Charles
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Diretor
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    United KingdomBritishRetired136424810001
    MARTIN, Michael Lawrence Sayer
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Diretor
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    United KingdomBritishRetired179738090001
    POWELL, Deborah Jane
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Diretor
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    EnglandBritishDirector288170760001
    PURDELL-LEWIS, David James, Dr
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Diretor
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    United KingdomBritishRetired120915810001
    SANDERS, Derek William
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Diretor
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    WalesBritishRetired262332410002
    ANSON, Jacqui
    2 Shaw Lane
    Greasby
    L49 3PD Wirral
    Merseyside
    Secretário
    2 Shaw Lane
    Greasby
    L49 3PD Wirral
    Merseyside
    British10086830001
    COOKSON, Helen Andrea
    7 Dale Road
    Aston Park
    CH5 1XE Queensferry
    Flintshire
    Secretário
    7 Dale Road
    Aston Park
    CH5 1XE Queensferry
    Flintshire
    BritishRetired Information Officer39685100002
    GREENLEES, Philip Alan
    87 Parc Hendy
    CH7 1TT Mold
    Flintshire
    Secretário
    87 Parc Hendy
    CH7 1TT Mold
    Flintshire
    BritishRetired Local Govt Officer10086860001
    KEMSLEY, Neil
    Yewtree Farmhouse
    Wet Lane Tilston
    SY14 7DR Malpas
    Cheshire
    Secretário
    Yewtree Farmhouse
    Wet Lane Tilston
    SY14 7DR Malpas
    Cheshire
    British41064330002
    MERRY, Alexander John
    Springfield Court
    Gresford
    LL12 8HY Wrexham
    14
    Wales
    Secretário
    Springfield Court
    Gresford
    LL12 8HY Wrexham
    14
    Wales
    271222960001
    PERRY, Joanne Louise
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Secretário
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    275106600001
    SMITHSON, Alison Mary
    Yew Tree Farmhouse Wet Lane
    Tilston
    SY14 7DR Malpas
    Cheshire
    Secretário
    Yew Tree Farmhouse Wet Lane
    Tilston
    SY14 7DR Malpas
    Cheshire
    BritishRetired Bank Of England Offici58756030001
    TAYLOR, John Allan
    15 Sebring Avenue
    Northop Hall
    CH7 6NP Mold
    Flintshire
    Secretário
    15 Sebring Avenue
    Northop Hall
    CH7 6NP Mold
    Flintshire
    BritishRetired Service Man21663700001
    ANSON, Jacqui
    2 Shaw Lane
    Greasby
    L49 3PD Wirral
    Merseyside
    Diretor
    2 Shaw Lane
    Greasby
    L49 3PD Wirral
    Merseyside
    BritishCivil Servant10086830001
    BATEMAN, David
    10 Maes Derwen
    LL18 2YH Rhuddlan
    Denbighshire
    Diretor
    10 Maes Derwen
    LL18 2YH Rhuddlan
    Denbighshire
    BritishRetired99102130001
    BELL, Michael
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Diretor
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    WalesBritishRetired189414480001
    BURKE, Barbara Mary
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Diretor
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    EnglandBritishRetired53037110001
    CLAYTON, Justin
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Diretor
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    EnglandBritishHead Of Hr242875840001
    COOKSON, Helen Andrea
    7 Dale Road
    Aston Park
    CH5 1XE Queensferry
    Flintshire
    Diretor
    7 Dale Road
    Aston Park
    CH5 1XE Queensferry
    Flintshire
    BritishRetired Information Officer39685100002
    COONEY, David Anthony
    Keepers Road
    Grappenhall
    WA4 3HD Warrington
    7
    United Kingdom
    Diretor
    Keepers Road
    Grappenhall
    WA4 3HD Warrington
    7
    United Kingdom
    UkBritishSolicitor132702160002
    COOPER, Christina Margaret
    Bryn Derw 63 Megs Lane
    CH7 2AG Buckley
    Clwyd
    Diretor
    Bryn Derw 63 Megs Lane
    CH7 2AG Buckley
    Clwyd
    British10086840001
    COOPER, John
    Bryn Derw 63 Megs Lane
    CH7 2AG Buckley
    Flintshire
    Diretor
    Bryn Derw 63 Megs Lane
    CH7 2AG Buckley
    Flintshire
    WalesBritishPlant Manager10086850001
    DAINES, Ann
    84 Allington Place
    Handbridge
    CH4 7DY Chester
    Cheshire
    Diretor
    84 Allington Place
    Handbridge
    CH4 7DY Chester
    Cheshire
    BritishRetired99101940001
    DAKIN, Catherine Mary
    30 Exeter Road
    CH65 8AW Ellesmere Port
    Cheshire
    Diretor
    30 Exeter Road
    CH65 8AW Ellesmere Port
    Cheshire
    United KingdomBritishPhysiotherapist72950370001
    EDWARDS, Ann
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Diretor
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    EnglandBritishRetired163511080001
    EVANS, John Gerwyn
    5 Woodlands
    LL31 9HB Llandudno Junction
    Conway
    Diretor
    5 Woodlands
    LL31 9HB Llandudno Junction
    Conway
    BritishRetired58755500001
    FAULKNER, Michael Frederick
    Brierscroft The Street
    Mickle Trafford
    CH2 4EP Chester
    Cheshire
    Diretor
    Brierscroft The Street
    Mickle Trafford
    CH2 4EP Chester
    Cheshire
    United KingdomBritishRetired90444390001
    FAULKNER, Wendy
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    Diretor
    Unit C4 Brymau One Estate
    River Lane
    CH4 8RG Saltney
    Chester
    United KingdomBritishRetired242657750001
    FORGIE, Geoff
    The Old Barn
    Llwyntidmon Mill Maesbrook
    SY10 8QD Oswestry
    Shropshire
    Diretor
    The Old Barn
    Llwyntidmon Mill Maesbrook
    SY10 8QD Oswestry
    Shropshire
    BritishRetired106031280001
    GREENLEES, Barry
    3 Christopher Drive
    CH62 0DA Wirral
    Merseyside
    Diretor
    3 Christopher Drive
    CH62 0DA Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritishRetired64817320001

    Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para NEURO THERAPY CENTRE LTD?

    Declarações de pessoas com controle significativo
    Notificado emCessado emDeclaração
    11/07/2017A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa.

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0