EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED

EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaEXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02276013
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?

    • Outras atividades de saúde humana (86900) / Atividades de saúde humana e ação social

    Onde fica EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    APTA HEALTHCARE (NOTTINGHAM) LIMITED03/01/199503/01/1995
    REALCARE HOMES LIMITED21/11/198821/11/1988
    RIMFORGE LIMITED11/07/198811/07/1988

    Quais são as últimas contas de EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2010

    Quais são as últimas submissões para EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Término da nomeação de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretário em 09/10/2012

    1 páginasTM02

    Aviso da conclusão do acordo voluntário

    6 páginas1.4

    Término da nomeação de Timothy James Bolot como diretor em 17/08/2012

    1 páginasTM01

    Aviso ao Registo Comercial do acordo voluntário de empresas que entra em vigor

    4 páginas1.1

    Declaração anual preparada até 15/01/2012 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital18/01/2012

    Estado do capital em 18/01/2012

    • Capital: GBP 4,000,000
    SH01

    Término da nomeação de William James Buchan como diretor em 15/11/2011

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de David Andrew Smith como diretor em 01/11/2011

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Stephen Jonathan Taylor como diretor em 26/10/2011

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Timothy James Bolot como diretor em 26/10/2011

    2 páginasAP01

    Nomeação de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretário

    1 páginasAP03

    Término da nomeação de William Mcleish como secretário

    1 páginasTM02

    Contas anuais preparadas até 30/09/2010

    25 páginasAA

    Declaração anual preparada até 15/01/2011 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01

    Término da nomeação de Richard Midmer como diretor

    1 páginasTM01

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Explanatory statement to sole member 14/05/2010
    RES13

    Contas anuais preparadas até 27/09/2009

    25 páginasAA

    Declaração anual preparada até 15/01/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Mr David Andrew Smith em 07/01/2010

    2 páginasCH01

    Nomeação de Mr David Andrew Smith como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de David Smith como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr David Andrew Smith como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Kamma Foulkes como diretor

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    BAKER, Graham
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    Secretário
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    British40240710001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Secretário
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    British53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Secretário
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Secretário
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Secretário
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    LOUKES, Kenneth Martin
    23 The Chase
    HA7 3RU Stanmore
    Middlesex
    Secretário
    23 The Chase
    HA7 3RU Stanmore
    Middlesex
    British6945830001
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Secretário
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretário
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158306100001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretário
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Secretário
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Secretário
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SMITH, Peter Anthony
    Forge Cottage
    Forge Lane, Shorne
    DA12 3DP Gravesend
    Kent
    Secretário
    Forge Cottage
    Forge Lane, Shorne
    DA12 3DP Gravesend
    Kent
    British71842080001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    Secretário
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    British69112020001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Diretor
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    British57906600001
    BAKER, Graham
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    26 Hazelhurst Road
    Kings Heath
    B14 7PJ Birmingham
    West Midlands
    British40240710001
    BALLANTYNE, Thomas Niven
    Greystones
    Milnthorpe Road, Holme
    LA6 1PX Carnforth
    Lancashire
    Diretor
    Greystones
    Milnthorpe Road, Holme
    LA6 1PX Carnforth
    Lancashire
    EnglandBritish68970050002
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    Diretor
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish66559170001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BRADEEN, Chester Howard
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    Diretor
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    American51593550001
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Diretor
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    FARMER, Nicholas John
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    Diretor
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish124228290001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    Diretor
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    British14241020001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Diretor
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish53915080001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Diretor
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GEE, Andrew Anthony Edward
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    Diretor
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    EnglandBritish93592160001
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Diretor
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    GWATKIN, Peter Frederick Stapleton
    Shustoke Hall Moathouse Lane
    Shustoke Coleshill
    B46 2RJ Birmingham
    Diretor
    Shustoke Hall Moathouse Lane
    Shustoke Coleshill
    B46 2RJ Birmingham
    British42082340004
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Diretor
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    British79846610001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Diretor
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    LAWRENCE, Stephen John
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    Diretor
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    EnglandBritish5579020001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Diretor
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    LOUKES, Kenneth Martin
    23 The Chase
    HA7 3RU Stanmore
    Middlesex
    Diretor
    23 The Chase
    HA7 3RU Stanmore
    Middlesex
    British6945830001

    EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Rent deposit deed
    Criado em 23/03/1998
    Entregue em 09/04/1998
    Pendente
    Montante garantido
    The obligations of the company to the chargee in a lease dated 23RD march 1998
    Breve descrição
    A deposit of £74,500 (initially) which will during the life of the rent deposit deed be increased as set out in the rent deposit deed.
    Pessoas com direito
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transações
    • 09/04/1998Registro de uma garantia (395)
    Legal charge
    Criado em 23/03/1998
    Entregue em 07/04/1998
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Inclusive of the l/h interest of the company in and to the "legal charge property" k/a site 5B2, copperfield road thamesmead all fixtures and the proceeds of sale. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transações
    • 07/04/1998Registro de uma garantia (395)
    Legal charge
    Criado em 13/02/1996
    Entregue em 14/02/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Mortgage 8,9 and 10 third avenue sherwood drive nottingham t/n's NT19209 and NT30826 all buildings and other structures any goodwill all olant macinery and items the proceeds of any claims under the insurances by way of assignment the rental sums and by way of floating charge all unattached plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 14/02/1996Registro de uma garantia (395)
    • 24/04/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 13/02/1996
    Entregue em 14/02/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The chestnuts hotel main road rasdcliffe on trent nottinghamshire t/n NT155409 by way of fixed charge all buildings and structures by way of fixed charge any goodwill all plant machinery and other items and the proceeds of any claims under the insurances by way of assignment the rental sums by way of floating charge all unattached plant machinery and chattels.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 14/02/1996Registro de uma garantia (395)
    • 08/07/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 04/12/1995
    Entregue em 12/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Bank of Wales
    Transações
    • 12/12/1995Registro de uma garantia (395)
    • 08/07/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 14/08/1995
    Entregue em 17/08/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The properties as detailed in the continuation sheet attached to the form 395 and. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 17/08/1995Registro de uma garantia (395)
    • 08/07/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 30/01/1995
    Entregue em 07/02/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    F/H-willow court nursing home being land on the east side of croft lane, cherry willingham, west lindsey lincolnshire t/n-LL88541. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 07/02/1995Registro de uma garantia (395)
    • 24/04/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 30/01/1995
    Entregue em 07/02/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    F/H-white gables nursing home lincoln road skellingthorpe and land at skellingthorpe, north kesteven lincolnshire t/n-LL54775 and LL73989. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 07/02/1995Registro de uma garantia (395)
    • 24/04/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 30/01/1995
    Entregue em 07/02/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    F/H-wood view nursing home being land on the south west side and land and buildings lying to the south west of lincoln road and being 127 lincoln road branston north kesteven lincolnshire t/n-LL91827 and LL93202. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 07/02/1995Registro de uma garantia (395)
    • 08/07/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 30/01/1995
    Entregue em 07/02/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H-willow court nursing home being land on east side of croft lane cherry willingham west lindsey lincolneshire t/n-LL88541. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 07/02/1995Registro de uma garantia (395)
    • 08/07/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite debenture
    Criado em 24/12/1991
    Entregue em 07/01/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the security documents as defined
    Breve descrição
    See doc ref M560C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 07/01/1992Registro de uma garantia (395)
    • 27/01/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    20/06/2012Data da reunião para aprovar o CVA
    20/08/2012Data de finalização ou terminação do CVA
    Acordo voluntário de reestruturação empresarial (CVA)
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Profissional
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profissional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0