GERRARD (OMH) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaGERRARD (OMH) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02284499
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de GERRARD (OMH) LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica GERRARD (OMH) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de GERRARD (OMH) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    OLD MUTUAL HOLDINGS LIMITED11/11/200211/11/2002
    OLD MUTUAL SECURITIES LIMITED01/06/200001/06/2000
    ALBERT E SHARP LIMITED01/01/199501/01/1995
    ALBERT E. SHARP & CO.05/08/198805/08/1988

    Quais são as últimas contas de GERRARD (OMH) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2015

    Quais são as últimas submissões para GERRARD (OMH) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    11 páginasLIQ13

    Endereço do domicílio registado alterado de 1 Churchill Place London E14 5HP para Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR em 27/02/2017

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    2 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 09/02/2017

    LRESSP

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado do capital em 07/02/2017

    • Capital: GBP 1.05
    3 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Share premium of £275,767.00 is cancelled 06/02/2017
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Satisfação total da garantia 5

    4 páginasMR04

    Declaração de confirmação apresentada em 09/12/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 01/01/2016 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital20/01/2016

    Estado do capital em 20/01/2016

    • Capital: GBP 9,930,052.5
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014

    5 páginasAA

    Nomeação de Dr Philip Andrew Frank Byle como diretor em 19/06/2015

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mark Andrew Richards como diretor em 19/06/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Nicholas John Garnett como diretor em 22/04/2015

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 01/01/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital20/01/2015

    Estado do capital em 20/01/2015

    • Capital: GBP 9,930,052.5
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 01/01/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital08/01/2014

    Estado do capital em 08/01/2014

    • Capital: GBP 9,930,052.5
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012

    5 páginasAA

    Nomeação de Mr Richard Henry Philipps como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de David Currie como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 01/01/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Quem são os diretores de GERRARD (OMH) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Secretário
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    BYLE, Philip Andrew Frank, Dr.
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish175463080001
    PHILIPPS, Richard Henry
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish178406100001
    RICHARDS, Mark Andrew
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish182116990001
    FISHER, Peter Blake
    Old Ridgeway Cottage
    Crown Lane Wychbold
    WR9 0BX Droitwich
    Worcestershire
    Secretário
    Old Ridgeway Cottage
    Crown Lane Wychbold
    WR9 0BX Droitwich
    Worcestershire
    British25278500001
    HILL, Edwina Anne
    27 Bishops Meadow
    Weeford Road
    B75 5PQ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secretário
    27 Bishops Meadow
    Weeford Road
    B75 5PQ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British44399680002
    MAYOR, Sukesh Chander
    62 Herbert Road
    Emerson Park
    RM11 3LL Hornchurch
    Essex
    Secretário
    62 Herbert Road
    Emerson Park
    RM11 3LL Hornchurch
    Essex
    British72392270001
    SLOCOMBE, Stephen Roy
    92 Stratton Drive
    IG11 9HD Barking
    Essex
    Secretário
    92 Stratton Drive
    IG11 9HD Barking
    Essex
    British55097590002
    SMELLIE, Keith Graham
    South Lawn
    CV35 7AA Rowington
    Warwick
    Secretário
    South Lawn
    CV35 7AA Rowington
    Warwick
    British97352560001
    SUTTON, Ian Nicholas
    83a Hervey Road
    Blackheath
    SE3 8BX London
    Secretário
    83a Hervey Road
    Blackheath
    SE3 8BX London
    British37516040002
    TELFER, Miranda Lauraine
    Lingfield House
    East Grinstead
    RH7 6ES Lingfield
    Secretário
    Lingfield House
    East Grinstead
    RH7 6ES Lingfield
    British80083220001
    AIREY, Christopher Jonathan
    Little Newarks Newarks Road
    Good Easter
    CM1 4SA Chelmsford
    Essex
    Diretor
    Little Newarks Newarks Road
    Good Easter
    CM1 4SA Chelmsford
    Essex
    British45740380001
    ANSTEE, Eric Edward
    Whitethorns
    Weydown Road
    GU27 1DS Haslemere
    Surrey
    Diretor
    Whitethorns
    Weydown Road
    GU27 1DS Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritish76479900001
    ATKINSON, Kevin Derek
    Stanage
    Roslyn Road, Wellington
    TF1 3AX Telford
    Shropshire
    Diretor
    Stanage
    Roslyn Road, Wellington
    TF1 3AX Telford
    Shropshire
    EnglandBritish97538420001
    AUSTIN, Richard Graham Gosset
    Olde Timbers Pumphouse Lane
    Hanbury
    B60 4BX Bromsgrove
    Worcestershire
    Diretor
    Olde Timbers Pumphouse Lane
    Hanbury
    B60 4BX Bromsgrove
    Worcestershire
    British3533270001
    BARON, Rupert Nigel Kendall
    2 Rectory Road
    SW13 0DT London
    Diretor
    2 Rectory Road
    SW13 0DT London
    British30084840002
    BARRELL, Alexander Conan
    Skinners Hill Cottage Eyford Park
    Upper Slaughter
    GL54 2JN Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    Skinners Hill Cottage Eyford Park
    Upper Slaughter
    GL54 2JN Cheltenham
    Gloucestershire
    British59253480001
    BARRETT, Del Amanda, Dr
    102a Marlborough
    61 Walton Street
    SW3 2JY London
    Diretor
    102a Marlborough
    61 Walton Street
    SW3 2JY London
    EnglandBritish39721540001
    BAWDEN, Derek Charles
    The Cottage 65 Water Lane
    NN4 6HH Wootton
    Northampton
    Diretor
    The Cottage 65 Water Lane
    NN4 6HH Wootton
    Northampton
    British59367250001
    BENNETT, Timothy Michael Roth
    62 Sir Johns Road
    B29 7ER Selly Park
    Birmingham
    Diretor
    62 Sir Johns Road
    B29 7ER Selly Park
    Birmingham
    British70298090001
    BERNAYS, Richard Oliver
    82 Elgin Crescent
    W11 2JL London
    Diretor
    82 Elgin Crescent
    W11 2JL London
    United KingdomBritish98729980001
    BLATCHLY, Christopher Nigel
    Old Comptons
    Comptons Lane
    RH13 6DP Horsham
    West Sussex
    Diretor
    Old Comptons
    Comptons Lane
    RH13 6DP Horsham
    West Sussex
    British26871210002
    BLOUNT, Christopher
    Cornerways
    The Green, Leafield
    OX29 9NP Witney
    Oxfordshire
    Diretor
    Cornerways
    The Green, Leafield
    OX29 9NP Witney
    Oxfordshire
    EnglandBritish89344930001
    BOGLE, Robert Oswald
    31 Foley Road East
    Streetly
    B74 3HP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    31 Foley Road East
    Streetly
    B74 3HP Sutton Coldfield
    West Midlands
    British6832140001
    BOLSOVER, Michael Timothy
    Wakehurst
    Limes Close Bramshott
    GU30 7SL Liphook
    Hampshire
    Diretor
    Wakehurst
    Limes Close Bramshott
    GU30 7SL Liphook
    Hampshire
    EnglandBritish104281460001
    BROCKLEBANK, Roger James
    Nursery Cottage Bull Hill Lane
    Astley Burf
    DY13 0SE Stourport On Severn
    Worcestershire
    Diretor
    Nursery Cottage Bull Hill Lane
    Astley Burf
    DY13 0SE Stourport On Severn
    Worcestershire
    British44399140001
    CAMPBELL, Gordon Edward
    34 Inchford Road
    B92 9QD Solihull
    West Midlands
    Diretor
    34 Inchford Road
    B92 9QD Solihull
    West Midlands
    British6832150001
    CAMPBELL, Neil
    Forge Cottage
    Street End
    BS40 7TL Blaydon
    Bristol
    Diretor
    Forge Cottage
    Street End
    BS40 7TL Blaydon
    Bristol
    United KingdomBritish59407690001
    CAMPBELL, Norman Hunter
    31 Montgomery Street
    G76 0AS Eaglesham
    Diretor
    31 Montgomery Street
    G76 0AS Eaglesham
    ScotlandBritish10030001
    CASHDAN, David
    11 Walsingham
    St Johns Wood Park
    NW8 6RG London
    Diretor
    11 Walsingham
    St Johns Wood Park
    NW8 6RG London
    British34609460001
    CASSIE, John
    12 Barn Road
    Handsacre
    WS15 4TA Rugeley
    Staffordshire
    Diretor
    12 Barn Road
    Handsacre
    WS15 4TA Rugeley
    Staffordshire
    British85363490001
    CONDER, Simon Andrew
    Elizabeth Dane
    5c Burnt Ash Lane
    BR1 4DJ Bromley
    Kent
    Diretor
    Elizabeth Dane
    5c Burnt Ash Lane
    BR1 4DJ Bromley
    Kent
    United KingdomBritish87427400001
    COOKE, Trevor Charles
    Clifton Cottage Cliftons Lane
    RH2 9RA Reigate
    Surrey
    Diretor
    Clifton Cottage Cliftons Lane
    RH2 9RA Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish141581640001
    CULL, Graeme Frank
    Strathbeg 6 Park Road
    GU22 7BW Woking
    Surrey
    Diretor
    Strathbeg 6 Park Road
    GU22 7BW Woking
    Surrey
    British62391710001
    CURRIE, David Mclean
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Diretor
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    ScotlandBritish136790250001

    Quem são as pessoas com controle significativo de GERRARD (OMH) LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    06/04/2016
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland & Wales
    Autoridade legalEngland And Wales
    Local de registroCompanies House
    Número de registro2181315
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    GERRARD (OMH) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Security deed
    Criado em 26/06/2000
    Entregue em 05/07/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All debts, obligations and liabilities whatsoever on the date of the security deed and from time to time thereafter (whether before or after the service of a default notice) due, owing or incurred by the company to the chargee (whether solely or jointly or jointly or severally with another or others and whether as principal or surely and whether actual or contingent present and future) including (whether before or after any judgement) all interest, costs and other charges whatsover and including without limitation, any such debts, obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as defined in the security deed)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges all sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company referable to the crest member in crest or any transfer by the company or the crest member of any of its right title or interest to and in stock represented by any credit balance on any such eligible account see ch microfiche for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 05/07/2000Registro de uma garantia (395)
    • 05/11/2003Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 06/02/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Security deed
    Criado em 01/02/2000
    Entregue em 15/02/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including, without limitation, in connection with the facility agreement; any assured payment by the chargee; or any transfer of stock to the company by means of crest; or any agreement to transfer stock to the company by means of crest; or any issue of stock to the company by means of crest
    Breve descrição
    First fixed charge all sums and payments hereafter receivable by or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of, or any agreement to transfer or debit stock for any eligible stock account of or in the name of or otherwise referable to the company in crest. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 15/02/2000Registro de uma garantia (395)
    • 15/03/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Criado em 23/07/1998
    Entregue em 03/08/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from albert e sharp holdings PLC to the chargee on any account whatsoever provided that the total sum recoverable under the security shall not exceed the amount of the deposit(s) together with all interest for the time being accrued thereon
    Breve descrição
    30802964. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 03/08/1998Registro de uma garantia (395)
    • 15/03/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 13/04/1993
    Entregue em 20/04/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due under the terms of the charge
    Breve descrição
    All shares stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland Limited
    Transações
    • 20/04/1993Registro de uma garantia (395)
    • 26/11/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Assignment
    Criado em 09/07/1992
    Entregue em 16/07/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All moneys due or owing due as specified in the guarantee dated 9TH july 1992 see form 395 ref. M249C for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 16/07/1992Registro de uma garantia (395)
    • 10/10/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    GERRARD (OMH) LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    09/02/2017Início da liquidação
    22/09/2017Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profissional
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profissional
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0