ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED

ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02284553
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED?

    • Outro transporte terrestre de passageiros urbano, suburbano ou metropolitano (não metro, metropolitano ou sistemas similares) (49319) / Transportes e armazenagem

    Onde fica ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    YORKSHIRE WOOLLEN DISTRICT TRANSPORT COMPANY LIMITED25/10/198825/10/1988
    SIMCO 246 LIMITED05/08/198805/08/1988

    Quais são as últimas contas de ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2015

    Quais são as últimas submissões para ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    11 páginasLIQ13

    Endereço do domicílio registado alterado de 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP para 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor York North Yorkshire YO30 4XG em 14/03/2017

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 27/02/2017

    LRESSP

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015

    12 páginasAA

    Término da nomeação de David Cocker como diretor em 27/06/2016

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mrs Lorna Edwards como diretor em 27/06/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Nigel Paul Featham como diretor em 27/06/2016

    1 páginasTM01

    Satisfação total da garantia 4

    2 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 5

    1 páginasMR04

    Declaração anual preparada até 03/05/2016 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital03/05/2016

    Estado do capital em 03/05/2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Término da nomeação de Richard Anthony Bowler como diretor em 22/12/2015

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014

    9 páginasAA

    Declaração anual preparada até 03/05/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital05/05/2015

    Estado do capital em 05/05/2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    20 páginasAA

    Declaração anual preparada até 03/05/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital06/05/2014

    Estado do capital em 06/05/2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Nomeação de Mrs Lorna Edwards como secretário

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Elizabeth Davies como secretário

    1 páginasTM02

    Contas anuais preparadas até 31/12/2012

    19 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Richard Anthony Bowler em 16/08/2013

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 03/05/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2011

    19 páginasAA

    Detalhes do secretário alterados para Ms Elizabeth Anne Thorpe em 26/05/2012

    1 páginasCH03

    Quem são os diretores de ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    EDWARDS, Lorna
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    Secretário
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    183720710001
    EDWARDS, Lorna
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    Diretor
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    EnglandBritish205425080001
    COCKER, David
    49 The Mount
    Wrenthorpe
    WF2 0NZ Wakefield
    West Yorkshire
    Secretário
    49 The Mount
    Wrenthorpe
    WF2 0NZ Wakefield
    West Yorkshire
    British37574310001
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Secretário
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    LAUCHT, Robert Ian
    1 High Meadows, Church Lane
    Kirk Ella
    HU10 7NJ Hull
    East Riding Yorkshire
    Secretário
    1 High Meadows, Church Lane
    Kirk Ella
    HU10 7NJ Hull
    East Riding Yorkshire
    British13774020001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Secretário
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Secretário
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    ADCOCK, Paul
    1 Field View
    Cawston
    CV22 7FE Rugby
    Warwickshire
    Diretor
    1 Field View
    Cawston
    CV22 7FE Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritish112858780001
    BARFOOT, Vernon
    1 Montague Court
    Santa Cruz Drive
    BN23 5 Eastbourne
    East Sussex
    Diretor
    1 Montague Court
    Santa Cruz Drive
    BN23 5 Eastbourne
    East Sussex
    British89516570001
    BARKER, Neil James
    50 Woodfield Road
    B13 9UJ Kings Heath
    Birmingham
    Diretor
    50 Woodfield Road
    B13 9UJ Kings Heath
    Birmingham
    EnglandBritish165014000001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    British42058550001
    BOOKER, Philip Geoffrey
    22 Naseby Road
    DE56 0ER Belper
    Derbyshire
    Diretor
    22 Naseby Road
    DE56 0ER Belper
    Derbyshire
    British84332090001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Diretor
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish35116070003
    BOWLER, Richard Charles
    25 Rock Farm Lane
    Sandford On Thames
    OX4 4YL Oxford
    Diretor
    25 Rock Farm Lane
    Sandford On Thames
    OX4 4YL Oxford
    British51739150002
    CLARKE, Kenneth Barry
    2 Sherwood Drive
    WF2 7QT Wakefield
    West Yorkshire
    Diretor
    2 Sherwood Drive
    WF2 7QT Wakefield
    West Yorkshire
    British76952760002
    CLAYTON, Stephen John
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    Diretor
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritish46866840005
    COCKER, David
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Diretor
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish37574310001
    CUMMINS, Philip
    7 Marina Avenue
    Sutton
    WA9 3TA St Helens
    Merseyside
    Diretor
    7 Marina Avenue
    Sutton
    WA9 3TA St Helens
    Merseyside
    United KingdomBritish153482060001
    DAVIES, Justin Wyn
    7 Hawkenbury Road
    TN2 5BN Tunbridge Wells
    Kent
    Diretor
    7 Hawkenbury Road
    TN2 5BN Tunbridge Wells
    Kent
    British66657430002
    FEATHAM, Nigel Paul
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Diretor
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish161124990001
    FLYNN, James Sidney
    4 Milnthorpe Drive
    Sandal
    WF2 7HU Wakefield
    West Yorkshire
    Diretor
    4 Milnthorpe Drive
    Sandal
    WF2 7HU Wakefield
    West Yorkshire
    Irish77440240001
    HARVEY, Peter
    Chapel End 36 Main Street
    Swithland
    LE12 8TH Loughborough
    Leicestershire
    Diretor
    Chapel End 36 Main Street
    Swithland
    LE12 8TH Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish30318040003
    HODGSON, Kenneth
    The Grange Church Lane
    Elvington
    YO41 4HD York
    Diretor
    The Grange Church Lane
    Elvington
    YO41 4HD York
    United KingdomBritish9946200002
    HOSKINS, Neil Terence
    45 Brand Hill Drive
    Crofton
    WF4 1PF Wakefield
    West Yorkshire
    Diretor
    45 Brand Hill Drive
    Crofton
    WF4 1PF Wakefield
    West Yorkshire
    British14322510001
    HUNTER, Michael John
    100 Manygates Lane
    Sandal
    WF2 7DP Wakefield
    West Yorkshire
    Diretor
    100 Manygates Lane
    Sandal
    WF2 7DP Wakefield
    West Yorkshire
    British1058260002
    JACKSON, Brian Malcolm
    Cedar House Manor Court
    Barton Under Needwood
    DE13 8AU Burton On Trent
    Staffordshire
    Diretor
    Cedar House Manor Court
    Barton Under Needwood
    DE13 8AU Burton On Trent
    Staffordshire
    British90088220001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish77984700001
    LAUCHT, Robert Ian
    1 High Meadows, Church Lane
    Kirk Ella
    HU10 7NJ Hull
    East Riding Yorkshire
    Diretor
    1 High Meadows, Church Lane
    Kirk Ella
    HU10 7NJ Hull
    East Riding Yorkshire
    United KingdomBritish13774020001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Diretor
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Diretor
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    NOBLE, Stephen Leslie
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    Diretor
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    United KingdomBritish128655430001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Diretor
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    British58415290001
    ROBERTS, Ralph Robert
    46 Jackson Drive
    Crowwod Grange
    G33 6GF Stepps
    Lanarkshire
    Diretor
    46 Jackson Drive
    Crowwod Grange
    G33 6GF Stepps
    Lanarkshire
    British127760350001
    STONE, Philip Martin
    21 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    Diretor
    21 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    EnglandBritish69200640003
    WALLACE, Neale Howard
    17 Greenside
    Denby Dale
    HD8 8QY Huddersfield
    West Yorkshire
    Diretor
    17 Greenside
    Denby Dale
    HD8 8QY Huddersfield
    West Yorkshire
    British43081660003

    ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Mortgage
    Criado em 19/05/2008
    Entregue em 22/05/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The goods X687YUG 001281 volvo X688YUG 001275 volvo X689YUG 001260 volvo arriva yorkshire west limited for further items charged please see form 395 see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 22/05/2008Registro de uma garantia (395)
    • 10/05/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Mortgage
    Criado em 23/11/2006
    Entregue em 02/12/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All right title and interest in the goods being chassis: 13336 vdl.reg no:YJ06 wwv.chassis type:DB250. Bodywork: e lancs. Body type: lowlander. Chassis: 13335 vdl. Reg no: YJ06 wwl. Chassis type: DB250. Bodywork: e lancs. Body type: lowlander. Chassis: 13337 vdl. Reg no: YJ06 wwx. Chassis type: DB250. Bodywork: e lancs. Body type: lowlander. (For details of further goods charged please see form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Ing Lease (UK) Limited
    Transações
    • 02/12/2006Registro de uma garantia (395)
    • 10/05/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Fixed and floating charge
    Criado em 15/06/1995
    Entregue em 20/06/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the loan agreement,any interest rate agreement or any other grant or security under any of the security documents (as defined therein)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The First National Bank of Boston("the Agent") as Agent and Trustee for Each of the Beneficiaries (As Defined Therein)
    Transações
    • 20/06/1995Registro de uma garantia (395)
    • 01/05/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed charge
    Criado em 13/04/1995
    Entregue em 20/04/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £3,335,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Fixed charge over the goods listed in the schedule to the form 395 including several leyland lynx, dennis lance and mercedes benz. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transações
    • 20/04/1995Registro de uma garantia (395)
    • 08/02/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 23/03/1990
    Entregue em 29/03/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed chage over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (excluding those mentioned above). Uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 29/03/1990Registro de uma garantia
    • 30/03/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    ARRIVA YORKSHIRE WEST LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    27/02/2017Início da liquidação
    25/12/2017Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    David Adam Broadbent
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link
    YO30 4XG Clifton Moor
    York
    Profissional
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link
    YO30 4XG Clifton Moor
    York
    Ian James Royle
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire
    Profissional
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0