THE UK CHANNEL LIMITED

THE UK CHANNEL LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTHE UK CHANNEL LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02301363
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de THE UK CHANNEL LIMITED?

    • (7499) /

    Onde fica THE UK CHANNEL LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    The London Television Centre
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de THE UK CHANNEL LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    THE HOME SERVICE CHANNEL LIMITED20/07/198920/07/1989
    MANI LIMITED30/09/198830/09/1988

    Quais são as últimas contas de THE UK CHANNEL LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2008

    Quais são as últimas submissões para THE UK CHANNEL LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 01/11/2009 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital24/11/2009

    Estado do capital em 24/11/2009

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Eleanor Kate Irving em 16/10/2009

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Helen Jane Tautz em 16/10/2009

    2 páginasCH01

    Endereço do domicílio registado alterado de 200 Grays Inn Road London WC1X 8HF em 12/10/2009

    1 páginasAD01

    Contas preparadas até 31/12/2008

    2 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    4 páginas363a

    Memorando e estatutos

    8 páginasMA

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01
    capital

    Resoluções

    Section 175(5)a 22/09/2008
    RES13

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    Contas preparadas até 31/12/2007

    2 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    Contas preparadas até 31/12/2006

    2 páginasAA

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    3 páginas363a

    Quem são os diretores de THE UK CHANNEL LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    IRVING, Eleanor Kate
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    Diretor
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish79177030002
    TAUTZ, Helen Jane
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    Diretor
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish37564540001
    ABDOO, David
    78 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NN London
    Secretário
    78 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NN London
    British40437090001
    HOWLE, Michael Anthony
    46 Dowlans Road
    KT23 4LE Great Bookham
    Surrey
    Secretário
    46 Dowlans Road
    KT23 4LE Great Bookham
    Surrey
    British32460850001
    LUCAS, Anthony Ronald
    Flat 12 Beatrix House
    208 Old Beatrix Road
    SW5 0BP London
    Secretário
    Flat 12 Beatrix House
    208 Old Beatrix Road
    SW5 0BP London
    British30771870001
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Secretário
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    British37564540001
    ANCLIFF, Christopher John
    121 Chestnut Grove
    SW12 8JH London
    Diretor
    121 Chestnut Grove
    SW12 8JH London
    British52876050001
    BIRDSEYE, Sarah Elizabeth
    4 Bowood Road
    SW11 6PE London
    Diretor
    4 Bowood Road
    SW11 6PE London
    British69659880002
    BUGGY, Alan Richard
    927 Westover Road
    Stamford Connecticut
    FOREIGN
    Usa
    Diretor
    927 Westover Road
    Stamford Connecticut
    FOREIGN
    Usa
    American4860890001
    CONSTANT, Richard Michael
    6 Balniel Gate
    SW1V 3SD London
    Diretor
    6 Balniel Gate
    SW1V 3SD London
    United KingdomBritish43836310003
    CRESSWELL, John
    Rosslyn House 8 Park Road
    SO22 6AA Winchester
    Hampshire
    Diretor
    Rosslyn House 8 Park Road
    SO22 6AA Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish39795820003
    DILNOTT-COOPER, Rupert Michael Walter James
    23 Glenmore Road
    NW3 4BY London
    Diretor
    23 Glenmore Road
    NW3 4BY London
    EnglandBritish52448400001
    FORREST, Ian Mcclure
    Brewhurst House
    Brewhurst
    RH14 0RJ Loxwood
    West Sussex
    Diretor
    Brewhurst House
    Brewhurst
    RH14 0RJ Loxwood
    West Sussex
    British2327400003
    GOROG, William Christopher
    9044 Melrose Avenue
    FOREIGN Los Angeles
    90069
    Usa
    Diretor
    9044 Melrose Avenue
    FOREIGN Los Angeles
    90069
    Usa
    American96074620002
    HAIMOVITZ, Jules
    10551 Wilshire Boulevard
    90024 Los Angeles
    California
    U.S.A.
    Diretor
    10551 Wilshire Boulevard
    90024 Los Angeles
    California
    U.S.A.
    American43075680001
    HUTCHINGS, David George
    Crepping Hall
    CO6 2AL Wakes Colne
    Essex
    Diretor
    Crepping Hall
    CO6 2AL Wakes Colne
    Essex
    British10085500002
    JACQUES, John Douglas
    White Gates 81 East Lane
    West Horsley
    KT24 6LR Leatherhead
    Surrey
    Diretor
    White Gates 81 East Lane
    West Horsley
    KT24 6LR Leatherhead
    Surrey
    British3170310001
    JOHNSON, David
    50 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1BA Brentwood
    Essex
    Diretor
    50 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1BA Brentwood
    Essex
    EnglandBritish76706450001
    LUCAS, Anthony Ronald
    Flat 12 Beatrix House
    208 Old Beatrix Road
    SW5 0BP London
    Diretor
    Flat 12 Beatrix House
    208 Old Beatrix Road
    SW5 0BP London
    British30771870001
    MARRINAN, James
    206815 Hot Springs Place
    Agoura Hills California Ca91301
    FOREIGN
    Usa
    Diretor
    206815 Hot Springs Place
    Agoura Hills California Ca91301
    FOREIGN
    Usa
    American17905570001
    MEDLICOTT, William Jonathan
    Wild Boars
    Monteswood Lane
    RH17 7NS Horsted Keynes
    West Sussex
    Diretor
    Wild Boars
    Monteswood Lane
    RH17 7NS Horsted Keynes
    West Sussex
    EnglandEnglish44636500002
    POHL, Henry Theodore
    227 Hanworth Road
    TW12 3EF Hampton
    Middlesex
    Diretor
    227 Hanworth Road
    TW12 3EF Hampton
    Middlesex
    British32450180001
    SANITSKY, Robert
    9100 Wilshire Boulevard
    Suite 600
    90212 Beverley Hills
    Los Angeles California
    Usa
    Diretor
    9100 Wilshire Boulevard
    Suite 600
    90212 Beverley Hills
    Los Angeles California
    Usa
    Usa53433450001
    SMITH, Kathryn
    9 Hanover Steps
    Saint Georges Fields
    W2 2YG London
    Diretor
    9 Hanover Steps
    Saint Georges Fields
    W2 2YG London
    British77161950001
    TILL, Stewart Myles
    Barrymore 6 High Street
    RG10 8HY Wargrave
    Berkshire
    Diretor
    Barrymore 6 High Street
    RG10 8HY Wargrave
    Berkshire
    British24204890001
    WILLIAMS, Lucinda Mary
    34 Helena Road
    SL4 1JN Windsor
    Berkshire
    Diretor
    34 Helena Road
    SL4 1JN Windsor
    Berkshire
    British55121890001

    THE UK CHANNEL LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Composite guarantee & debenture
    Criado em 06/02/1991
    Entregue em 14/02/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreements dated 5/2/91 and all other facility documents on defined
    Breve descrição
    (See doc M132 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank Plcas Agent and Trustee for and on Behalf of Trelfand the Banks
    Transações
    • 14/02/1991Registro de uma garantia
    • 27/01/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Amanded and restated copyright collaterol assignment agreement
    Criado em 05/02/1991
    Entregue em 14/02/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined)
    Breve descrição
    All of the company's right title and interest in the " collaferal" (see form 395 ref M108 for full details).
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC(As Agent for the Benefit of the Beneficiaries as Defined)
    Transações
    • 14/02/1991Registro de uma garantia
    • 27/01/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Trademark security agreement
    Criado em 05/02/1991
    Entregue em 14/02/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined)
    Breve descrição
    All of the company's right title and interest in the "collaferal" (see form 395 - ref M124 for full details).
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC(As Agent for the Benefit of the Beneficiaries as Defined)
    Transações
    • 14/02/1991Registro de uma garantia
    • 27/01/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Us security agreement (created by the home service channel limited now k/a the U.K. channel limited)
    Criado em 05/02/1991
    Entregue em 14/02/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined)
    Breve descrição
    All of the company's right title and interest in the "collaferal" (see form 396- ref m 116 for full details).
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC(As Agent for the Benefit of the Beneficiaries as Defined)
    Transações
    • 14/02/1991Registro de uma garantia
    • 27/01/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0