PKL GROUP (UK) LIMITED

PKL GROUP (UK) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaPKL GROUP (UK) LIMITED
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02308713
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de PKL GROUP (UK) LIMITED?

    • Aluguel e leasing de outras máquinas, equipamentos e bens tangíveis n.e.c. (77390) / Atividades administrativas e de apoio

    Onde fica PKL GROUP (UK) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de PKL GROUP (UK) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    PORTABLE KITCHENS LIMITED09/05/199109/05/1991
    OPEN ALL DAY LIMITED01/05/199101/05/1991
    PORTABLE KITCHENS LIMITED25/10/198825/10/1988

    Quais são as últimas contas de PKL GROUP (UK) LIMITED?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/12/2024
    Próximas contas vencem em30/09/2025
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2023

    Qual é o status da última declaração de confirmação para PKL GROUP (UK) LIMITED?

    Última declaração de confirmação elaborada até01/04/2025
    Próxima declaração de confirmação vence15/04/2025
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até01/04/2024
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para PKL GROUP (UK) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Contas anuais preparadas até 31/12/2023

    31 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 01/04/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr Colin Nigel Dowds como diretor em 01/04/2024

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Neil William Gamble como diretor em 31/03/2024

    1 páginasTM01

    Satisfação total da garantia 023087130022

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 023087130023

    1 páginasMR04

    Registo da garantia 023087130024, criada em 14/09/2023

    61 páginasMR01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/04/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2022

    31 páginasAA

    Término da nomeação de Christopher Charles Richards como diretor em 31/07/2022

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2021

    32 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 01/04/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mrs Rachel Mccausland como diretor em 28/03/2022

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Neil William Gamble como diretor em 28/03/2022

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Paul Lavery como diretor em 28/03/2022

    1 páginasTM01

    Registo da garantia 023087130023, criada em 11/03/2022

    184 páginasMR01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2020

    32 páginasAA

    Registo da garantia 023087130022, criada em 09/07/2021

    30 páginasMR01

    Registo da garantia 023087130021, criada em 21/06/2021

    18 páginasMR01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/04/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mrs Karen Rumsey como diretor em 01/01/2021

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Lee Anthony Vines como diretor em 31/12/2020

    1 páginasTM01

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/08/2020 para 31/12/2020

    1 páginasAA01

    Registo da garantia 023087130020, criada em 09/04/2020

    60 páginasMR01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/04/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Quem são os diretores de PKL GROUP (UK) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    PERRY, William Edward
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Secretário
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    181911740001
    DOWDS, Colin Nigel
    9 Lissue Walk
    BT28 2LU Lisburn
    Unit 1
    Northern Ireland
    Diretor
    9 Lissue Walk
    BT28 2LU Lisburn
    Unit 1
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritishDirector253795300001
    IRVING, Christopher James Elgin
    Stella Way
    Bishops Cleeve
    GL52 7DQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    Stella Way
    Bishops Cleeve
    GL52 7DQ Cheltenham
    Gloucestershire
    ScotlandScottishDirector147035890001
    LOWRY, Rodney
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Diretor
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Northern IrelandBritishDirector219925750001
    MCCAUSLAND, Rachel
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Diretor
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Northern IrelandBritishDirector192783600002
    PERRY, William Edward
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Diretor
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    EnglandBritishFinance Director247031000001
    RUMSEY, Karen
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Diretor
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    EnglandBritishChief Operating Officer278213030001
    SCHAD, Peter Ferdinand
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Diretor
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector72449070002
    COLCHESTER, Timothy Mark
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Secretário
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    BritishAccountant104741260001
    HUNT, Michael Peter
    Ashton House Neata Farm
    Market Lane Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretário
    Ashton House Neata Farm
    Market Lane Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Secretary36149350002
    LOWE, Timothy Alun
    107 Heol Y Coed
    Rhiwbina
    CF14 6HS Cardiff
    Secretário
    107 Heol Y Coed
    Rhiwbina
    CF14 6HS Cardiff
    BritishCo Director36133150003
    MIDDLETON, Christopher Alan
    14 Saint Edwards Walk
    GL53 7RS Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretário
    14 Saint Edwards Walk
    GL53 7RS Cheltenham
    Gloucestershire
    British74792740001
    PUGH, David Richard
    Snowfield House
    4 Sheraton Road The Oakalls
    B60 2RT Bromsgrove
    Worcestershire
    Secretário
    Snowfield House
    4 Sheraton Road The Oakalls
    B60 2RT Bromsgrove
    Worcestershire
    British108788360001
    SCHAD, Peter Ferdinand
    Westfield
    25 All Saints Villas Road
    GL52 2HB Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretário
    Westfield
    25 All Saints Villas Road
    GL52 2HB Cheltenham
    Gloucestershire
    British72449070002
    VINCENT, Nicholas John
    Fairview 68 Sandy Lane
    Charlton Kings
    GL53 9DH Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretário
    Fairview 68 Sandy Lane
    Charlton Kings
    GL53 9DH Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishAccountant4565330001
    VINCENT, Nicholas John
    Fairview 68 Sandy Lane
    Charlton Kings
    GL53 9DH Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretário
    Fairview 68 Sandy Lane
    Charlton Kings
    GL53 9DH Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishAccountant4565330001
    BAILEY, Michael William John
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Diretor
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    EnglandBritishNon-Executive148550460002
    BIRD, Kenneth John
    The Beeches
    Hewlett Road
    GL51 6QY Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    The Beeches
    Hewlett Road
    GL51 6QY Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector3875670001
    COLCHESTER, Tim Mark
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Diretor
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    EnglandBritishAccountant184641070001
    CROW, Lynda Dawn
    19 Keynsham Road
    GL53 7PU Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    19 Keynsham Road
    GL53 7PU Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector18855840002
    CROW, Neil Ernest
    50 Naunton Crescent
    GL53 7BE Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    50 Naunton Crescent
    GL53 7BE Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishProject Manager34957860001
    DAY, Barry David
    The Old Rectory Hatton Green
    Hatton
    CV35 7LA Warwick
    Warwickshire
    Diretor
    The Old Rectory Hatton Green
    Hatton
    CV35 7LA Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritishAccountant57937960001
    GAMBLE, Neil William
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Diretor
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Northern IrelandBritishAccountant245581340001
    GLOVER, David Alan
    Birlingham
    WR10 3AB Pershore
    Glebe House
    Worcestershire
    Diretor
    Birlingham
    WR10 3AB Pershore
    Glebe House
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector133622500001
    HUNT, Michael Peter
    Ashton House Neata Farm
    Market Lane Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    Ashton House Neata Farm
    Market Lane Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector36149350002
    JOHN, Noel Emlyn
    9 Redthorne Way
    Hatherley
    GL51 3NW Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    9 Redthorne Way
    Hatherley
    GL51 3NW Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector81392560001
    JOY, Christine Elizabeth
    Coxhorne London Road
    Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    Coxhorne London Road
    Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector66531670001
    JOY, Peter Robin
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Diretor
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    EnglandBritishDirector92906050002
    LAVERY, Paul
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Diretor
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Northern IrelandIrishFinance Director145537540001
    LOWE, Timothy Alun
    107 Heol Y Coed
    Rhiwbina
    CF14 6HS Cardiff
    Diretor
    107 Heol Y Coed
    Rhiwbina
    CF14 6HS Cardiff
    WalesBritishAccountant36133150003
    MELLOR, Michael Ernest George
    30 Oakland Avenue
    GL52 3EP Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    30 Oakland Avenue
    GL52 3EP Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector23607050002
    MIDDLETON, Christopher Alan
    14 Saint Edwards Walk
    GL53 7RS Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    14 Saint Edwards Walk
    GL53 7RS Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector74792740001
    PUGH, David Richard
    Snowfield House
    4 Sheraton Road The Oakalls
    B60 2RT Bromsgrove
    Worcestershire
    Diretor
    Snowfield House
    4 Sheraton Road The Oakalls
    B60 2RT Bromsgrove
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector108788360001
    RICHARDS, Christopher Charles
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Diretor
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    EnglandBritishOperations Director232369840001
    ROGERS, Paul Stuart
    Manor Farmhouse
    Stanley Pontlarge
    GL54 5HD Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    Manor Farmhouse
    Stanley Pontlarge
    GL54 5HD Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishSales Executive63211870002

    Quem são as pessoas com controle significativo de PKL GROUP (UK) LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Pkl Topco Limited
    Stella Way
    Bishops Cleeve
    GL52 7DQ Cheltenham
    Pkl
    England
    31/07/2017
    Stella Way
    Bishops Cleeve
    GL52 7DQ Cheltenham
    Pkl
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalThe Law Of England & Wales
    Local de registroUk Companies House
    Número de registro07110339
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.
    Pkl Topco Ltd
    Stella Way
    Bishops Cleeve
    GL52 7DQ Cheltenham
    Pkl Group (Uk) Ltd
    England
    20/07/2017
    Stella Way
    Bishops Cleeve
    GL52 7DQ Cheltenham
    Pkl Group (Uk) Ltd
    England
    Sim
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUk
    Autoridade legalEngland & Wales
    Local de registroUk Company Number 06627298
    Número de registro06627298
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.
    Pkl Parent Ltd
    Malvern View Business Park, Stella Way
    Bishops Cleeve
    GL52 7DQ Cheltenham
    Pkl
    England
    18/05/2016
    Malvern View Business Park, Stella Way
    Bishops Cleeve
    GL52 7DQ Cheltenham
    Pkl
    England
    Sim
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUk
    Autoridade legalEngland & Wales
    Local de registroCompany Register
    Número de registro06627298
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    PKL GROUP (UK) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 14/09/2023
    Entregue em 15/09/2023
    Pendente
    Breve descrição
    1. old station yard, beckford, tewkesbury, GL20 7AN with title number WR74356.. Please see instrument for further details.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Ares Management Limited (The “Security Agent”)
    Transações
    • 15/09/2023Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 11/03/2022
    Entregue em 18/03/2022
    Totalmente satisfeita
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Upstream Working Capital LTD
    Transações
    • 18/03/2022Registro de uma garantia (MR01)
    • 19/09/2023Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 09/07/2021
    Entregue em 22/07/2021
    Totalmente satisfeita
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Upstream Working Capital LTD
    Transações
    • 22/07/2021Registro de uma garantia (MR01)
    • 19/09/2023Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 21/06/2021
    Entregue em 08/07/2021
    Pendente
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transações
    • 08/07/2021Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 09/04/2020
    Entregue em 09/04/2020
    Pendente
    Breve descrição
    Material real property:. Mortgagor: pkl group (UK) limited. Address: old station yard, beckford, tewkesbury, GL20 7AN. Title no: WR74356.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Ares Management Limited
    Transações
    • 09/04/2020Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 01/08/2019
    Entregue em 09/08/2019
    Pendente
    Breve descrição
    Please see instrument for further details.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Ares Management Limited
    Transações
    • 09/08/2019Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 29/03/2019
    Entregue em 05/04/2019
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    The property known as old station yard beckford tewkesbury GL20 7AN as registered at hm land registry with title number WR74356.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Handelsbanken PLC
    Transações
    • 05/04/2019Registro de uma garantia (MR01)
    • 18/12/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Criado em 14/01/2010
    Entregue em 15/01/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 15/01/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 18/12/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 11/11/2008
    Entregue em 15/11/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 15/11/2008Registro de uma garantia (395)
    • 18/12/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 1 december 2004 and
    Criado em 12/02/2007
    Entregue em 20/02/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 20/02/2007Registro de uma garantia (395)
    • 18/12/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    An omnibus guarantee and set off agreement
    Criado em 01/12/2004
    Entregue em 08/12/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 08/12/2004Registro de uma garantia (395)
    • 18/12/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 01/12/2004
    Entregue em 08/12/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 08/12/2004Registro de uma garantia (395)
    • 18/12/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    Mortgage debenture
    Criado em 25/02/1998
    Entregue em 04/03/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 04/03/1998Registro de uma garantia (395)
    • 10/03/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Assignment and charge of sub-leasing agreements
    Criado em 05/01/1998
    Entregue em 06/01/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the assignment and charge
    Breve descrição
    All the rights title and interest of the company in sub leases now made or hereafter to be made by the company in respect of equipment comprised in hp/leasing/contract hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transações
    • 06/01/1998Registro de uma garantia (395)
    • 24/04/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Charge over sub-hire
    Criado em 04/10/1996
    Entregue em 19/10/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All its right title and benefit under or in the existing sub-leases. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Tsb Asset Finance Limited
    Transações
    • 19/10/1996Registro de uma garantia (395)
    • 17/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Equipment mortgage
    Criado em 20/09/1996
    Entregue em 04/10/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The equipment and all right title benefit and interest of the mortgagor in and to all insurances and warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Tsb Asset Finance Limited
    Transações
    • 04/10/1996Registro de uma garantia (395)
    • 17/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 05/07/1995
    Entregue em 21/07/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 21/07/1995Registro de uma garantia (395)
    • 06/02/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    Criado em 05/07/1995
    Entregue em 11/07/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All the l/h property k/a unit 3 the courtyard gillingham business park gillingham kent t/no K703408. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 11/07/1995Registro de uma garantia (395)
    • 06/02/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 05/07/1995
    Entregue em 11/07/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The benefit of an agreement made 30/4/91 between grosvenor deveopments limited (1) and the company (2) relating to unit 3 the courtyard phase 35 gillingham business park kent.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 11/07/1995Registro de uma garantia (395)
    • 27/02/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A credit agreement
    Criado em 20/07/1993
    Entregue em 29/07/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £37,266.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Breve descrição
    All the right,title and interest in and to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Close Brothers Limited
    Transações
    • 29/07/1993Registro de uma garantia (395)
    • 17/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A credit agreement entitled "prompt credit application"
    Criado em 12/11/1992
    Entregue em 19/11/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £22,429.60 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement.
    Breve descrição
    All its right,title and interest in and to all sums payable under the insurance.please see doc M167C for full details.
    Pessoas com direito
    • Close Brothers Limited
    Transações
    • 19/11/1992Registro de uma garantia (395)
    • 17/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 30/04/1991
    Entregue em 07/05/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/Hold property k/as unit 3 the courtyard phase 35 gillingham business p ark gillingham kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 07/05/1991Registro de uma garantia
    • 30/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 02/01/1990
    Entregue em 08/01/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Unit 3 manchester park, tewkesbury road cheltenham and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 08/01/1990Registro de uma garantia
    • 08/09/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 05/04/1989
    Entregue em 13/04/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 13/04/1989Registro de uma garantia
    • 30/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0