ROBERT'S YORKSHIRE KITCHEN LIMITED

ROBERT'S YORKSHIRE KITCHEN LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaROBERT'S YORKSHIRE KITCHEN LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02357407
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ROBERT'S YORKSHIRE KITCHEN LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica ROBERT'S YORKSHIRE KITCHEN LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ROBERT'S YORKSHIRE KITCHEN LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    NORDALE FOODS LIMITED21/09/199321/09/1993
    NORDALE COUNTRY FOODS LIMITED02/06/199202/06/1992
    THE ORIGINAL YORKSHIRE PUDDING COMPANY LIMITED09/03/198909/03/1989

    Quais são as últimas contas de ROBERT'S YORKSHIRE KITCHEN LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até27/09/2013

    Qual é o status da última declaração anual para ROBERT'S YORKSHIRE KITCHEN LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para ROBERT'S YORKSHIRE KITCHEN LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    13 páginas4.71

    Contas anuais preparadas até 27/09/2013

    11 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de * Greencore Group Uk Centre Midland Way Barlborough Links Business Park Barlborough Chesterfield S43 4XA* em 25/06/2014

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação

    LRESSP

    Declaração anual preparada até 31/03/2014 com lista completa de acionistas

    16 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital23/04/2014

    Estado do capital em 23/04/2014

    • Capital: GBP 550,000
    SH01

    Endereço do domicílio registado alterado de * Midland Road Hunslet Leeds LS10 2RJ* em 22/04/2014

    2 páginasAD01

    Nomeação de Michael Evans como secretário

    3 páginasAP03

    Término da nomeação de Conor O'leary como secretário

    2 páginasTM02

    Declaração anual preparada até 31/03/2013 com lista completa de acionistas

    16 páginasAR01

    Nomeação de Mr Alan Richard Williams como diretor

    3 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 28/09/2012

    11 páginasAA

    Nomeação de Jolene Gacquin como diretor

    3 páginasAP01

    Nomeação de Mr Michael Evans como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de John Mcnamara como diretor

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de Jonathan Hall como diretor

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de Jonathan Hall como secretário

    2 páginasTM02

    Nomeação de Conor O'leary como secretário

    3 páginasAP03

    Declaração anual preparada até 31/03/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2011

    14 páginasAA

    Declaração anual preparada até 31/03/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 24/09/2010

    22 páginasAA

    Término da nomeação de Geoffrey Doherty como diretor

    2 páginasTM01

    Quem são os diretores de ROBERT'S YORKSHIRE KITCHEN LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    EVANS, Michael
    Midland Way
    Barlborough Links Business Park Barlborough
    S43 4XA Chesterfield
    Greencore Uk Centre
    Uk
    Secretário
    Midland Way
    Barlborough Links Business Park Barlborough
    S43 4XA Chesterfield
    Greencore Uk Centre
    Uk
    British179189240001
    EVANS, Michael
    Lakeside Park
    WF6 1WN Normanton
    37
    West Yorkshire
    England
    Diretor
    Lakeside Park
    WF6 1WN Normanton
    37
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritishManaging Director148060720001
    GACQUIN, Jolene Anna, Ms.
    Northwood Avenue
    Northwood Business Park
    Dublin
    No 2
    9
    Ireland
    Diretor
    Northwood Avenue
    Northwood Business Park
    Dublin
    No 2
    9
    Ireland
    IrelandIrishDirector176849210001
    OLEARY, Conor
    Carrigabruce
    Enniscorthy
    Ard Na Laoi
    Co. Wexford
    Ireland
    Diretor
    Carrigabruce
    Enniscorthy
    Ard Na Laoi
    Co. Wexford
    Ireland
    IrelandIrishAssistant Group Secretary151167870001
    WILLIAMS, Alan Richard, Mr.
    Northwood Avenue
    Northwood Business Park
    9 Santry
    2
    Dublin 9
    Ireland
    Diretor
    Northwood Avenue
    Northwood Business Park
    9 Santry
    2
    Dublin 9
    Ireland
    EnglandBritishCompany Director137582690001
    ACKROYD, Ian Mark
    New Brighton House
    New Brighton Gargrave
    BD23 Skipton
    North Yorkshire
    Secretário
    New Brighton House
    New Brighton Gargrave
    BD23 Skipton
    North Yorkshire
    British78253880001
    ARMOUR, Douglas William
    Deramore Ham Lane
    Elstead
    GU8 6HG Godalming
    Surrey
    Secretário
    Deramore Ham Lane
    Elstead
    GU8 6HG Godalming
    Surrey
    BritishCompany Director31463000002
    BATES, Martin Anthony
    The Farmhouse
    1 Sothall Green Farm
    S20 1FU Beighton
    1
    Yorkshire
    England
    Secretário
    The Farmhouse
    1 Sothall Green Farm
    S20 1FU Beighton
    1
    Yorkshire
    England
    BritishFinance Director117628550003
    CONNERY, John Frederick
    Thornfield Hall Farm Arundel Street
    OL6 6RH Ashton Under Lyne
    Lancashire
    Secretário
    Thornfield Hall Farm Arundel Street
    OL6 6RH Ashton Under Lyne
    Lancashire
    BritishChartered Accountant5854930002
    GREEN, Adrian Phillip
    8 Brookhill Close
    Diggle
    OL3 5NH Oldham
    Lancashire
    Secretário
    8 Brookhill Close
    Diggle
    OL3 5NH Oldham
    Lancashire
    British75160130002
    HALL, Jonathan
    Midland Road
    Hunslet
    LS10 2RJ Leeds
    Secretário
    Midland Road
    Hunslet
    LS10 2RJ Leeds
    BritishAccountant136667060001
    MARCHANT, Derek Albert
    Ivydene House
    Chapel Street Barmby Moor
    YO42 4EN York
    North Yorkshire
    Secretário
    Ivydene House
    Chapel Street Barmby Moor
    YO42 4EN York
    North Yorkshire
    BritishFinance Director107199050001
    O'LEARY, Conor
    Carringabruce
    Enniscorthy
    Ard Na Laoi
    Co. Wexford
    Ireland
    Secretário
    Carringabruce
    Enniscorthy
    Ard Na Laoi
    Co. Wexford
    Ireland
    British174928470001
    VARLEY, John Edward Thomas
    46 Mill Croft Estate
    Pool In Wharfedale
    LS21 1LT Otley
    West Yorkshire
    Secretário
    46 Mill Croft Estate
    Pool In Wharfedale
    LS21 1LT Otley
    West Yorkshire
    British48730390001
    WHITFIELD, Ian
    7 Town Street
    Rawdon
    LS19 6PU Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    7 Town Street
    Rawdon
    LS19 6PU Leeds
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant92601920001
    ACKROYD, Ian Mark
    New Brighton House
    New Brighton Gargrave
    BD23 Skipton
    North Yorkshire
    Diretor
    New Brighton House
    New Brighton Gargrave
    BD23 Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritishFood Dealer78253880001
    ACKROYD, Miles David
    3 Thompson Terrace
    Carleton
    BD23 3DU Skipton
    North Yorkshire
    Diretor
    3 Thompson Terrace
    Carleton
    BD23 3DU Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritishFood Dealer78423670001
    ARMOUR, Douglas William
    Deramore Ham Lane
    Elstead
    GU8 6HG Godalming
    Surrey
    Diretor
    Deramore Ham Lane
    Elstead
    GU8 6HG Godalming
    Surrey
    BritishCompany Director31463000002
    BATES, Martin Anthony
    The Farmhouse
    1 Sothall Green Farm
    S20 1FU Beighton
    1
    Yorkshire
    England
    Diretor
    The Farmhouse
    1 Sothall Green Farm
    S20 1FU Beighton
    1
    Yorkshire
    England
    BritishFinance Director117628550003
    BRUCE, Martha Blanche Waymark
    7 Clifton Terrace
    Cliftonville
    RH4 2JG Dorking
    Surrey
    Diretor
    7 Clifton Terrace
    Cliftonville
    RH4 2JG Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Secretary71698110001
    CONNERY, John Frederick
    Thornfield Hall Farm Arundel Street
    OL6 6RH Ashton Under Lyne
    Lancashire
    Diretor
    Thornfield Hall Farm Arundel Street
    OL6 6RH Ashton Under Lyne
    Lancashire
    BritishChartered Accountant5854930002
    COVENEY, Patrick Francis
    6 Leinster Square
    Rathmines
    IRISH Dublin
    6
    Ireland
    Diretor
    6 Leinster Square
    Rathmines
    IRISH Dublin
    6
    Ireland
    IrelandIrishDirector143778240001
    DILGER, David John
    Lauriston Cenacle Grove
    Killiney Hill Road
    Killiney
    Co Dublin
    Ireland
    Diretor
    Lauriston Cenacle Grove
    Killiney Hill Road
    Killiney
    Co Dublin
    Ireland
    IrishManaging Director74455510001
    DOHERTY, Geoff Patrick
    Midland Road
    Hunslet
    LS10 2RJ Leeds
    Diretor
    Midland Road
    Hunslet
    LS10 2RJ Leeds
    IrelandIrishChartered Accountant161069960001
    GALLAGHER, David Stephen
    Manor Drive
    North Duffield
    YO8 5TJ Selby
    5
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Manor Drive
    North Duffield
    YO8 5TJ Selby
    5
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector136903520001
    GREEN, Adrian Phillip
    8 Brookhill Close
    Diggle
    OL3 5NH Oldham
    Lancashire
    Diretor
    8 Brookhill Close
    Diggle
    OL3 5NH Oldham
    Lancashire
    EnglandBritishChartered Accountant75160130002
    HALL, Jonathan
    Midland Road
    Hunslet
    LS10 2RJ Leeds
    Diretor
    Midland Road
    Hunslet
    LS10 2RJ Leeds
    United KingdomBritishAccountant136667060001
    HOWARD, Nigel
    8 Old Bank Close
    Bredbury Stockport
    SK6 1AF Cheshire
    Cheshire
    Diretor
    8 Old Bank Close
    Bredbury Stockport
    SK6 1AF Cheshire
    Cheshire
    BritishSales Director75291270001
    KENNEDY, Patrick Thomas
    61 Dartmouth Square
    Dublin 6
    Ireland
    Diretor
    61 Dartmouth Square
    Dublin 6
    Ireland
    IrishDirector74455540001
    LAND, Michael
    Island Cottage
    Forge Lane Wike
    LS17 9JU Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    Island Cottage
    Forge Lane Wike
    LS17 9JU Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director64511080001
    MARCHANT, Derek Albert
    Ivydene House
    Chapel Street Barmby Moor
    YO42 4EN York
    North Yorkshire
    Diretor
    Ivydene House
    Chapel Street Barmby Moor
    YO42 4EN York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director107199050001
    MCNAMARA, John
    Midland Road
    Hunslet
    LS10 2RJ Leeds
    Diretor
    Midland Road
    Hunslet
    LS10 2RJ Leeds
    United KingdomIrishGeneral Manager136666520002
    MONEY, Graham Joseph
    30 Dundee Drive
    PE9 2TR Stamford
    Lincolnshire
    Diretor
    30 Dundee Drive
    PE9 2TR Stamford
    Lincolnshire
    BritishOperations Director54294420001
    O'SULLIVAN, Kevin Clive
    17 Elgin Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    Diretor
    17 Elgin Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    BritishChief Financial Officer3562130002
    ODLUM, Philip Edwin
    109 Anglesea Road
    IRISH Ballisbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Diretor
    109 Anglesea Road
    IRISH Ballisbridge
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director144667960001

    ROBERT'S YORKSHIRE KITCHEN LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Mortgage deed
    Criado em 07/07/2000
    Entregue em 13/07/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land adjacent to midland road hunslet leeds t/no WYK510718. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 13/07/2000Registro de uma garantia (395)
    • 05/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 07/07/2000
    Entregue em 13/07/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £150,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Land to the west of pepper road hunslet leeds west yorkshire t/no WYK510718. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • R.B. Farquhar Holdings Limited
    Transações
    • 13/07/2000Registro de uma garantia (395)
    • 17/08/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    All assets debenture
    Criado em 03/11/1998
    Entregue em 12/11/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transações
    • 12/11/1998Registro de uma garantia (395)
    • 18/01/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 03/11/1998
    Entregue em 10/11/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • 3I Group PLC
    Transações
    • 10/11/1998Registro de uma garantia (395)
    • 15/09/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage deed
    Criado em 16/01/1998
    Entregue em 20/01/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a or being land and buildings on the south side of midland road leeds t/no;-WYK332420. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 20/01/1998Registro de uma garantia (395)
    • 05/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 30/05/1997
    Entregue em 07/06/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 30TH may 1997
    Breve descrição
    Freehold property known as land on the south side of midland road leeds title number WYK332420 together with all buildings and the fixtures and fixed plant and machinery,described on the lists attached to the form M395,and the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Exel Logistics - Temperature Controlled Services Limited
    Transações
    • 07/06/1997Registro de uma garantia (395)
    • 22/08/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 13/09/1996
    Entregue em 13/09/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Two new dijko oven modules serial nos: GB-t-170 9606.001 and GB-t-170 9606.002 complete with cooler heads,racks and filter cabinets.
    Pessoas com direito
    • Forward Trust Limited
    Transações
    • 13/09/1996Registro de uma garantia (395)
    • 05/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Collateral debenture
    Criado em 21/08/1995
    Entregue em 26/08/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • 3I Group PLC
    Transações
    • 26/08/1995Registro de uma garantia (395)
    • 04/09/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed charge
    Criado em 16/08/1994
    Entregue em 17/08/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £90,226.00 due from the company to the chargee
    Breve descrição
    First fixed charge over 3 new travelling rack oven systems type 170 for yorkshire puddings ser no GB-t-170 930901, GB-t-170 930902 & GB-t-170 930903 and 3 may 1990 system travelling rack oven type GB-t-27X 170 ser no GB-t-170 891001, GB-t-170 891003 & GB-t-170 891002.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transações
    • 17/08/1994Registro de uma garantia (395)
    • 09/09/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Single debenture
    Criado em 22/11/1993
    Entregue em 24/11/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 24/11/1993Registro de uma garantia (395)
    • 05/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 07/10/1992
    Entregue em 13/10/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 13/10/1992Registro de uma garantia (395)
    • 01/12/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    ROBERT'S YORKSHIRE KITCHEN LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    09/06/2014Início da liquidação
    07/10/2015Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Richard Howard Toone
    Cvr Global Llp
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LB London
    Profissional
    Cvr Global Llp
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LB London
    Lee De'Ath
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Profissional
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0