FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 02359377 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | All Seasons Church Road Cookham SL6 9PG Maidenhead Berkshire England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN LEASING DECEMBER (5)LIMITED | 30/04/2001 | 30/04/2001 |
| KLEINWORT BENSON LEASING DECEMBER (5) LTD. | 22/12/1995 | 22/12/1995 |
| S.G.WARBURG & CO. (LEASING) (NUMBER 8) LTD. | 14/05/1990 | 14/05/1990 |
| PALLAS LEASING (NUMBER 61) LTD | 10/03/1989 | 10/03/1989 |
Quais são as últimas contas de FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 30/04/2020 |
Quais são as últimas submissões para FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 30/04/2020 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/03/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 30/04/2019 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/03/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas não auditadas abreviadas apresentadas até 30/04/2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/03/2018 com atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas não auditadas abreviadas apresentadas até 30/04/2017 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/03/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 30/04/2016 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/03/2016 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de All Seasons Church Road Cookham Maidenhead Berkshire SL6 9PG England para All Seasons Church Road Cookham Maidenhead Berkshire SL6 9PG em 09/03/2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de The Courtlands 8 Plymouth Drive Barnt Green Worcestershire B45 8JB para All Seasons Church Road Cookham Maidenhead Berkshire SL6 9PG em 09/03/2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 30/04/2015 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Portavo Management Limited como diretor em 14/01/2016 | 2 páginas | AP02 | ||||||||||
Nomeação de Mr Frederick Derek Tughan como diretor em 09/12/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Ronald Ernest Woods como diretor em 09/12/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Jill Louise Robinson como diretor em 09/12/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Jill Louise Robinson como secretário em 09/12/2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/03/2015 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 30/04/2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/03/2014 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 30/04/2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Quem são os diretores de FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUGHAN, Frederick David | Diretor | Church Road Cookham SL6 9PG Maidenhead All Seasons Berkshire England | Northern Ireland | British | 203412740001 | |||||||||
| PORTAVO MANAGEMENT LIMITED | Diretor | Hill Street BT1 2LB Belfast 38 Northern Ireland |
| 204342110001 | ||||||||||
| AMEY, Michelle | Secretário | 4 Holme Road RM11 3QS Hornchurch Essex | British | 57746950002 | ||||||||||
| CLIFTON, Roger Cheston | Secretário | 8 Sandy Close GU22 8BQ Woking Surrey | British | 8089410002 | ||||||||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Secretário | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||||||
| LAYCOCK, Rufus | Secretário | Burghley Avenue KT3 4SW New Malden 33 Surrey | British | 7584610001 | ||||||||||
| LONGCROFT, Peter Leonard | Secretário | 4 Lakeside Close Reydon IP18 6YA Southwold Suffolk | British | 32431030003 | ||||||||||
| MARSHALL, Ian Bruce | Secretário | Hungershall Lodge Hungershall Park TN4 8ND Tunbridge Wells Kent | British | 752600001 | ||||||||||
| MARSHALL, Ian Bruce | Secretário | Hungershall Lodge Hungershall Park TN4 8ND Tunbridge Wells Kent | British | 752600001 | ||||||||||
| MORRISON, Audrey | Secretário | 20 Bliss Avenue SG17 5SF Shefford Bedfordshire | British | 44972470001 | ||||||||||
| ROBINSON, Jill Louise | Secretário | 81 Old Gansha Road BT19 7HA Bangor Down N Ireland | British | 114372460001 | ||||||||||
| YOUNG, Lorraine Elizabeth | Secretário | 3 Vaughan Avenue TN10 4EB Tonbridge Kent | British | 45988970001 | ||||||||||
| AIKEN, Neil Gordon | Diretor | The Birches 14 Stradbroke Drive IG7 5QX Chigwell Essex | United Kingdom | British | 43380390001 | |||||||||
| BARKER, Nicholas David | Diretor | Benhall Place Low Street, Benhall IP17 1JF Saxmundham Suffolk | United Kingdom | British | 41800250004 | |||||||||
| BEEVER, David Milton Maxwell | Diretor | Warren Farm House South Drive GU25 4JS Wentworth Surrey | United Kingdom | British | 35274610001 | |||||||||
| CHARLTON, John Michael | Diretor | Dunstone 5 Broomfield Ride KT22 0LR Oxshott Surrey | England | British | 73081460001 | |||||||||
| DEDMAN, John Arnold | Diretor | Heather Court Broomhall Road GU21 4AP Woking Surrey | British | 102358040001 | ||||||||||
| FOSSE, Finn Erik | Diretor | 5 Orchard Lane SW20 0SE London | Norwegian | 118721520001 | ||||||||||
| HARDWICK, Michael Robert | Diretor | The Laurels 9 Patmore Lane Burwood Park KT12 5DX Walton On Thames Surrey | British | 71971030001 | ||||||||||
| INNES, Michael Ernest Ashley | Diretor | Woodlands 4 Winchelsey Rise CR2 7BN South Croydon Surrey | British | 41782380001 | ||||||||||
| LAYCOCK, Rufus | Diretor | Burghley Avenue KT3 4SW New Malden 33 Surrey | United Kingdom | British | 7584610001 | |||||||||
| LEATHES, Simon William De Mussenden | Diretor | 19 Lauriston Road Wimbledon SW19 4TJ London | British | 9808160001 | ||||||||||
| MARSHALL, Kenneth Richard Paul | Diretor | Holford House North Chailey BN8 4DT Lewes East Sussex | British | 4863570001 | ||||||||||
| MYALL, Paul Geoffrey | Diretor | 10 Latimer Road Wimbledon SW19 1EP London | New Zealander/British | 41747120001 | ||||||||||
| O'HAIRE, Cormac Patrick Thomas | Diretor | 1 Windermere Road Ealing W5 4TJ London | Irish | 56976610001 | ||||||||||
| RANDALL, Colin | Diretor | 3 Raglan Court CR2 6NT South Croydon Surrey | British | 76844920001 | ||||||||||
| RANDALL, Colin | Diretor | 3 Raglan Court CR2 6NT South Croydon Surrey | British | 76844920001 | ||||||||||
| READ, Philip David | Diretor | 35 Elwill Way BR3 3AB Beckenham Kent | United Kingdom | British | 81624400001 | |||||||||
| ROBINSON, Jill Louise | Diretor | 81 Old Gansha Road BT19 7HA Bangor Down N Ireland | Northern Ireland | British | 114372460001 | |||||||||
| STEWART-ROBERTS, Andrew Kerr | Diretor | 48 Grove Lane Camberwell SE5 8ST London | British | 456970001 | ||||||||||
| TUGHAN, Frederick David | Diretor | Portavo House 176 Warren Road BT21 0PJ Donaghadee Co Down | Northern Ireland | British | 203412740001 | |||||||||
| WHITING, Kevin John | Diretor | 30 Gloucester Circus Greenwich SE10 8RY London | British | 43709920002 | ||||||||||
| WOODS, Ronald Ernest | Diretor | 8 Plymouth Drive B45 8JB Barnt Green The Courtlands Worcestershire | United Kingdom | British | 149388120001 | |||||||||
| WOODS, Ronald Ernest | Diretor | All Seasons House Sterlings Field SL6 9PG Cookham Dean Berks | United Kingdom | British | 149388120001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almira Holdings Ltd | 06/04/2016 | Rosemary Street BT1 1QD Belfast 20 Northern Ireland | Não | ||||
| |||||||
Natureza do controle
| |||||||
FITZGEORGE DECEMBER (5) LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Security assignment made between the company formerly known as dresdner kleinwort wasserstein leasing december (5) limited and lombard north central PLC | Criado em 29/06/2001 Entregue em 10/07/2001 | Pendente | Montante garantido All obligations whether actual,contingent,present and/or future obligations and liabilities of the assignors, to the chargee pursuant to the loan agreement and to this assignment | |
Breve descrição All of the right title benefit and interest of the assignor whatsoever present and future in the assigned rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Security assignment of put option made between the company formerly known as kleinwort wasserstein leasing december (5) limited and lombard north central PLC | Criado em 29/06/2001 Entregue em 10/07/2001 | Pendente | Montante garantido All obligations whether actual,contingent,present and/or future obligations and liabilities of the assignors,to the chargee under or pursuant to the loan agreement and to the assignment | |
Breve descrição Right title and interest in the option agreement dated 29 june 2001 in relation to lease agreements entered into with south west water limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0