DISTRICT ENERGY LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | DISTRICT ENERGY LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 02362017 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de DISTRICT ENERGY LIMITED?
- produção de eletricidade (35110) / Fornecimento de eletricidade, gás, vapor e ar condicionado
Onde fica DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 6th Floor, Radcliffe House Blenheim Court B91 2AA Solihull England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| BRITISH ENERGY MERCHANT GENERATION LIMITED | 19/03/1999 | 19/03/1999 |
| BRITISH ENERGY INVESTMENT (NO.4) LIMITED | 26/02/1999 | 26/02/1999 |
| NE GENERATION LIMITED | 16/02/1994 | 16/02/1994 |
| NUCLEAR ELECTRIC (1990) LTD. | 06/04/1990 | 06/04/1990 |
| SIGNKIT LIMITED | 16/03/1989 | 16/03/1989 |
Quais são as últimas contas de DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2018 |
Quais são as últimas submissões para DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
O processo de exclusão voluntária foi suspenso. | 1 páginas | SOAS(A) | ||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||
Nomeação de Mr Andrew Robert Koss como diretor em 03/08/2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Nauman Ahmad como diretor em 03/08/2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 19/06/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Término da nomeação de Sam Kieron Wither como diretor em 30/11/2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough TS90 8WS | 1 páginas | AD03 | ||
O endereço de inspeção do registo foi alterado para Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough TS90 8WS | 1 páginas | AD02 | ||
Contas anuais preparadas até 31/12/2018 | 17 páginas | AA | ||
Término da nomeação de Paul David Tomlinson como diretor em 30/09/2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 19/06/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Endereço do domicílio registado alterado de Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough Cleveland TS90 8WS England para 6th Floor, Radcliffe House Blenheim Court Solihull B91 2AA em 18/04/2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Nomeação de Mr Stephen Christopher Hands como secretário em 01/04/2019 | 2 páginas | AP03 | ||
Endereço do domicílio registado alterado de C/O Uk Power Reserve Ltd Radcliffe House Blenheim Court Warwick Road Solihull West Midlands B91 2AA para Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough Cleveland TS90 8WS em 18/04/2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Término da nomeação de Andrew Joseph Mountford como secretário em 01/04/2019 | 1 páginas | TM02 | ||
Contas anuais preparadas até 31/03/2018 | 17 páginas | AA | ||
Nomeação de Mr Paul David Tomlinson como diretor em 12/02/2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Sriram Narayanan como diretor em 12/02/2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Jonathan Peter Addis como diretor em 31/01/2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Satisfação total da garantia 023620170007 | 1 páginas | MR04 | ||
Satisfação total da garantia 023620170008 | 1 páginas | MR04 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 19/06/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Nomeação de Mr Stephen Christopher Hands como diretor em 31/05/2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Quem são os diretores de DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDS, Stephen Christopher | Secretário | Blenheim Court B91 2AA Solihull 6th Floor, Radcliffe House England | 257684290001 | |||||||
| HANDS, Stephen Christopher | Diretor | Wilton International TS90 8WS Middlesbrough Sembcorp Uk Headquarters United Kingdom | England | British | 205116300001 | |||||
| KOSS, Andrew Robert | Diretor | Blenheim Court B91 2AA Solihull 6th Floor, Radcliffe House England | England | English | 157160710002 | |||||
| ALLEN, Anthony | Secretário | 7 Conway Road Hucclecote GL3 3PD Gloucester | British | 43845510001 | ||||||
| ARMOUR, Robert Malcolm | Secretário | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 50003350005 | ||||||
| ARMOUR, Robert Malcolm | Secretário | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 50003350005 | ||||||
| GRANT, Paul Robert | Secretário | c/o Uk Power Reserve Ltd Blenheim Court Warwick Road B91 2AA Solihull Radcliffe House West Midlands England | 170448160001 | |||||||
| LAWRIE, Karen Nicola | Secretário | Bishops Frome WR6 5AS Worcester Boscombe House Worcestershire | British | 138732390001 | ||||||
| MELVILLE, John Rex | Secretário | Haileywood 3 Birchen Lane RH16 1RY Haywards Heath West Sussex | British | 12057640001 | ||||||
| MOUNTFORD, Andrew Joseph | Secretário | c/o Uk Power Reserve Ltd Blenheim Court Warwick Road B91 2AA Solihull Radcliffe House West Midlands | 244885560001 | |||||||
| SULLIVAN, Beverley Joyce | Secretário | Grange House Grange Park Somerford Keynes GL7 6EW Cirencester Gloucestershire | British | 47891500002 | ||||||
| SULLIVAN, Beverley Joyce | Secretário | Grange House Grange Park Somerford Keynes GL7 6EW Cirencester Gloucestershire | British | 47891500002 | ||||||
| ADDIS, Jonathan Peter | Diretor | c/o Uk Power Reserve Ltd Blenheim Court Warwick Road B91 2AA Solihull Radcliffe House West Midlands | England | British | 260439420001 | |||||
| AHMAD, Nauman | Diretor | Wilton International TS90 8WS Middlesbrough Sembcorp Uk Headquarters United Kingdom | England | Pakistani | 246516040001 | |||||
| ALLEN, Anthony | Diretor | 7 Conway Road Hucclecote GL3 3PD Gloucester | British | 43845510001 | ||||||
| ARMOUR, Robert Malcolm | Diretor | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | United Kingdom | British | 50003350005 | |||||
| BERESFORD, Nigel Stephen | Diretor | c/o Edf Energy Grosvenor Place SW1X 7EN London 40 England | United Kingdom | English | 140458520001 | |||||
| BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor | Diretor | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 983300008 | ||||||
| BLISS, Simon Richard Weston | Diretor | Edgehill West Glen Road PA13 4PH Kilmalcolm | Scotland | British | 82638440001 | |||||
| BROOKSHAW, Terry | Diretor | Saddlers Field Bowbridge Lane, Prestbury GL52 3BJ Cheltenham Gloucestershire | British | 78425070001 | ||||||
| CLEMENTS, Andrew Arthur | Diretor | 27 Grange Court Road Westbury On Trym BS9 4DR Bristol | British | 52249820001 | ||||||
| COLEY, William Alfred | Diretor | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 90266090006 | ||||||
| DOWN, Leonard Michael | Diretor | 6 King Malcolm Close EH10 7JB Edinburgh | British | 58057730001 | ||||||
| EMRICH, Timothy Wayne | Diretor | c/o Uk Power Reserve Ltd Blenheim Court Warwick Road B91 2AA Solihull Radcliffe House West Midlands England | United Kingdom | American | 159180900001 | |||||
| HOLLINS, Peter Thomas | Diretor | 10d Kinnear Road EH3 5PE Edinburgh | British | 56803330002 | ||||||
| JEFFREY, Robin Campbell, Dr | Diretor | 71d Partickhill Road G11 5AD Glasgow | British | 34426500002 | ||||||
| JOHNSON, Christopher Brian | Diretor | 31 Merevale Road GL2 0QX Gloucester | United Kingdom | British | 46900180001 | |||||
| KIRWAN, Michael Ralph | Diretor | 18 Greenhill Gardens EH10 4BW Edinburgh Lothian | Scotland | British | 55649070001 | |||||
| KIRWAN, Michael Ralph | Diretor | 18 Greenhill Gardens EH10 4BW Edinburgh Lothian | Scotland | British | 55649070001 | |||||
| KUSTERER, Thomas Andreas | Diretor | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 United Kingdom | United Kingdom | German | 137548090001 | |||||
| LANGLEY, Michael James | Diretor | 13 Nelson Street EH3 6LF Edinburgh Midlothian | British | 70818670002 | ||||||
| LOUGH, Keith Geddes | Diretor | Lochside PA12 4JH Lochwinnoch Renfrewshire | United Kingdom | British | 101630860001 | |||||
| LOW, Michael Brian John | Diretor | Grange House Somerford Keynes GL7 6EW Cirencester Gloucestershire | British | 76638420001 | ||||||
| MACDONALD, Jean Elizabeth | Diretor | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | Scotland | British | 4947170004 | |||||
| MARSHALL, Richard Allan Jeffrey | Diretor | c/o British Energy Grosvenor Place SW1X 7EN London 40 United Kingdom | England | British | 151085170001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de DISTRICT ENERGY LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uk Power Reserve Ltd | 06/04/2016 | Blenheim Court B91 2AA Solihull 6th Floor, Radcliffe House England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
DISTRICT ENERGY LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Criado em 16/11/2015 Entregue em 20/11/2015 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição Aberaman park industrial estate aberaman aberdare t/no CYM18100. Please see image for details of further property charged. A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A registered charge | Criado em 16/11/2015 Entregue em 19/11/2015 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição Aberaman park industrial eatate, aberaman, aberdare t/no CYM18100. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged. A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A registered charge | Criado em 13/08/2014 Entregue em 20/08/2014 | Totalmente satisfeita | ||
A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A registered charge | Criado em 13/08/2014 Entregue em 20/08/2014 | Totalmente satisfeita | ||
Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 14/01/2005 Entregue em 17/01/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Sizewell power station and adjoining land suffolk t/no's SK160398,SK160390,SK160388 and SK155462, dungeness power station and adjoining land kent t/no 761827 hinkley point power station and adjoining land somerset t/no's ST127567 and st 127518 (for details of further properties charged please refer to form 395) first fixed charge all of its rights in and to the charged securities which are not scottish charge securities,floating charge,all its present and future assets,property,business,undertaking and uncalled capital and all rights under and in respect of any of the foregoing.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of amendment | Criado em 28/11/2002 Entregue em 16/12/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All obligations and liabilities due or to become due from each and every facility obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All rights under or in respect of the special accounts and all sums standing to the credit of such accounts and the intragroup receivables including all other assets and rights thereunder (fixed charge); floating charge over all future assets,property,business,undertaking, uncalled capital,rights and interests thereunder; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 26/09/2002 Entregue em 09/10/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição By way of fixed security all its rights under or in respect of the assigned assets, its whole right, title and interest, including all rights of action past, present and future, in and to any assigned assets, its intagroup receivables, the special accounts. By way of first floating charge, all its present and future assets, property, business, undertaking and uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0