DISTRICT ENERGY LIMITED

DISTRICT ENERGY LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaDISTRICT ENERGY LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02362017
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de DISTRICT ENERGY LIMITED?

    • produção de eletricidade (35110) / Fornecimento de eletricidade, gás, vapor e ar condicionado

    Onde fica DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    6th Floor, Radcliffe House
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    BRITISH ENERGY MERCHANT GENERATION LIMITED19/03/199919/03/1999
    BRITISH ENERGY INVESTMENT (NO.4) LIMITED26/02/199926/02/1999
    NE GENERATION LIMITED16/02/199416/02/1994
    NUCLEAR ELECTRIC (1990) LTD.06/04/199006/04/1990
    SIGNKIT LIMITED16/03/198916/03/1989

    Quais são as últimas contas de DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2018

    Quais são as últimas submissões para DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Nomeação de Mr Andrew Robert Koss como diretor em 03/08/2020

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Nauman Ahmad como diretor em 03/08/2020

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 19/06/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Sam Kieron Wither como diretor em 30/11/2019

    1 páginasTM01

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough TS90 8WS

    1 páginasAD03

    O endereço de inspeção do registo foi alterado para Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough TS90 8WS

    1 páginasAD02

    Contas anuais preparadas até 31/12/2018

    17 páginasAA

    Término da nomeação de Paul David Tomlinson como diretor em 30/09/2019

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 19/06/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Endereço do domicílio registado alterado de Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough Cleveland TS90 8WS England para 6th Floor, Radcliffe House Blenheim Court Solihull B91 2AA em 18/04/2019

    1 páginasAD01

    Nomeação de Mr Stephen Christopher Hands como secretário em 01/04/2019

    2 páginasAP03

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Uk Power Reserve Ltd Radcliffe House Blenheim Court Warwick Road Solihull West Midlands B91 2AA para Sembcorp Uk Headquarters Wilton International Middlesbrough Cleveland TS90 8WS em 18/04/2019

    1 páginasAD01

    Término da nomeação de Andrew Joseph Mountford como secretário em 01/04/2019

    1 páginasTM02

    Contas anuais preparadas até 31/03/2018

    17 páginasAA

    Nomeação de Mr Paul David Tomlinson como diretor em 12/02/2019

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Sriram Narayanan como diretor em 12/02/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Jonathan Peter Addis como diretor em 31/01/2019

    1 páginasTM01

    Satisfação total da garantia 023620170007

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 023620170008

    1 páginasMR04

    Declaração de confirmação apresentada em 19/06/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr Stephen Christopher Hands como diretor em 31/05/2018

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HANDS, Stephen Christopher
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    Secretário
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    257684290001
    HANDS, Stephen Christopher
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Diretor
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    EnglandBritish205116300001
    KOSS, Andrew Robert
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    Diretor
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    EnglandEnglish157160710002
    ALLEN, Anthony
    7 Conway Road
    Hucclecote
    GL3 3PD Gloucester
    Secretário
    7 Conway Road
    Hucclecote
    GL3 3PD Gloucester
    British43845510001
    ARMOUR, Robert Malcolm
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Secretário
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British50003350005
    ARMOUR, Robert Malcolm
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Secretário
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British50003350005
    GRANT, Paul Robert
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    England
    Secretário
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    England
    170448160001
    LAWRIE, Karen Nicola
    Bishops Frome
    WR6 5AS Worcester
    Boscombe House
    Worcestershire
    Secretário
    Bishops Frome
    WR6 5AS Worcester
    Boscombe House
    Worcestershire
    British138732390001
    MELVILLE, John Rex
    Haileywood
    3 Birchen Lane
    RH16 1RY Haywards Heath
    West Sussex
    Secretário
    Haileywood
    3 Birchen Lane
    RH16 1RY Haywards Heath
    West Sussex
    British12057640001
    MOUNTFORD, Andrew Joseph
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    Secretário
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    244885560001
    SULLIVAN, Beverley Joyce
    Grange House Grange Park
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    Secretário
    Grange House Grange Park
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    British47891500002
    SULLIVAN, Beverley Joyce
    Grange House Grange Park
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    Secretário
    Grange House Grange Park
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    British47891500002
    ADDIS, Jonathan Peter
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    Diretor
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    EnglandBritish260439420001
    AHMAD, Nauman
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Diretor
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    EnglandPakistani246516040001
    ALLEN, Anthony
    7 Conway Road
    Hucclecote
    GL3 3PD Gloucester
    Diretor
    7 Conway Road
    Hucclecote
    GL3 3PD Gloucester
    British43845510001
    ARMOUR, Robert Malcolm
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Diretor
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    United KingdomBritish50003350005
    BERESFORD, Nigel Stephen
    c/o Edf Energy
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    England
    Diretor
    c/o Edf Energy
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    England
    United KingdomEnglish140458520001
    BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Diretor
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British983300008
    BLISS, Simon Richard Weston
    Edgehill
    West Glen Road
    PA13 4PH Kilmalcolm
    Diretor
    Edgehill
    West Glen Road
    PA13 4PH Kilmalcolm
    ScotlandBritish82638440001
    BROOKSHAW, Terry
    Saddlers Field
    Bowbridge Lane, Prestbury
    GL52 3BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    Saddlers Field
    Bowbridge Lane, Prestbury
    GL52 3BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British78425070001
    CLEMENTS, Andrew Arthur
    27 Grange Court Road
    Westbury On Trym
    BS9 4DR Bristol
    Diretor
    27 Grange Court Road
    Westbury On Trym
    BS9 4DR Bristol
    British52249820001
    COLEY, William Alfred
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Diretor
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British90266090006
    DOWN, Leonard Michael
    6 King Malcolm Close
    EH10 7JB Edinburgh
    Diretor
    6 King Malcolm Close
    EH10 7JB Edinburgh
    British58057730001
    EMRICH, Timothy Wayne
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    England
    Diretor
    c/o Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    Warwick Road
    B91 2AA Solihull
    Radcliffe House
    West Midlands
    England
    United KingdomAmerican159180900001
    HOLLINS, Peter Thomas
    10d Kinnear Road
    EH3 5PE Edinburgh
    Diretor
    10d Kinnear Road
    EH3 5PE Edinburgh
    British56803330002
    JEFFREY, Robin Campbell, Dr
    71d Partickhill Road
    G11 5AD Glasgow
    Diretor
    71d Partickhill Road
    G11 5AD Glasgow
    British34426500002
    JOHNSON, Christopher Brian
    31 Merevale Road
    GL2 0QX Gloucester
    Diretor
    31 Merevale Road
    GL2 0QX Gloucester
    United KingdomBritish46900180001
    KIRWAN, Michael Ralph
    18 Greenhill Gardens
    EH10 4BW Edinburgh
    Lothian
    Diretor
    18 Greenhill Gardens
    EH10 4BW Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritish55649070001
    KIRWAN, Michael Ralph
    18 Greenhill Gardens
    EH10 4BW Edinburgh
    Lothian
    Diretor
    18 Greenhill Gardens
    EH10 4BW Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritish55649070001
    KUSTERER, Thomas Andreas
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Diretor
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    United KingdomGerman137548090001
    LANGLEY, Michael James
    13 Nelson Street
    EH3 6LF Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    13 Nelson Street
    EH3 6LF Edinburgh
    Midlothian
    British70818670002
    LOUGH, Keith Geddes
    Lochside
    PA12 4JH Lochwinnoch
    Renfrewshire
    Diretor
    Lochside
    PA12 4JH Lochwinnoch
    Renfrewshire
    United KingdomBritish101630860001
    LOW, Michael Brian John
    Grange House
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    Diretor
    Grange House
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    British76638420001
    MACDONALD, Jean Elizabeth
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Diretor
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    ScotlandBritish4947170004
    MARSHALL, Richard Allan Jeffrey
    c/o British Energy
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Diretor
    c/o British Energy
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    EnglandBritish151085170001

    Quem são as pessoas com controle significativo de DISTRICT ENERGY LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Uk Power Reserve Ltd
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    06/04/2016
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    6th Floor, Radcliffe House
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridade legalUk
    Local de registroEngland And Wales
    Número de registro7385282
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    DISTRICT ENERGY LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 16/11/2015
    Entregue em 20/11/2015
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Aberaman park industrial estate aberaman aberdare t/no CYM18100. Please see image for details of further property charged.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transações
    • 20/11/2015Registro de uma garantia (MR01)
    • 16/01/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 16/11/2015
    Entregue em 19/11/2015
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Aberaman park industrial eatate, aberaman, aberdare t/no CYM18100. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (in Its Capacity as Security Trustee)
    Transações
    • 19/11/2015Registro de uma garantia (MR01)
    • 16/01/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 13/08/2014
    Entregue em 20/08/2014
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Lombard North Central PLC
    Transações
    • 20/08/2014Registro de uma garantia (MR01)
    • 19/11/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 13/08/2014
    Entregue em 20/08/2014
    Totalmente satisfeita
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Lombard North Central PLC
    Transações
    • 20/08/2014Registro de uma garantia (MR01)
    • 19/11/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 14/01/2005
    Entregue em 17/01/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Sizewell power station and adjoining land suffolk t/no's SK160398,SK160390,SK160388 and SK155462, dungeness power station and adjoining land kent t/no 761827 hinkley point power station and adjoining land somerset t/no's ST127567 and st 127518 (for details of further properties charged please refer to form 395) first fixed charge all of its rights in and to the charged securities which are not scottish charge securities,floating charge,all its present and future assets,property,business,undertaking and uncalled capital and all rights under and in respect of any of the foregoing.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nuclear Generation Decommissioning Fund Limited
    Transações
    • 17/01/2005Registro de uma garantia (395)
    • 11/02/2010Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 27/01/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of amendment
    Criado em 28/11/2002
    Entregue em 16/12/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All obligations and liabilities due or to become due from each and every facility obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All rights under or in respect of the special accounts and all sums standing to the credit of such accounts and the intragroup receivables including all other assets and rights thereunder (fixed charge); floating charge over all future assets,property,business,undertaking, uncalled capital,rights and interests thereunder; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transações
    • 16/12/2002Registro de uma garantia (395)
    • 17/01/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 26/09/2002
    Entregue em 09/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of fixed security all its rights under or in respect of the assigned assets, its whole right, title and interest, including all rights of action past, present and future, in and to any assigned assets, its intagroup receivables, the special accounts. By way of first floating charge, all its present and future assets, property, business, undertaking and uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transações
    • 09/10/2002Registro de uma garantia (395)
    • 17/01/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0