GIBB HOLDINGS LTD

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaGIBB HOLDINGS LTD
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02387714
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de GIBB HOLDINGS LTD?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica GIBB HOLDINGS LTD?

    Endereço do escritório registrado
    Cottons Centre
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de GIBB HOLDINGS LTD?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    GIBB LIMITED18/09/198918/09/1989
    CHULSAVALE LIMITED22/05/198922/05/1989

    Quais são as últimas contas de GIBB HOLDINGS LTD?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até01/10/2021

    Quais são as últimas submissões para GIBB HOLDINGS LTD?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Nomeação de Mr Geoffrey Roberts como secretário em 21/08/2023

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Rhona Mary Holman como secretário em 21/08/2023

    1 páginasTM02

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Estado do capital em 29/06/2023

    • Capital: GBP 0.40412
    5 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Nomeação de Rhona Mary Holman como secretário em 10/02/2023

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Tejender Singh Chaudhary como secretário em 10/02/2023

    1 páginasTM02

    Declaração de confirmação apresentada em 20/01/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mrs Katherine Helen Kenny como diretor em 15/12/2022

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Hugh Donald Morrison como diretor em 15/12/2022

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 01/10/2021

    24 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 20/01/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 02/10/2020

    26 páginasAA

    Nomeação de Mrs Sally Miles como diretor em 11/08/2021

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Guy Douglas como diretor em 11/08/2021

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 20/01/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2019

    26 páginasAA

    Término da nomeação de Jonathan R. Shattock como diretor em 30/11/2020

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Hugh Donald Morrison como diretor em 30/11/2020

    2 páginasAP01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Guy Douglas em 17/12/2020

    2 páginasCH01

    Alteração dos detalhes de Jacobs Uk Limited como pessoa com controlo significativo em 02/11/2020

    2 páginasPSC05

    Quem são os diretores de GIBB HOLDINGS LTD?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ROBERTS, Geoffrey
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Secretário
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    312725290001
    KENNY, Katherine Helen
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Diretor
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish216980410001
    MILES, Sally Linda Joyce
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Diretor
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    EnglandBritish161125950001
    CHAUDHARY, Tejender Singh
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Secretário
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    246698880001
    HOLMAN, Rhona Mary
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Secretário
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    305629180001
    MARKLEY, William Clyde
    2105 Sunnybank Drive
    La Canada
    91011 Flintridge
    California
    United States Of America
    Secretário
    2105 Sunnybank Drive
    La Canada
    91011 Flintridge
    California
    United States Of America
    American57955380001
    NORRIS, Michael Timothy
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretário
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    British52563600002
    UDOVIC, Michael Sean
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretário
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    165335900001
    WARD, Sandra Lesley
    17 Clayfields
    HP10 8AT Tylers Green
    Bucks
    Secretário
    17 Clayfields
    HP10 8AT Tylers Green
    Bucks
    British89320390001
    WITHERS, Graham Reginald
    33 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    Secretário
    33 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    British1420080001
    BACK, Paul Adrian Auchmuty, Dr
    Parsonage Farm
    How Lane
    SL6 3JP White Waltham
    Berkshire
    Diretor
    Parsonage Farm
    How Lane
    SL6 3JP White Waltham
    Berkshire
    British22932520001
    BARBER, Walter Charles
    61 Riverside House
    Bear Wharf Fobney Street
    RG1 6BJ Reading
    Berkshire
    Diretor
    61 Riverside House
    Bear Wharf Fobney Street
    RG1 6BJ Reading
    Berkshire
    American93663320001
    BOWCOCK, John Brown
    Lothlorien
    Crowsley Road
    RG9 3JU Shiplake
    Oxfordshire
    Diretor
    Lothlorien
    Crowsley Road
    RG9 3JU Shiplake
    Oxfordshire
    British34950050001
    BRETTELL, Peter Donald
    Blorenge Cottage
    Holly Lane Ashampstead
    RG8 8RT Reading
    Berkshire
    Diretor
    Blorenge Cottage
    Holly Lane Ashampstead
    RG8 8RT Reading
    Berkshire
    British34455550003
    BRICE, Geoffrey John
    3 Orwell Close
    Caversham
    RG4 7PU Reading
    Berkshire
    Diretor
    3 Orwell Close
    Caversham
    RG4 7PU Reading
    Berkshire
    British7239880001
    COATES, Geoffrey Hamilton
    The Shealing
    Backsideans Wargrave-On-Thames
    RG10 8JP Reading
    Berkshire
    Diretor
    The Shealing
    Backsideans Wargrave-On-Thames
    RG10 8JP Reading
    Berkshire
    British1420060001
    COLES, Bruce Charles
    703 Henley Fields Circle
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30155
    Usa
    Diretor
    703 Henley Fields Circle
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30155
    Usa
    American49990460001
    DANGER, James Ivan
    2694 Northbrook Drive
    Atlanta
    FOREIGN Georgia 30340
    Usa
    Diretor
    2694 Northbrook Drive
    Atlanta
    FOREIGN Georgia 30340
    Usa
    American43472160001
    DAWSON, James Grant Forbes
    Woodpeckers
    Pangbourne Hill
    RG8 8JS Pangbourne
    Berkshire
    Diretor
    Woodpeckers
    Pangbourne Hill
    RG8 8JS Pangbourne
    Berkshire
    British32689240001
    DOUGLAS, Guy
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Diretor
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish258025190001
    DOYLE, John Conor
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandIrish78009780001
    DUFF, Robert Shepherd
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish165632810001
    ELLIS, David
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    Diretor
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United KingdomBritish206422550001
    FOOSHEE, Robert Brown
    9000 Etching Overlook Drive
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30097
    Usa
    Diretor
    9000 Etching Overlook Drive
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30097
    Usa
    American49990480001
    HENNESSEY, John Richard
    Folly Farm
    Barkham Road
    RG11 4BS Wokingham
    Berkshire
    Diretor
    Folly Farm
    Barkham Road
    RG11 4BS Wokingham
    Berkshire
    British22928530001
    IRVIN, Robert Anthony Michael
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish161055320001
    JONES, Graham Roger
    Coningsby 81 The Rise
    TN13 1RN Sevenoaks
    Kent
    Diretor
    Coningsby 81 The Rise
    TN13 1RN Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish42069750001
    MONTGOMERY, Michael Wayne
    Red Fox Cottage
    Old Bath Road Sonning
    RG4 0TA Reading
    Berkshire
    Diretor
    Red Fox Cottage
    Old Bath Road Sonning
    RG4 0TA Reading
    Berkshire
    American32725930002
    MORRISON, Hugh Donald
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Diretor
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish240150920001
    SEHGAL, Raghbir Kumar
    55 Cliffside Crossing
    Atlanta
    Georgia Ga 30338
    Usa
    Diretor
    55 Cliffside Crossing
    Atlanta
    Georgia Ga 30338
    Usa
    American32725940001
    SHATTOCK, Jonathan R.
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Diretor
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish259549880001
    STANCOMBE, Christopher John
    8 Wellington Gardens
    Southend Bradfield
    RG7 6EJ Reading
    Berkshire
    Diretor
    8 Wellington Gardens
    Southend Bradfield
    RG7 6EJ Reading
    Berkshire
    EnglandBritish33841950002
    STEINBRENNER, Frederick James
    5707 Brynwood Circle
    30101 Georgia
    Usa
    Diretor
    5707 Brynwood Circle
    30101 Georgia
    Usa
    American7239910004
    TAYLOR, Allyn Byram
    Mill Lane
    Cookham
    SL6 9QT Maidenhead
    Formosa Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Mill Lane
    Cookham
    SL6 9QT Maidenhead
    Formosa Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandUnited States124922150002
    WALKER, William Allen
    3345 Robinson Farms Court
    Marietta
    FOREIGN Atlanta
    Georgia Ga 30068
    Usa
    Diretor
    3345 Robinson Farms Court
    Marietta
    FOREIGN Atlanta
    Georgia Ga 30068
    Usa
    American15467690004

    Quem são as pessoas com controle significativo de GIBB HOLDINGS LTD?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Jacobs Uk Limited
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    06/04/2016
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroEngland Companies Registry
    Número de registro02594504
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    GIBB HOLDINGS LTD possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Deed of rectification and supplemental charge
    Criado em 03/11/1995
    Entregue em 22/11/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    13% of the issued share capital of prointec sa being: 300,000 pesetas............................13 Common stock of pesetas,100,000 numbered 8-18 and 21 and 94; all stocks,shares,bonds,debentures,notes...etc..........all dividends/other income and all rights,benefits,money or property..................all repayments of principal on loan notes.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Suntrust Bank,Atlanta
    Transações
    • 22/11/1995Registro de uma garantia (395)
    • 31/01/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 13/10/1995
    Entregue em 18/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 18/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 31/01/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over shares
    Criado em 11/10/1995
    Entregue em 18/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to suntrust bank,atlanta for itself and as agent and trustee on behalf of the lenders (as defined)to each lender in any currency and whether or not the lender in question shall have been a party to the original transaction except any money or liabilities due by any company as guarantor for the depositor
    Breve descrição
    The securities all dividends distributions interest and other income all accretions of a capital nature and all capital sums received. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Suntrust Bank Atlanta
    Transações
    • 18/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 31/01/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    First charge
    Criado em 08/10/1993
    Entregue em 13/10/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities (i)of law companies group,inc.to trust company bank and other banks under a credit agreement dated 8 october 1993 (us$42,000,000 together with interest,charges and costs)(ii)of law companies group,inc.to trust company bank under a reimbursement agreement dated 8 october 1993 (all amounts due under letters of credit issued by trust company bank)(iii)of law companies group,inc.and sir alexander gibb & partners limited to barclays bank PLC under a facility letter dated 8 october 1993 (£16,900,000 together with interest charges and costs)(iv)of gibb limited to barclays bank PLC under a commercial mortgage facility letter dated 8 february 1990 (£495,900 together with interest charges and costs) and (v)the obligations of certain partnerships and companies defined as sir alexander gibb partnerships to barclays bank PLC (£2,000,000 together with interest,charges and costs)and amounts due under the indemnity contained in clause 15.3 of the first charge
    Breve descrição
    2,217,800 shares of £1 each in sir alexander gibb & partners limited together with any substituted or additional shares or other securities and further including all allotments,accretions,offers,voting or other rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Trust Company Bankertain Other Banksas Collateral Agent and Trustee for Itself and C
    Transações
    • 13/10/1993Registro de uma garantia (395)
    • 05/02/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 02/03/1990
    Entregue em 07/03/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Flat 5, 2 hyde park street, london W2. Title no. Ngl 617261.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 07/03/1990Registro de uma garantia
    • 31/01/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 22/08/1989
    Entregue em 24/08/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transações
    • 24/08/1989Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0