CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED

CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02388832
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    4th Floor 24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    INNOVATIVE FRANCHISING LIMITED24/05/198924/05/1989

    Quais são as últimas contas de CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/04/2021

    Quais são as últimas submissões para CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória

    1 páginasGAZ2

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Alteração dos detalhes de Independent Group (Uk) Limited como pessoa com controlo significativo em 06/01/2023

    2 páginasPSC05

    Término da nomeação de Rjp Secretaries Limited como secretário em 25/01/2023

    1 páginasTM02

    Nomeação de Cossey Cosec Services Limited como secretário em 25/01/2023

    2 páginasAP04

    Endereço do domicílio registado alterado de Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom para 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW em 06/01/2023

    1 páginasAD01

    Notificação de Independent Group (Uk) Limited como pessoa com controlo significativo em 31/10/2022

    2 páginasPSC02

    Cessação de Aghoco 1022 Limited como pessoa com controlo significativo em 31/10/2022

    1 páginasPSC07

    Alteração dos detalhes de Gold Round Limited como pessoa com controlo significativo em 25/07/2022

    2 páginasPSC05

    Detalhes do diretor alterados para Gold Round Limited em 25/07/2022

    1 páginasCH02

    Declaração de confirmação apresentada em 24/05/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/04/2021

    6 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Stuart Pace em 21/07/2021

    2 páginasCH01

    Declaração de confirmação apresentada em 24/05/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/04/2020

    7 páginasAA

    Término da nomeação de Alan Albert Horton como diretor em 30/06/2020

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Stuart Pace em 29/06/2020

    2 páginasCH01

    Declaração de confirmação apresentada em 24/05/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Alteração dos detalhes de Gold Round Limited como pessoa com controlo significativo em 18/04/2016

    2 páginasPSC05

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/04/2019

    7 páginasAA

    Detalhes do secretário alterados para Rjp Secretaries Limited em 09/08/2019

    1 páginasCH04

    Alteração dos detalhes de Aghoco 1022 Limited como pessoa com controlo significativo em 09/08/2019

    2 páginasPSC05

    Endereço do domicílio registado alterado de 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR England para Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL em 12/08/2019

    1 páginasAD01

    Declaração de confirmação apresentada em 24/05/2019 com atualizações

    4 páginasCS01

    Satisfação total da garantia 11

    1 páginasMR04

    Quem são os diretores de CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    COSSEY COSEC SERVICES LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Secretário
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro14344691
    302964180001
    PACE, Stuart
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Diretor
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish207506130003
    GOLD ROUND LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Diretor
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro05687325
    149588400001
    DALES, Shirley
    27 South Parade
    Leven
    HU17 5LJ Beverley
    North Humberside
    Secretário
    27 South Parade
    Leven
    HU17 5LJ Beverley
    North Humberside
    British10362760002
    GARBETT, Anna Marie
    25 Tanhill Wilnecote
    B77 4LF Tamworth
    Staffordshire
    Secretário
    25 Tanhill Wilnecote
    B77 4LF Tamworth
    Staffordshire
    British28626350001
    GREY, Elizabeth Jane
    6301 Vintage Oak Lane
    Salt Lake City Utah 84121
    FOREIGN Usa
    Secretário
    6301 Vintage Oak Lane
    Salt Lake City Utah 84121
    FOREIGN Usa
    British13020220004
    JOHNSTON, Iain
    3 Scholes Park Road
    YO12 6RE Scarborough
    North Yorkshire
    Secretário
    3 Scholes Park Road
    YO12 6RE Scarborough
    North Yorkshire
    Uk702270001
    MAUGHAN, Anna
    404 Chester Road
    Boldmere
    B73 5BS Sutton Coldfield
    Secretário
    404 Chester Road
    Boldmere
    B73 5BS Sutton Coldfield
    British53071850001
    THOMAS, Caroline Emma Roberts
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    Secretário
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    British154322040001
    RJP SECRETARIES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro02989995
    61999120002
    ABBOTTS, Michael Anthony
    40 Balmoral Road Four Oaks
    B74 4UE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    40 Balmoral Road Four Oaks
    B74 4UE Sutton Coldfield
    West Midlands
    British55787590001
    ANNISON, Roger Neil
    19 Sackville Close
    HU17 8XF Beverley
    East Yorkshire
    Diretor
    19 Sackville Close
    HU17 8XF Beverley
    East Yorkshire
    British69954830003
    BELK, Andrew John
    Pen Plannau
    Moelfre
    SY10 7QL Llansilin
    North Wales
    Diretor
    Pen Plannau
    Moelfre
    SY10 7QL Llansilin
    North Wales
    British65603000003
    BELL, Jonathan
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish123082590001
    CARLISLE, Ian
    The Clock House
    West End Road Box End
    MK43 8RT Kempston Rural
    Bedfordshire
    Diretor
    The Clock House
    West End Road Box End
    MK43 8RT Kempston Rural
    Bedfordshire
    EnglandBritish146715900001
    DALES, Shirley
    27 South Parade
    Leven
    HU17 5LJ Beverley
    North Humberside
    Diretor
    27 South Parade
    Leven
    HU17 5LJ Beverley
    North Humberside
    British10362760002
    DICKINSON, Louise
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Diretor
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish139480580001
    GREY, Elizabeth Jane
    6301 Vintage Oak Lane
    Salt Lake City Utah 84121
    FOREIGN Usa
    Diretor
    6301 Vintage Oak Lane
    Salt Lake City Utah 84121
    FOREIGN Usa
    British13020220004
    GREY, Robin Francis
    5272 Goldspring Place
    Chillingwalk
    FOREIGN British Colombia
    V 2r 373
    Canada
    Diretor
    5272 Goldspring Place
    Chillingwalk
    FOREIGN British Colombia
    V 2r 373
    Canada
    British33733380005
    HORTON, Alan Albert
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish182208240001
    JOHNSTON, Iain
    3 Scholes Park Road
    YO12 6RE Scarborough
    North Yorkshire
    Diretor
    3 Scholes Park Road
    YO12 6RE Scarborough
    North Yorkshire
    United KingdomUk702270001
    JOLLY, Adrian Richard
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Diretor
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    United KingdomBritish87664160001
    LEE, Peter Francis
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Diretor
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish207608120001
    LEES, Stuart
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Diretor
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish70032700001
    LLOYD-JONES, Andrew Mark
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Diretor
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish149155620001
    ROCKETT, Matthew Ian
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Diretor
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    BritishBritish146169560001
    ROCKETT, Matthew Ian
    Trent Walk
    Welton Grange
    HU15 1GF Brough
    7
    East Yorkshire
    Diretor
    Trent Walk
    Welton Grange
    HU15 1GF Brough
    7
    East Yorkshire
    BritishBritish146169560001
    SMITH, Andrew John
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    Diretor
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    United KingdomBritish207506140001
    SMITH, Andrew John
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    Diretor
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    UkBritish149018750001
    SMITH, Robert John
    16 Chelsea Drive
    Four Oaks
    B74 4UG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    16 Chelsea Drive
    Four Oaks
    B74 4UG Sutton Coldfield
    West Midlands
    British109244130001
    TAYLOR, Mark Andrew
    Westlands
    Queensgate
    HU17 8NE Beverley
    Diretor
    Westlands
    Queensgate
    HU17 8NE Beverley
    United KingdomBritish95264700003

    Quem são as pessoas com controle significativo de CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Independent Group (Uk) Limited
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    31/10/2022
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroEngland And Wales
    Número de registro06732498
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    18/04/2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUnited Kingdom
    Local de registroCompanies House
    Número de registro05687325
    Natureza do controle
    • A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, uma influência ou controle significativo sobre a empresa.
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    06/04/2016
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Sim
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro07200489
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    United Kingdom
    06/04/2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    United Kingdom
    Sim
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUnited Kingdom
    Local de registroCompanies House
    Número de registro05687325
    Natureza do controle
    • A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, uma influência ou controle significativo sobre a empresa.

    CHEM-DRY MIDLANDS AND LONDON LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 01/09/2016
    Entregue em 13/09/2016
    Pendente
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Blackstar 2016 Limited
    Transações
    • 13/09/2016Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 03/06/2016
    Entregue em 17/06/2016
    Pendente
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Secure Trust Bank PLC
    Transações
    • 17/06/2016Registro de uma garantia (MR01)
    A composite guarantee and debenture
    Criado em 31/01/2011
    Entregue em 08/02/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Andrew Lloyd-Jones
    Transações
    • 08/02/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 28/03/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    A deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 26 june 2009
    Criado em 31/01/2011
    Entregue em 08/02/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transações
    • 08/02/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 31/05/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 31/01/2011
    Entregue em 03/02/2011
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transações
    • 03/02/2011Registro de uma garantia (MG01)
    A composite guarantee and debenture
    Criado em 31/07/2010
    Entregue em 07/08/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Evander Limited
    Transações
    • 07/08/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 02/02/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 30/07/2010
    Entregue em 10/08/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the chargor to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (Security Trustee)
    Transações
    • 10/08/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 02/02/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 30/07/2010
    Entregue em 05/08/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 05/08/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 02/02/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 24/09/2009
    Entregue em 14/10/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from ingleby (1823) limited to the noteholders on any account whatsoever and all other monies due or to become due from any charging company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the property and assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Pessoas com direito
    • Jonathan Simpson-Dent (As Security Trustee)
    Transações
    • 14/10/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 04/08/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 24/09/2009
    Entregue em 03/10/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 03/10/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 02/02/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Composite guarantee and debentures
    Criado em 24/09/2009
    Entregue em 02/10/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the note issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transações
    • 02/10/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 04/08/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal mortgage
    Criado em 14/06/2000
    Entregue em 16/06/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The f/h property k/a 3 kettlebrook road tamworth stafforshire t/n's SF153292 and SF340069. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 16/06/2000Registro de uma garantia (395)
    • 08/04/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 05/11/1998
    Entregue em 13/11/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 13/11/1998Registro de uma garantia (395)
    • 08/04/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0