CSB HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCSB HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaLiquidação
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02397837
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CSB HOLDINGS LIMITED?

    • Outras atividades de serviços de tecnologia da informação (62090) / Informação e comunicação

    Onde fica CSB HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CSB HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CSB HOLDINGS PLC30/04/199330/04/1993
    1992 SPECIALISTS LTD.22/06/198922/06/1989

    Quais são as últimas contas de CSB HOLDINGS LIMITED?

    VencidoSim
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/03/2022
    Próximas contas vencem em31/03/2023
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2021

    Qual é o status da última declaração de confirmação para CSB HOLDINGS LIMITED?

    VencidoSim
    Última declaração de confirmação elaborada até22/06/2023
    Próxima declaração de confirmação vence06/07/2023
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até22/06/2022
    VencidoSim

    Quais são as últimas submissões para CSB HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 30/11/2024

    16 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 30/11/2023

    10 páginasLIQ03

    Endereço do domicílio registado alterado de The Coins Building 11 st Laurence Way Slough Berkshire SL1 2EA para 79 Caroline Street Birmingham B3 1UP em 13/12/2022

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    5 páginasLIQ01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 01/12/2022

    LRESSP

    Término da nomeação de Richard Louis Werner como diretor em 29/11/2022

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Michael Timothy James como diretor em 29/11/2022

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Adrian Halls como diretor em 25/11/2022

    2 páginasAP01

    Satisfação total da garantia 5

    1 páginasMR04

    Declaração de confirmação apresentada em 22/06/2022 com atualizações

    8 páginasCS01

    Memorando e estatutos

    31 páginasMA

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 09/03/2022

    • Capital: GBP 103,392.52
    3 páginasSH01

    Término da nomeação de Derek Leaver como diretor em 25/02/2022

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Nigel Leslie Cope como diretor em 25/02/2022

    1 páginasTM01

    Contas consolidadas preparadas até 31/03/2021

    53 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 22/06/2021 com atualizações

    9 páginasCS01

    Compra de ações próprias.

    3 páginasSH03
    Anotações
    DataAnotação
    14/05/2021Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Cancelamento de ações. Estado do capital em 02/03/2021

    • Capital: GBP 103,392.51
    4 páginasSH06

    Contas consolidadas preparadas até 31/03/2020

    50 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 22/06/2020 com atualizações

    8 páginasCS01

    Contas consolidadas preparadas até 31/03/2019

    54 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 22/06/2019 com atualizações

    9 páginasCS01

    Resoluções

    Resolutions
    47 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Quem são os diretores de CSB HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HALLS, Adrian
    Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    79
    Secretário
    Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    79
    193455080001
    ARMITAGE, Timothy Peter
    Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    79
    Diretor
    Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    79
    United KingdomBritishCompany Director49179200001
    HALLS, Adrian
    Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    79
    Diretor
    Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    79
    EnglandBritishCertified Accountant302647360001
    SULLIVAN, Lawrence John
    Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    79
    Diretor
    Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    79
    United KingdomBritishCompany Director2247440002
    BAKER, Philip
    11 St Laurence Way
    SL1 2EA Slough
    The Coins Building
    Berkshire
    England
    Secretário
    11 St Laurence Way
    SL1 2EA Slough
    The Coins Building
    Berkshire
    England
    BritishChief Financial Officer119678640001
    CHAPMAN, Stuart Victor
    Arbrook
    44 St. Mary`S Road
    KT22 8EY Leatherhead
    Surrey
    Secretário
    Arbrook
    44 St. Mary`S Road
    KT22 8EY Leatherhead
    Surrey
    British11854090001
    CLAIR, Peter
    11 Ackmar Road
    Parsons Green
    SW6 4UP London
    Secretário
    11 Ackmar Road
    Parsons Green
    SW6 4UP London
    British47537030001
    COPE, Nigel Leslie
    119 Burnham Lane
    SL1 6LA Burnham
    Berkshire
    Secretário
    119 Burnham Lane
    SL1 6LA Burnham
    Berkshire
    BritishMarketing Director97685670001
    COPE, Nigel Leslie
    129 Mortlake Road
    Kew
    TW9 4AW Richmond
    Surrey
    Secretário
    129 Mortlake Road
    Kew
    TW9 4AW Richmond
    Surrey
    British13511870001
    DAY, Simon Philip
    23 Ash Green
    Great Chesterford
    CB10 1QR Saffron Walden
    Essex
    Secretário
    23 Ash Green
    Great Chesterford
    CB10 1QR Saffron Walden
    Essex
    British71393050001
    FEERY, Stephen Joseph
    131 Chalklands
    SL8 5TL Bourne End
    Buckinghamshire
    Secretário
    131 Chalklands
    SL8 5TL Bourne End
    Buckinghamshire
    British21558970001
    ARMITAGE, Timothy Peter
    Sandford Barn Sandford Lane
    Woodley
    RG5 4TB Reading
    Berkshire
    Diretor
    Sandford Barn Sandford Lane
    Woodley
    RG5 4TB Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector49179200001
    CHAPMAN, Paul George
    Rosebank 4 Shortsill Lane
    Flaxby
    HG5 0RT Knaresborough
    North Yorkshire
    Diretor
    Rosebank 4 Shortsill Lane
    Flaxby
    HG5 0RT Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector24182580002
    COPE, Nigel Leslie
    11 St Laurence Way
    SL1 2EA Slough
    The Coins Building
    Berkshire
    England
    Diretor
    11 St Laurence Way
    SL1 2EA Slough
    The Coins Building
    Berkshire
    England
    United Arab EmiratesBritishCompany Director97685670004
    FEERY, Stephen Joseph
    131 Chalklands
    SL8 5TL Bourne End
    Buckinghamshire
    Diretor
    131 Chalklands
    SL8 5TL Bourne End
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director21558970001
    GAY, Andrew
    Bircham Dyson Bell
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    Diretor
    Bircham Dyson Bell
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    United KingdomBritishCompany Director73774260004
    JACKSON, George Barry
    Willow Cottage Church Lane
    Boxgrove
    PO18 0ED Chichester
    West Sussex
    Diretor
    Willow Cottage Church Lane
    Boxgrove
    PO18 0ED Chichester
    West Sussex
    EnglandBritishDirector24677720001
    JAMES, Michael Timothy
    11 St Laurence Way
    SL1 2EA Slough
    The Coins Building
    Berkshire
    England
    Diretor
    11 St Laurence Way
    SL1 2EA Slough
    The Coins Building
    Berkshire
    England
    EnglandBritishCompany Director114453240001
    LEAVER, Derek
    11 St Laurence Way
    SL1 2EA Slough
    The Coins Building
    Berkshire
    England
    Diretor
    11 St Laurence Way
    SL1 2EA Slough
    The Coins Building
    Berkshire
    England
    EnglandBritishDirector58541610002
    LIDGATE, Stephen Robert
    The Coins Building
    12 The Grove
    SL1 1QP Slough
    Berkshire
    Diretor
    The Coins Building
    12 The Grove
    SL1 1QP Slough
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director103537740001
    MORLEY, Sean Maurice Hill
    143 Percy Road
    TW12 2JP Hampton
    Middlesex
    Diretor
    143 Percy Road
    TW12 2JP Hampton
    Middlesex
    BritishProject Manager77050730003
    OBRIEN, David
    Copyhold
    Chertsey Road
    GU24 8HS Chobham
    Surrey
    Diretor
    Copyhold
    Chertsey Road
    GU24 8HS Chobham
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director6759900001
    SHAW, Laurence David
    11 St Laurence Way
    SL1 2EA Slough
    The Coins Building
    Berkshire
    England
    Diretor
    11 St Laurence Way
    SL1 2EA Slough
    The Coins Building
    Berkshire
    England
    EnglandBritishBritish4482600002
    SKINNER, Gordon William Ford
    Bayshill House
    Templewood Park Templewood Lane
    SL2 4DA Slough
    Diretor
    Bayshill House
    Templewood Park Templewood Lane
    SL2 4DA Slough
    EnglandBritishDirector150542080001
    SMITH, Colin
    7 Iver Lodge
    Bangors Road South
    SL0 0AW Iver
    Buckinghamshire
    Diretor
    7 Iver Lodge
    Bangors Road South
    SL0 0AW Iver
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director70557860003
    SWANSON, Thomas Hillis
    Tigh Na Bruaich Laigh Braehead
    Braehead Road Thorntonhall
    G74 5AQ Glasgow
    Diretor
    Tigh Na Bruaich Laigh Braehead
    Braehead Road Thorntonhall
    G74 5AQ Glasgow
    United KingdomBritishCompany Director86147070001
    WERNER, Richard Louis
    11 St Laurence Way
    SL1 2EA Slough
    The Coins Building
    Berkshire
    England
    Diretor
    11 St Laurence Way
    SL1 2EA Slough
    The Coins Building
    Berkshire
    England
    United StatesAmericanExecutive121290680001

    Quem são as pessoas com controle significativo de CSB HOLDINGS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Mr Lawrence John Sullivan
    Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    79
    06/04/2016
    Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    79
    Não
    Nacionalidade: British
    País de residência: United Kingdom
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 50% mas não mais de 75% das ações da empresa.

    CSB HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Guarantee & debenture
    Criado em 26/07/2007
    Entregue em 06/08/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 06/08/2007Registro de uma garantia (395)
    • 28/09/2022Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 10/05/2003
    Entregue em 30/05/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transações
    • 30/05/2003Registro de uma garantia (395)
    • 23/08/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 21/12/1994
    Entregue em 21/12/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 21/12/1994Registro de uma garantia (395)
    • 13/08/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee an debenture
    Criado em 14/09/1994
    Entregue em 30/09/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 30/09/1994Registro de uma garantia (395)
    • 13/08/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 01/02/1994
    Entregue em 04/02/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 04/02/1994Registro de uma garantia (395)
    • 14/01/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    CSB HOLDINGS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    01/12/2022Início da liquidação
    01/12/2022Data da declaração de solvência jurada
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Roderick Graham Butcher
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    Profissional
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0