MH VOKES AIR UK LIMITED

MH VOKES AIR UK LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaMH VOKES AIR UK LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02400211
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de MH VOKES AIR UK LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica MH VOKES AIR UK LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de MH VOKES AIR UK LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    VOKES AIR UK LIMITED26/08/200826/08/2008
    SPX VOKES LIMITED13/01/200613/01/2006
    MCLEOD RUSSEL INTERNATIONAL LIMITED03/08/199803/08/1998
    WHEWAY INTERNATIONAL LIMITED15/08/198915/08/1989
    VOWDIN LIMITED03/07/198903/07/1989

    Quais são as últimas contas de MH VOKES AIR UK LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2013

    Quais são as últimas submissões para MH VOKES AIR UK LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Término da nomeação de George Henry Black como diretor em 23/02/2017

    2 páginasTM01

    Diversos

    Statemenbt of fact - name correction - mh vokes air uk LIMITED LIMITED - mh vokes air uk LIMITED
    1 páginasMISC

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Aviso de alteração do nome"

    2 páginasCONNOT

    Restauração por ordem judicial

    4 páginasAC92

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed mann + hummel vokes air uk\certificate issued on 04/11/16
    páginasCERTNM
    Anotações
    DataAnotação
    09/11/2016Clarification changed its name on 04/11/2016 to MH VOKES AIR UK LIMITED and not the name MH VOKES AIR UK LIMITED LIMITED as incorrectly shown on the face of the certificate of change of name issued on that date.

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Segunda apresentação de AR01 previamente entregue à Companies House elaborado em 12/10/2014

    16 páginasRP04

    Declaração anual preparada até 12/10/2014 com lista completa de acionistas

    15 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital21/10/2014

    Estado do capital em 21/10/2014

    • Capital: GBP 10,000,001
    SH01
    Anotações
    DataAnotação
    11/11/2014Clarification A second filed AR01 was registered on 11/11/2014

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    16 páginasAA

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed vokes air uk LIMITED\certificate issued on 28/03/14
    3 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name28/03/2014

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Aviso de alteração do nome"

    2 páginasCONNOT

    Nomeação de Steffen Schneider como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Thomas Blomqvist como secretário

    2 páginasTM02

    Término da nomeação de Thomas Blomqvist como diretor

    2 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2012

    16 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para George Henry Black em 19/10/2013

    3 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 12/10/2013 com lista completa de acionistas

    14 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital18/10/2013

    Estado do capital em 18/10/2013

    • Capital: GBP 10,000,001
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para George Henry Black em 19/10/2012

    3 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 12/10/2012 com lista completa de acionistas

    14 páginasAR01

    Quem são os diretores de MH VOKES AIR UK LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SCHNEIDER, Steffen
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Diretor
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    GermanyGerman185882550001
    BLOMQVIST, Thomas
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Secretário
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Swedish132005410001
    SOHAL, Balkar
    5 North Park
    NG18 4PA Mansfield
    Nottinghamshire
    Secretário
    5 North Park
    NG18 4PA Mansfield
    Nottinghamshire
    British122186580001
    M.R. SERVICES LIMITED
    C/O Vokes-Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Secretário
    C/O Vokes-Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    55567600012
    MR SERVICES LIMITED
    Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way
    Abingdon Business Park
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    Secretário
    Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way
    Abingdon Business Park
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    55567600003
    WHEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Suite Two Hitching Court
    Blacklands Way Abingdon Business Par
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    Secretário
    Suite Two Hitching Court
    Blacklands Way Abingdon Business Par
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    39955810002
    BLACK, George Henry
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Diretor
    C/O Vokes Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    UkBritish151256750002
    BLOMQVIST, Thomas
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Diretor
    Stureparken 11 4th Floor
    Stockholm 114 26
    Sweden
    Swedish132005410001
    BOSWELL, Brian Peter
    Garden Cottage Hawford House
    Hawford
    WR3 7SQ Worcester
    Worcestershire
    Diretor
    Garden Cottage Hawford House
    Hawford
    WR3 7SQ Worcester
    Worcestershire
    British52804120001
    BRICKER, Ross Benjamin
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Diretor
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Canadian105172080001
    COLE, Ian Robert
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    Diretor
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    British42980510001
    COTTON, Richard John
    148 Myton Road
    CV34 6PR Warwick
    Diretor
    148 Myton Road
    CV34 6PR Warwick
    EnglandBritish45397090001
    DOHERTY, James Patrick
    950 S E 82nd Street Road
    Ocala
    Florida 34480
    Diretor
    950 S E 82nd Street Road
    Ocala
    Florida 34480
    Irish105328280001
    FERRARI, Fabio
    Lot Chirouzanches 05240
    La Salle Les Alps
    France
    Diretor
    Lot Chirouzanches 05240
    La Salle Les Alps
    France
    French132005120001
    FITCHFORD, Andrew Michael John
    The Old House
    The Green
    B94 5AJ Tanworth In Arden
    Warwickshire
    Diretor
    The Old House
    The Green
    B94 5AJ Tanworth In Arden
    Warwickshire
    British99141670001
    FROY, Robert Anthony Douglas
    171 Defoe House
    Barbican
    EC2Y 8ND London
    Diretor
    171 Defoe House
    Barbican
    EC2Y 8ND London
    British35373020004
    GOPSILL, Michael Clement
    Wood Cottage
    Norton Road Iverley
    Stourbridge
    West Midlands
    Diretor
    Wood Cottage
    Norton Road Iverley
    Stourbridge
    West Midlands
    British32481900001
    HAZLEHURST, Ian James
    Malvern Park Farm
    Widney Manor Road
    B91 3JG Solihull
    West Midlands
    Diretor
    Malvern Park Farm
    Widney Manor Road
    B91 3JG Solihull
    West Midlands
    British43476760001
    HODGSON, Geoffrey Phillip
    Canterbury Cottage
    Fox Pond Lane
    LE2 4RY Great Glen
    Leicestershire
    Diretor
    Canterbury Cottage
    Fox Pond Lane
    LE2 4RY Great Glen
    Leicestershire
    British107483910001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    The Wendy House 3 Elf Meadow
    Poulton
    GL7 5HQ Cirencester
    Gloucestershire
    Diretor
    The Wendy House 3 Elf Meadow
    Poulton
    GL7 5HQ Cirencester
    Gloucestershire
    British33223550001
    JONES, Alan Martin
    5 Firsway
    Wightwick
    WV6 8BJ Wolverhampton
    West Midlands
    Diretor
    5 Firsway
    Wightwick
    WV6 8BJ Wolverhampton
    West Midlands
    British47891670001
    KEARNEY, Christopher James
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    Diretor
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    American85114770001
    LADENBERGER, Daniel Timothy
    24 Portland Place
    Saint Louis
    Missouri 63108
    Usa
    Diretor
    24 Portland Place
    Saint Louis
    Missouri 63108
    Usa
    American110032170001
    LEEK, James Anthony
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    Diretor
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    British11293430001
    LILLY, Kevin Lucius
    13515 Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Diretor
    13515 Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican110636870001
    MCGOWAN, John Peter
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    Diretor
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    British62509010002
    O'LEARY, Patrick Joseph
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Diretor
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican61807850002
    PETERSON, Andris
    Redlands
    Lower Town
    WR3 7RY Claines
    Worcestershire
    Diretor
    Redlands
    Lower Town
    WR3 7RY Claines
    Worcestershire
    American31642760001
    RADISCH, Klaus Ingo
    Weidendstrasse 36
    Sonsbeck 47665
    Germany
    Diretor
    Weidendstrasse 36
    Sonsbeck 47665
    Germany
    GermanyGerman121578410001
    REILLY, Michael Andrew
    2007 Channelstone Way
    NC 28104 Matthews
    Nc 28104
    Usa
    Diretor
    2007 Channelstone Way
    NC 28104 Matthews
    Nc 28104
    Usa
    United StatesAmerican103500870001
    RENZI, Anthony Andrew
    5101 Sw 60th Street Road
    Ocala
    Florida 34474
    Usa
    Diretor
    5101 Sw 60th Street Road
    Ocala
    Florida 34474
    Usa
    American121578380001
    WALKER, Craig Allen
    Bruhnstrasse 2a
    FOREIGN 40225 Dusseldorf
    Germany
    Diretor
    Bruhnstrasse 2a
    FOREIGN 40225 Dusseldorf
    Germany
    Usa109340980001
    WINOWIECKI, Ronald Lee
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    Diretor
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    American95572300001

    MH VOKES AIR UK LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Supplemental deed
    Criado em 22/02/1993
    Entregue em 09/03/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from the company and/or any other obligors named therein to the chargee under the security trust deed,the financing agreement and the security documents as defined in this deed
    Breve descrição
    All moneys,dividends and interest in respect of the shares.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank Plcas Security Trustee
    Transações
    • 09/03/1993Registro de uma garantia (395)
    • 23/12/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Share pledge agreement
    Criado em 18/01/1993
    Entregue em 02/02/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or wheway secretarial services limited to the chargee under the terms of the pledge agreement (the "secured liabilities as defined)
    Breve descrição
    By way of pledge 599 shares in appareils electriques et electoniques belges N.V. (see form 395 ref M93).
    Pessoas com direito
    • Midland Bank Plcthe "Pledgees" (As Defined)
    Transações
    • 02/02/1993Registro de uma garantia (395)
    • 23/12/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage of shares
    Criado em 18/01/1993
    Entregue em 02/02/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined), under the facilities documents and/or the security documents (as defined) or any of them
    Breve descrição
    All the companys right title and interest in and to and under the presentshares the acquired shares and the new rights the deposited shares (see form 395REF M95).
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC as Security Trustee
    Transações
    • 02/02/1993Registro de uma garantia (395)
    • 23/12/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Pledge agreement
    Criado em 18/01/1993
    Entregue em 02/02/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee dated 22/12/92
    Breve descrição
    The pledged shares divends cash instruments chattel paper and other rights property or proceeds.see form 395 for full details.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank Plcas Security Trustee
    Transações
    • 02/02/1993Registro de uma garantia (395)
    • 23/12/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Pledge agreement
    Criado em 18/01/1993
    Entregue em 02/02/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a security trust deed dated 22/12/92
    Breve descrição
    25,994 shares in climavent-cadi S.a and any other shares or seurities.see form 395 for full details.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank Plcas Security Trustee
    Transações
    • 02/02/1993Registro de uma garantia (395)
    • 23/12/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 22/12/1992
    Entregue em 07/01/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined) under the financing agreement dated 22ND december 1992 and/or the security documents(as defined) or any of them
    Breve descrição
    See doc ref M79 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank Plcas "Security Trustee" for the Beneficiaries (Asdefined)
    Transações
    • 07/01/1993Registro de uma garantia (395)
    • 23/12/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0