WINDELECTRIC LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | WINDELECTRIC LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 02407377 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de WINDELECTRIC LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica WINDELECTRIC LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de WINDELECTRIC LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2010 |
Quais são as últimas submissões para WINDELECTRIC LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Juliet Sarah Loveday Davenport em 17/07/2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Nigel Tranah como secretário em 16/04/2012 | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Angela Newman como secretário em 16/04/2012 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/03/2012 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2010 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de John Sellers como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 3 páginas | SH20 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/03/2011 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Nomeação de Miss Angela Newman como secretário | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Mark Hopkins como secretário | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2009 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/03/2010 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Jonathan George Fairchild em 11/03/2010 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Peter Dixon Edwards em 01/01/2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Juliet Sarah Loveday Davenport em 01/01/2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Mark Hopkins como secretário | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Jonathan Fairchild como secret ário | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2008 | 22 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2007 | 17 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
Quem são os diretores de WINDELECTRIC LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANAH, Nigel | Secretário | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire | 168397380001 | |||||||
| DAVENPORT, Juliet Sarah Lovedy | Diretor | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire | United Kingdom | British | 70686370003 | |||||
| EDWARDS, Martin John | Diretor | The Bungalow Deli PL33 9BZ Delabole Cornwall | England | British | 81829090001 | |||||
| EDWARDS, Peter Dixon | Diretor | Deli PL33 9BZ Delabole N Cornwall | United Kingdom | British | 6723810001 | |||||
| EDWARDS, Jeremy Paul | Secretário | Kempson House PO BOX 570,Camomile Street EC3A 7AN London | British | 27850190002 | ||||||
| FAIRCHILD, Jonathan George | Secretário | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire | British | 91228100003 | ||||||
| HOPKINS, Mark | Secretário | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire | 149634170001 | |||||||
| NEWMAN, Angela | Secretário | Monkton Reach Monkton Hill SN15 1EE Chippenham Wiltshire | 155558130001 | |||||||
| OVALSEC LIMITED | Secretário nomeado | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 | |||||||
| FISK, Nicholas John Spencer | Diretor | 10 Edwards Meadow SN8 1UD Marlborough Wiltshire | British | 36028930001 | ||||||
| LOPEZ-CACICEDO, Carlos, Dr | Diretor | 362 Marlborough Road SN3 1NP Swindon | Spanish | 14105600002 | ||||||
| MASOOD, Tariq | Diretor | 22 Ashgrove Avenue Ashley Down BS7 9LJ Bristol | United Kingdom | British | 46049660002 | |||||
| MASOOD, Tariq | Diretor | 46 Sherbourne Avenue Bradley Stoke BS12 8BB Bristol Avon | British | 46049660001 | ||||||
| MASTERMAN, Richard Thomas | Diretor | Thuborough House Sutcombe EX22 7QE Holsworthy Devon | British | 3437250001 | ||||||
| SEED, John Junior | Diretor | Highfield House North Road BA2 6HW Bath Bath & North East Somerset | British | 8670120001 | ||||||
| SELLERS, John Ernest | Diretor | Rodway Hill Manor Manor Road Mangotsfield BS16 9LG Bristol | United Kingdom | British | 47428650001 | |||||
| SWARBRICK, Gerard Joseph | Diretor | 39 Upper Cranbrook Road Westbury Park BS6 7UR Bristol | England | British | 27850210001 | |||||
| SWINDELLS, Brian James | Diretor | 7 Hollymead Lane Stoke Bishop BS9 1LN Bristol | British | 32426200002 | ||||||
| SAXON FINANCE CORPORATION LIMITED | Diretor | Thuborough House Sutcombe EX22 7QE Holsworthy Devon | 59178080001 |
WINDELECTRIC LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Performance guarantee and warranty guarantee assignment | Criado em 14/11/1991 Entregue em 22/11/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 4/11/91 and security documents issued pursuant thereto | |
Breve descrição All the companys rights title and interest in and to a performance guarantee dated 12/11/91. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Contract consultant's appointment and warranty and maintenance agreement charge | Criado em 04/11/1991 Entregue em 20/11/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All moneys due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of the facility letter dated 4TH NOVEMBER1991 and this deed | |
Breve descrição All the benefit of the contract agreement,the agreement,andthe warranty and maintenance agreement all dated 19TH july 1991 see form 395 ref M792C for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Contract charge | Criado em 04/11/1991 Entregue em 15/11/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter of even date and the charge | |
Breve descrição All the benefit of an agreement dated 9/8/91. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Charge over deposit account | Criado em 04/11/1991 Entregue em 13/11/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All the company's right, title and interest-bearing deposit account number 66457901 at natwest investment bank limited designated cnw re: windelectric limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Charge over power purchase agreement | Criado em 04/11/1991 Entregue em 13/11/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to natwest investment bank limited or to any receiver appointed by the bank under the terms of the facility letter and/or mortgage debenture, both of even date, and/or this charge | |
Breve descrição All sums payable by non-fossil purchasing agency limited to the company under the power purchase agreement dated 12TH september 1990 and made beyween the company (1) non-fossil purchasing agency limited (2) and south western electricity PLC (3). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Mortgage debenture | Criado em 04/11/1991 Entregue em 13/11/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição By way of legal mortgage all those areas of leasehold land and premises at deli farm development delabole cornwall and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0