PINDAR PLC

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaPINDAR PLC
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade anónima cotada
    Número da empresa 02428709
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de PINDAR PLC?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica PINDAR PLC?

    Endereço do escritório registrado
    C/O Kpmg Llp 1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de PINDAR PLC?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    PINDAR GRAPHICS PLC17/11/198917/11/1989
    METROTAB PUBLIC LIMITED COMPANY 03/10/198903/10/1989

    Quais são as últimas contas de PINDAR PLC?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2010

    Quais são as últimas submissões para PINDAR PLC?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Relatório de progresso do administrador até 11/01/2013

    31 páginas2.24B

    Aviso de mudança da administração para dissolução em 15/01/2013

    31 páginas2.35B

    Relatório de progresso do administrador até 13/11/2012

    33 páginas2.24B

    Relatório de progresso do administrador até 13/05/2012

    33 páginas2.24B

    Aviso de extensão do período da administração

    1 páginas2.31B

    Declaração anual preparada até 12/03/2012 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital16/04/2012

    Estado do capital em 16/04/2012

    • Capital: GBP 2,000,000
    SH01

    Relatório de progresso do administrador até 25/01/2012

    44 páginas2.24B

    Aviso da aprovação presumida das propostas

    1 páginasF2.18

    Declaração de proposta do administrador

    75 páginas2.17B

    Declaração de negócios com formulário 2.14B

    36 páginas2.16B

    Término da nomeação de Jenna Holliday como secretário

    1 páginasTM02

    Endereço do domicílio registado alterado de Thornburgh Road Eastfield Scarborough North Yorkshire YO11 3UY em 03/08/2011

    1 páginasAD01

    Nomeação de um administrador

    1 páginas2.12B

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    31 páginasMG01

    legacy

    31 páginasMG01

    Término da nomeação de Andrew Holmes como diretor

    1 páginasTM01

    legacy

    5 páginasMG01

    Contas consolidadas preparadas até 30/09/2010

    27 páginasAA

    Declaração anual preparada até 12/03/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2009

    26 páginasAA

    Nomeação de Mr Andrew Charles David Holmes como diretor

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de PINDAR PLC?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    PINDAR, George Thomas Ventress
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    Diretor
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    United KingdomBritishPrinter1020460001
    PINDAR, George Andrew
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    Diretor
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    EnglandBritishDirector1120570003
    HOLLIDAY, Jenna Louise
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    Secretário
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    C/O Kpmg Llp
    British136386570001
    NOAKES, David Anthony
    21 Town Street
    Old Malton
    YO17 7HB Malton
    North Yorkshire
    Secretário
    21 Town Street
    Old Malton
    YO17 7HB Malton
    North Yorkshire
    British54380850004
    WHITTAKER, Paul Meredith Allen
    Martin Garth
    86 Hutton Buscel
    YO13 9LN Scarborough
    North Yorkshire
    Secretário
    Martin Garth
    86 Hutton Buscel
    YO13 9LN Scarborough
    North Yorkshire
    British29811100001
    WOOLLEY, Heather Caroline
    25 Mayville Avenue
    YO12 7NW Scarborough
    North Yorkshire
    Secretário
    25 Mayville Avenue
    YO12 7NW Scarborough
    North Yorkshire
    BritishCompany Secretary38563500003
    BROUGHAM, Martyn
    2 Sawyers Walk
    Dunnington
    YO19 5SJ York
    North Yorkshire
    Diretor
    2 Sawyers Walk
    Dunnington
    YO19 5SJ York
    North Yorkshire
    BritishMarketing Director60080800002
    COWLEY, Christian Anthony
    59 Station Road
    Scholes
    LS15 4BY Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    59 Station Road
    Scholes
    LS15 4BY Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director27271120001
    DALTON, Andrew Leslie
    Kirby House Farm
    Kirby Knowle
    YO7 2JF Thirsk
    North Yorkshire
    Diretor
    Kirby House Farm
    Kirby Knowle
    YO7 2JF Thirsk
    North Yorkshire
    EnglandBritishChief Executive116104960001
    DUGGLEBY, Paul Neil
    Lowgill
    LA2 8PS Lancaster
    Mill Bridge Barn
    United Kingdom
    Diretor
    Lowgill
    LA2 8PS Lancaster
    Mill Bridge Barn
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director42924780005
    GRAY, Richard David
    1 West Parade
    NR2 3DN Norwich
    Norfolk
    Diretor
    1 West Parade
    NR2 3DN Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish56284200002
    HOLMES, Andrew Charles David
    Thornburgh Road
    Eastfield
    YO11 3UY Scarborough
    North Yorkshire
    Diretor
    Thornburgh Road
    Eastfield
    YO11 3UY Scarborough
    North Yorkshire
    United KingdomBritishLawyer64104370003
    LONGBOTHAM, David George
    34 Water Lane
    Dunnington
    YO1 5NS York
    N Yorkshire
    Diretor
    34 Water Lane
    Dunnington
    YO1 5NS York
    N Yorkshire
    BritishPrinter24899320001
    LUMBY, Richard Stephen
    30 North Street
    Scalby
    YO13 0RP Scarborough
    North Yorkshire
    Diretor
    30 North Street
    Scalby
    YO13 0RP Scarborough
    North Yorkshire
    BritishDirector5653290001
    MCFIE SNEDDON, Mark
    11 Oriel Close
    Walkington
    HU17 8YD Beverley
    North Humberside
    Diretor
    11 Oriel Close
    Walkington
    HU17 8YD Beverley
    North Humberside
    BritishManaging Director71831240001
    NIVEN, Fraser Irvine
    30 Bonaly Avenue
    EH13 0ET Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    30 Bonaly Avenue
    EH13 0ET Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishManaging Director1245890002
    O'SULLIVAN, Paul Joseph
    Robin Hill
    Ravenscar
    Y013 ONA Scarborough
    North Yorkshire
    Diretor
    Robin Hill
    Ravenscar
    Y013 ONA Scarborough
    North Yorkshire
    BritishManager39741380001
    PALFREY, David Gwyn
    Bay Horse Cottage
    19 Main Street Ebberston
    YO13 9NR Scarborough
    North Yorkshire
    Diretor
    Bay Horse Cottage
    19 Main Street Ebberston
    YO13 9NR Scarborough
    North Yorkshire
    BritishChartered Accountant1209930001
    PINDAR, George Andrew
    Southend House
    Burniston
    YO13 0HP Scarborough
    North Yorkshire
    Diretor
    Southend House
    Burniston
    YO13 0HP Scarborough
    North Yorkshire
    BritishPrinter1120570001
    STREET, Nigel
    19 New Walk Terrace
    YO10 4BG York
    North Yorkshire
    Diretor
    19 New Walk Terrace
    YO10 4BG York
    North Yorkshire
    BritishCompany Director60080730002
    WHITE, John
    St Johns Cottage
    8 East Avenue Scalby
    YO13 0QE Scarborough
    North Yorkshire
    Diretor
    St Johns Cottage
    8 East Avenue Scalby
    YO13 0QE Scarborough
    North Yorkshire
    BritishCommercial Director5503640001
    WILKINSON, Peter James
    Bridgewater House 16 Station Road
    Scalby
    YO13 0PU Scarborough
    Diretor
    Bridgewater House 16 Station Road
    Scalby
    YO13 0PU Scarborough
    EnglandBritishSales Director70519070001

    PINDAR PLC possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Chattels mortgage
    Criado em 19/05/2011
    Entregue em 27/05/2011
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    With full title guarantee assigns the items of equipment and/or other chattels described or referred to in the schedule being 4 sets of 5 bays adjustable botless steel pallet racking, vacuumatic counter and mettler toledo electronic scale and remote platform (for details of all other equipment charged, please refer to the MG01 document).
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 27/05/2011Registro de uma garantia (MG01)
    Chattel mortgage
    Criado em 19/05/2011
    Entregue em 27/05/2011
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of a specific first charge all right, title and interest in and to the equipment being 4 sets of 5 bays adjustable boltless steel pallet racking, vacuumatic counter and mettler toledo electronic scale and remote platform (for details of all other equipment charged, please refer to the MG01 document).
    Pessoas com direito
    • Hsbc Equipment Finance (UK) Limited and Hsbc Asset Finance (UK) Limited
    Transações
    • 27/05/2011Registro de uma garantia (MG01)
    Legal assignment
    Criado em 06/05/2011
    Entregue em 07/05/2011
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 07/05/2011Registro de uma garantia (MG01)
    Chattel mortgage
    Criado em 16/06/2004
    Entregue em 21/06/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Heidelberg - five colour printing press / s/no: 537137; heidelberg - five colour printing press / s/no: 540261; heidelberg - five colour printing press / s/no: 537749; muller - saddle stitching machine / s/no: 91.06593/42.
    Pessoas com direito
    • Lombard North Central PLC
    Transações
    • 21/06/2004Registro de uma garantia (395)
    • 11/04/2005Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 29/06/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Floating charge
    Criado em 05/12/2003
    Entregue em 06/12/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the undertaking, all assets now owned or hereafter acquired including the stock in trdae and its uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transações
    • 06/12/2003Registro de uma garantia (395)
    Chattels mortgage
    Criado em 28/12/2000
    Entregue em 28/12/2000
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof muller martini tempo saddle stitcher equipped with four type 416 feeders streatmfeeders 3738, card folder 344, rapido stacker into FW67/FJK41 filmwrapping line and cohiba palletiser s/n SAP368060.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transações
    • 28/12/2000Registro de uma garantia (395)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Criado em 14/02/2000
    Entregue em 17/02/2000
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement for the purchase of debts
    Breve descrição
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement (including the associated rights as defined in the agreement) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transações
    • 17/02/2000Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 11/02/2000
    Entregue em 15/02/2000
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 15/02/2000Registro de uma garantia (395)
    Mortgage
    Criado em 09/06/1999
    Entregue em 15/06/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £5,217,250 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    One new man roland and web offset printing press type lithoman iv serial no 27666 with all accessories and component parts and all improvements and renewals with all books manuals and handbooks technical data drawings schedules and other documentation.
    Pessoas com direito
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transações
    • 15/06/1999Registro de uma garantia (395)
    • 24/01/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 13/01/1995
    Entregue em 13/01/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    One new heidelberg 102 speedmaster five colour offset press model 102F + l cp tronic controlled 72 x 102CM with coating system, complete with CPC1-03 alcolor dampening and CPC4 plate registration device, serial no: 537137 together with ancillary equipment. One new CPC3-s plate image reader serial no: 0057 together with ancillary equipment.
    Pessoas com direito
    • Forward Trust Limited
    Transações
    • 13/01/1995Registro de uma garantia (395)
    • 29/06/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Chattels mortgage
    Criado em 04/01/1995
    Entregue em 04/01/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule. One new heidelberg harris web offset press model M600, serial no:mc Y0057 no. 51, together with ancillary equipment, serial nos:0044 da, 0218 ma, 28 0006010, 180193, 197.01.0080& 550051 6/94. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Forward Trust Limited
    Transações
    • 04/01/1995Registro de uma garantia (395)
    • 29/06/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Criado em 09/07/1991
    Entregue em 10/07/1991
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 10/07/1991Registro de uma garantia

    PINDAR PLC possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    26/07/2011Início da administração
    15/01/2013Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Mark Granville Firmin
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profissional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Profissional
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profissional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0