ROUGHLY RED LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaROUGHLY RED LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02460533
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ROUGHLY RED LIMITED?

    • (9999) /

    Onde fica ROUGHLY RED LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ROUGHLY RED LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    RACING GREEN LIMITED23/01/199823/01/1998
    HEMINGWAY LIMITED22/03/199022/03/1990
    HOCKBRIDGE LIMITED17/01/199017/01/1990

    Quais são as últimas contas de ROUGHLY RED LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/01/2010

    Quais são as últimas submissões para ROUGHLY RED LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    18 páginas4.72

    Restauração por ordem judicial

    3 páginasAC92

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    11 páginas4.72

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 04/01/2012

    15 páginas4.68

    Endereço do domicílio registado alterado de * Toronto Square Toronto Street Leeds LS1 2HJ* em 26/05/2011

    2 páginasAD01

    Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia

    3 páginasF10.2

    Estado de situação patrimonial com formulário em anexo 4.19

    4 páginas4.20

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução extraordinária para a liquidação

    LRESEX

    Endereço do domicílio registado alterado de * Toronto Square Toronto Street Leeds LS1 2HJ* em 19/01/2011

    2 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de * Granary Building 1 Canal Wharf Leeds West Yorkshire LS11 5BB* em 11/01/2011

    2 páginasAD01

    Nomeação de Scott Keith Carpenter como diretor

    3 páginasAP01

    Nomeação de Gavin Michael George como secretário

    3 páginasAP03

    Nomeação de Mr Gavin Michael George como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Richard Paul como secretário

    2 páginasTM02

    Término da nomeação de Baird Group Ltd como diretor

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de Peter Lucas como diretor

    2 páginasTM01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/01/2010

    5 páginasAA

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed racing green LIMITED\certificate issued on 19/10/10
    2 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name19/10/2010

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Aviso de alteração do nome"

    2 páginasCONNOT

    Quem são os diretores de ROUGHLY RED LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    GEORGE, Gavin Michael
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    Secretário
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    British156135760001
    CARPENTER, Scott Keith
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    England
    Diretor
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    England
    United StatesAmerican145987830001
    GEORGE, Gavin Michael
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    Diretor
    Stratton Street
    W1J 8LQ London
    15
    United KingdomBritish148227120001
    BRICK, Alexander Paul
    12 The Bishops Avenue
    N2 0AN London
    Secretário
    12 The Bishops Avenue
    N2 0AN London
    British122889900001
    CASH, Daphne Valerie
    20 Chichester Mews
    SE27 0NS London
    Secretário
    20 Chichester Mews
    SE27 0NS London
    British59646330004
    COCKIN, Anna Margaret
    16 Manor House Estate
    HA7 4BH Stanmore
    Middlesex
    Secretário
    16 Manor House Estate
    HA7 4BH Stanmore
    Middlesex
    British95030040001
    HIGHT-WARBURTON, Jonathan Howard
    50 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    Secretário
    50 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    British62797170001
    HODGES, John
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    Secretário
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    British3666240001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Secretário
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Secretário
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001
    LIPTON, Richard Geoffrey
    67 Green Lane
    HA8 7PZ Edgware
    Middlesex
    Secretário
    67 Green Lane
    HA8 7PZ Edgware
    Middlesex
    British32995330001
    PAUL, Richard Neil
    21 Almsford Avenue
    HG2 8HD Harrogate
    North Yorkshire
    Secretário
    21 Almsford Avenue
    HG2 8HD Harrogate
    North Yorkshire
    British43099210003
    SPERRY, Ian Nicholas
    8 St. Thomas Place
    Wheathampstead
    AL4 8BG St. Albans
    Hertfordshire
    Secretário
    8 St. Thomas Place
    Wheathampstead
    AL4 8BG St. Albans
    Hertfordshire
    British106924330002
    STEVENSON, Rebecca Jayne
    49 Rivulet Road
    Tottenham
    N17 7JT London
    Secretário
    49 Rivulet Road
    Tottenham
    N17 7JT London
    British71917770002
    ALLAN, Fraser Stuart
    Village Farm Barn
    The Broadway, Charlton On Otmoor
    OX5 2UB Kidlington
    Oxfordshire
    Diretor
    Village Farm Barn
    The Broadway, Charlton On Otmoor
    OX5 2UB Kidlington
    Oxfordshire
    British64559730001
    BEHARRELL, Russell Clive
    2 The Grange
    Wimbledon
    SW19 4PT London
    Diretor
    2 The Grange
    Wimbledon
    SW19 4PT London
    EnglandBritish6730570001
    BLOMGREN, Britta Katarina
    31a Ospringe Road
    NW5 2JB London
    Diretor
    31a Ospringe Road
    NW5 2JB London
    Swedish35948360001
    BRICK, Alexander Paul
    12 The Bishops Avenue
    N2 0AN London
    Diretor
    12 The Bishops Avenue
    N2 0AN London
    EnglandBritish122889900001
    BRICK, Anthony Allan
    11 Pangbourne Drive
    HA7 4QS Stanmore
    Middlesex
    Diretor
    11 Pangbourne Drive
    HA7 4QS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish34122180001
    BRICK, Brian Denis
    28 Aylmer Drive
    HA7 3EG Stanmore
    Middlesex
    Diretor
    28 Aylmer Drive
    HA7 3EG Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish9649690002
    BROWN, David Nigel
    116 Clarence Road
    AL1 4NW St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    116 Clarence Road
    AL1 4NW St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish40354400003
    BUDGE, Paul Everard
    16 Overland Crescent
    Apperley Bridge
    BD10 9TG Bradford
    Diretor
    16 Overland Crescent
    Apperley Bridge
    BD10 9TG Bradford
    United KingdomBritish88851520002
    CHALLEN, Philippa Helen
    1 Myrtle House
    Sulgrave Road
    W6 7QG London
    Diretor
    1 Myrtle House
    Sulgrave Road
    W6 7QG London
    British39567180001
    CHAPPELOW, Peter Raymond
    Settlebeck 109 Curly Hill
    LS29 0DT Ilkley
    West Yorkshire
    Diretor
    Settlebeck 109 Curly Hill
    LS29 0DT Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish71153170002
    CHEESEMAN, Gordon William
    Tawny End
    Earleswood
    KT11 2BZ Cobham
    Surrey
    Diretor
    Tawny End
    Earleswood
    KT11 2BZ Cobham
    Surrey
    British17467970001
    DUCKELS, Colin Peter
    25 Woodlea Drive
    Meanwood
    LS6 4SQ Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    25 Woodlea Drive
    Meanwood
    LS6 4SQ Leeds
    West Yorkshire
    British44237310003
    FAY, Janet Anne
    Gable Cottage
    Church Lane Avenue
    CR5 3RT Coulsdon
    Surrey
    Diretor
    Gable Cottage
    Church Lane Avenue
    CR5 3RT Coulsdon
    Surrey
    British35948290002
    FREEDMAN, Jonathan Sydney
    9 Eastglade
    HA5 3AN Pinner
    Middlesex
    Diretor
    9 Eastglade
    HA5 3AN Pinner
    Middlesex
    British5232410001
    GIPSON, Stephen
    The Engine House
    2 Leigh Court Barns
    WR6 5LB Leigh
    Worcestershire
    Diretor
    The Engine House
    2 Leigh Court Barns
    WR6 5LB Leigh
    Worcestershire
    Great BritainBritish98785200001
    GOLDMAN, Adam Alexander
    4 Jenner Way
    Clarendon Park
    KT19 7LJ Epsom
    Surrey
    Diretor
    4 Jenner Way
    Clarendon Park
    KT19 7LJ Epsom
    Surrey
    EnglandBritish28466260004
    HALLETT, Peter John
    Goldfields Glenhill Farm
    Glendon Road
    NN14 1QE Kettering
    Northamptonshire
    Diretor
    Goldfields Glenhill Farm
    Glendon Road
    NN14 1QE Kettering
    Northamptonshire
    United KingdomBritish20621770002
    HICK, Paul Arney
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    Diretor
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish47699120005
    HIGGINSON, Andrew Thomas
    Little Wood Wood End
    SL7 2HW Marlow
    Buckinghamshire
    Diretor
    Little Wood Wood End
    SL7 2HW Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish57637410001
    HODGES, John
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    Diretor
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    British3666240001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Diretor
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001

    ROUGHLY RED LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 14/09/2007
    Entregue em 27/09/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Gresham LLP (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transações
    • 27/09/2007Registro de uma garantia (395)
    • 22/10/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Supplement deed
    Criado em 25/05/2006
    Entregue em 09/06/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transações
    • 09/06/2006Registro de uma garantia (395)
    • 22/10/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 25/11/2005
    Entregue em 13/12/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties (The Security Trustee)
    Transações
    • 13/12/2005Registro de uma garantia (395)
    • 22/10/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 27/02/1996
    Entregue em 29/02/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 29/02/1996Registro de uma garantia (395)
    • 05/10/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 17/08/1993
    Entregue em 21/08/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transações
    • 21/08/1993Registro de uma garantia (395)
    • 05/10/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 18/12/1991
    Entregue em 20/12/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plus patents.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 20/12/1991Registro de uma garantia (395)
    • 03/12/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 08/05/1991
    Entregue em 15/05/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All the tenants obligations under a lease dated 8 may 1991 and under the terms of the charge
    Breve descrição
    £ 18,750 (see 395 for full detail).
    Pessoas com direito
    • Colebrook Estates Limited
    Transações
    • 15/05/1991Registro de uma garantia
    • 01/10/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    ROUGHLY RED LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    11/07/2017Data de dissolução
    05/01/2011Início da liquidação
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Profissional
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Simon Jonathan Appell
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Profissional
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0