NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.

NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaNEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02475402
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    • (7222) /

    Onde fica NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    Endereço do escritório registrado
    2nd Floor
    79 Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CAMBRIDGE ANIMATION SYSTEMS LIMITED22/03/199022/03/1990
    FELTONIAN LIMITED28/02/199028/02/1990

    Quais são as últimas contas de NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2008

    Quais são as últimas submissões para NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória

    1 páginasGAZ2

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Contas de isenção total preparadas até 30/06/2008

    9 páginasAA

    Contas de isenção total preparadas até 30/06/2007

    7 páginasAA

    legacy

    8 páginas363a

    legacy

    6 páginas363a

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed cambridge animation systems LIMITED\certificate issued on 19/01/09
    3 páginasCERTNM

    Extrato de receitas e despesas do supervisor do acordo voluntário até 08/01/2009

    2 páginas1.3

    Aviso da conclusão do acordo voluntário

    5 páginas1.4

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    2 páginas403a

    Extrato de receitas e despesas do supervisor do acordo voluntário até 22/09/2008

    9 páginas1.3

    Extrato de receitas e despesas do supervisor do acordo voluntário até 22/09/2007

    10 páginas1.3

    legacy

    7 páginas363s

    Contas de isenção total preparadas até 30/06/2006

    9 páginasAA

    Diversos

    Supervisor's report
    5 páginasMISC

    Extrato de receitas e despesas do supervisor do acordo voluntário até 22/09/2006

    2 páginas1.3

    legacy

    7 páginas363s

    Contas de isenção total preparadas até 30/06/2005

    11 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288b

    Extrato de receitas e despesas do supervisor do acordo voluntário até 22/09/2005

    3 páginas1.3

    Quem são os diretores de NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    PS LAW SECRETARIES LIMITED
    Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    79
    Secretário
    Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    79
    81576980001
    SLEVIN, Cormac Brian
    62 Brampton Road
    CB1 3HL Cambridge
    Cambridgeshire
    Diretor
    62 Brampton Road
    CB1 3HL Cambridge
    Cambridgeshire
    Irish98972470001
    FLORENCE, Peter Charles
    34 Grafton Street
    CB1 1DS Cambridge
    Secretário
    34 Grafton Street
    CB1 1DS Cambridge
    British50715100001
    HOLLAND, Stephen John William
    35 Woodlands Park
    CB3 0QB Girton
    Cambridgeshire
    Secretário
    35 Woodlands Park
    CB3 0QB Girton
    Cambridgeshire
    British79873930001
    MCCALL, Ruth
    18 Milman Road
    Queens Park
    NW6 6EJ London
    Secretário
    18 Milman Road
    Queens Park
    NW6 6EJ London
    British51783880001
    O'CONNOR, Christopher Patrick, Mr.
    Willow Cottage
    School Lane
    CB23 4ND Boxworth
    Cambridgeshire
    Secretário
    Willow Cottage
    School Lane
    CB23 4ND Boxworth
    Cambridgeshire
    British3751430003
    SHIRREN, Gerry
    Kiltale
    IRISH Dunsany
    Co Meath
    Ireland
    Secretário
    Kiltale
    IRISH Dunsany
    Co Meath
    Ireland
    Irish97685400001
    VIS, Annemarie Mirjam Frederique
    37 Martingale Close
    CB4 3TA Cambridge
    Secretário
    37 Martingale Close
    CB4 3TA Cambridge
    British52939100001
    WOOLLEY, Alastair John Lomond
    Charity Farmhouse
    Brinkley
    CB8 0SE Newmarket
    Suffolk
    Secretário
    Charity Farmhouse
    Brinkley
    CB8 0SE Newmarket
    Suffolk
    British89506550001
    PS LAW SECRETARIES LIMITED
    2nd Floor
    79 Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    Secretário
    2nd Floor
    79 Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    81576980001
    ABBOTT, Raymond James
    44 Coillesdene Avenue
    EH15 2JR Edinburgh
    Diretor
    44 Coillesdene Avenue
    EH15 2JR Edinburgh
    British65699620002
    BAHNS, Robert Harold
    40a Parkhill Road
    NW3 2YP London
    Diretor
    40a Parkhill Road
    NW3 2YP London
    British64794090001
    BARRETT, Philip James, Dr
    16 Kings Road
    PE19 1LD St. Neots
    Cambridgeshire
    Diretor
    16 Kings Road
    PE19 1LD St. Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritish198025600001
    BEREND, Andrew Louis Charles
    145 King Henrys Road
    NW3 3RD London
    Diretor
    145 King Henrys Road
    NW3 3RD London
    British24724970005
    CARRIGAN, Thomas Jay
    464 Notre Dame Road
    91711 Claremont
    Los Angeles
    Usa
    Diretor
    464 Notre Dame Road
    91711 Claremont
    Los Angeles
    Usa
    American60077320001
    FERRIS, Gavin Robert, Dr
    29c Shanrod Road
    Katebridge
    BT32 5PG Banbridge
    County Down
    Northern Ireland
    Diretor
    29c Shanrod Road
    Katebridge
    BT32 5PG Banbridge
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish107911580001
    FLORENCE, Peter Charles
    34 Mornington Crescent
    NW1 7RE London
    Diretor
    34 Mornington Crescent
    NW1 7RE London
    United KingdomBritish50715100002
    FLORENCE, Peter Charles
    34 Grafton Street
    CB1 1DS Cambridge
    Diretor
    34 Grafton Street
    CB1 1DS Cambridge
    British50715100001
    HAYMAN, Anne Carolyn
    36 Lawford Road
    NW5 2LN London
    Diretor
    36 Lawford Road
    NW5 2LN London
    EnglandBritish32391350001
    HOLLAND, Stephen John William
    35 Woodlands Park
    CB3 0QB Girton
    Cambridgeshire
    Diretor
    35 Woodlands Park
    CB3 0QB Girton
    Cambridgeshire
    British79873930001
    JACKSON, John Bernard Haysom
    Summit House
    Red Lion Square
    WC1R 4QB London
    Diretor
    Summit House
    Red Lion Square
    WC1R 4QB London
    United KingdomBritish98731480001
    KELLY, William
    10 Peak Lane
    Portola Valley
    94028 California
    Usa
    Diretor
    10 Peak Lane
    Portola Valley
    94028 California
    Usa
    American46464350001
    KORDA, Alexander Vincent
    Flat 7 8 St Quintin Avenue
    W10 6NU London
    Diretor
    Flat 7 8 St Quintin Avenue
    W10 6NU London
    United KingdomBritish110996140001
    MCCALL, Ruth
    18 Milman Road
    Queens Park
    NW6 6EJ London
    Diretor
    18 Milman Road
    Queens Park
    NW6 6EJ London
    British51783880001
    MITCHELL, John Ross, Dr
    123a London Road
    SG18 8EF Biggleswade
    Bedfordshire
    Diretor
    123a London Road
    SG18 8EF Biggleswade
    Bedfordshire
    British54883260001
    O'CONNOR, Christopher Patrick, Mr.
    Willow Cottage
    School Lane
    CB23 4ND Boxworth
    Cambridgeshire
    Diretor
    Willow Cottage
    School Lane
    CB23 4ND Boxworth
    Cambridgeshire
    EnglandBritish3751430003
    OSBORN, Peter Gordon
    Northchurch Farm Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Diretor
    Northchurch Farm Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    British28389710001
    PETTMAN, Michael George
    The Ranch
    High Street
    SL6 5LT Hurley
    Bucks
    Diretor
    The Ranch
    High Street
    SL6 5LT Hurley
    Bucks
    British23702430001
    RAMSAY, Michael
    13060 Alta Lane North
    Los Altos Hills
    California 94022
    Usa
    Diretor
    13060 Alta Lane North
    Los Altos Hills
    California 94022
    Usa
    UsaBritish72705850001
    SCOGGINS, Ian Maxwell
    High Thicket
    Dockenfield
    GU10 4HB Farnham
    Surrey
    Diretor
    High Thicket
    Dockenfield
    GU10 4HB Farnham
    Surrey
    British54583190001
    SOMPER, Nicholas John
    55 Brookland Rise
    NW11 6DT London
    Diretor
    55 Brookland Rise
    NW11 6DT London
    British59505050001
    STEEL, Andrew Dewar
    Flat 2 3 Dean Path
    EH4 3BG Edinburgh
    Midlothian
    Diretor
    Flat 2 3 Dean Path
    EH4 3BG Edinburgh
    Midlothian
    British14788330002
    SWINSTEAD, Philip Edgar
    Flat 5
    60-61 Cheyne Walk
    SW3 5LX London
    Diretor
    Flat 5
    60-61 Cheyne Walk
    SW3 5LX London
    British101634050001
    TYLER, Brian David
    64 Cavendish Avenue
    CB1 7UT Cambridge
    Cambridgeshire
    Diretor
    64 Cavendish Avenue
    CB1 7UT Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish76611270001
    WATT, Mark
    14 Beaufort Place
    Thompsons Lane
    CB5 8AG Cambridge
    Cambridgeshire
    Diretor
    14 Beaufort Place
    Thompsons Lane
    CB5 8AG Cambridge
    Cambridgeshire
    British56960450001

    NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD. possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 11/04/2001
    Entregue em 18/04/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 18/04/2001Registro de uma garantia (395)
    • 03/12/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 13/03/1997
    Entregue em 19/03/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 13TH march 1997 and the debenture
    Breve descrição
    All of the assets and undertakings of the company except interest in leaseholds as at 13/3/97; shares in animax animation consortium limited and charges in respect of rent deposits not exceeding £50,000.
    Pessoas com direito
    • Ivory & Sime Enterprise Capital PLC
    Transações
    • 19/03/1997Registro de uma garantia (395)
    • 05/09/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 11/03/1997
    Entregue em 28/03/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £3,000 due from the company to the chargee
    Breve descrição
    £3,000 plus interest.
    Pessoas com direito
    • Leonard Robert Martin
    Transações
    • 28/03/1997Registro de uma garantia (395)
    • 31/03/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of rent deposit
    Criado em 14/09/1995
    Entregue em 15/09/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease made 14TH september 1995
    Breve descrição
    The sum of £8,800.00 being the initial deposit placed in a deposit account by cambridge homes limited under the terms of the deed.
    Pessoas com direito
    • Cambridge Homes Limited
    Transações
    • 15/09/1995Registro de uma garantia (395)
    • 31/03/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Criado em 16/02/1994
    Entregue em 19/02/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £50,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland (Stanlife) London Nominees Limited
    Transações
    • 19/02/1994Registro de uma garantia (395)
    • 11/08/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Criado em 16/02/1994
    Entregue em 19/02/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £20,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Monument Trust Company Limited
    Transações
    • 19/02/1994Registro de uma garantia (395)
    • 11/08/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Criado em 16/02/1994
    Entregue em 19/02/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £55,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Ivory & Sime Enterprise Capital PLC
    Transações
    • 19/02/1994Registro de uma garantia (395)
    • 11/08/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Criado em 16/02/1994
    Entregue em 19/02/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £5,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • John Jackson
    Transações
    • 19/02/1994Registro de uma garantia (395)
    • 11/08/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Criado em 16/02/1994
    Entregue em 19/02/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £5,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Colin West
    Transações
    • 19/02/1994Registro de uma garantia (395)
    • 11/08/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Criado em 16/02/1994
    Entregue em 19/02/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £15,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Walbrook Trustees (Guernsey) Limited
    Transações
    • 19/02/1994Registro de uma garantia (395)
    • 11/08/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Criado em 16/02/1994
    Entregue em 19/02/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £50,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Korda Seed Capital Fund Limited Partnership
    Transações
    • 19/02/1994Registro de uma garantia (395)
    • 11/08/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 07/07/1993
    Entregue em 20/07/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 20/07/1993Registro de uma garantia (395)
    • 31/03/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 18/09/1992
    Entregue em 26/09/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date and this charge
    Breve descrição
    £14,900 and any other amount standing to the credit of the account.
    Pessoas com direito
    • The Oceana Consolidated Company PLC
    Transações
    • 26/09/1992Registro de uma garantia (395)
    • 03/12/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD. possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    23/09/2002Data da reunião para aprovar o CVA
    08/01/2009Data de finalização ou terminação do CVA
    Acordo voluntário de reestruturação empresarial (CVA)
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    James Alfred Lettice
    Peters Elworthy & Moore
    Salisbury House
    CB1 2LA Station Road
    Cambridge
    Profissional
    Peters Elworthy & Moore
    Salisbury House
    CB1 2LA Station Road
    Cambridge

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0