VHE HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaVHE HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02478386
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de VHE HOLDINGS LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica VHE HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de VHE HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    VHE HOLDINGS PLC06/09/199306/09/1993
    VHE (HOLDINGS) LIMITED27/03/199027/03/1990
    SOVSHELFCO (NO. 57) LIMITED07/03/199007/03/1990

    Quais são as últimas contas de VHE HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2014

    Qual é o status da última declaração anual para VHE HOLDINGS LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para VHE HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 01/03/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital09/03/2015

    Estado do capital em 09/03/2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Término da nomeação de Stephen Stiff como diretor em 22/01/2015

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de Brian Ward May como diretor em 22/01/2015

    2 páginasTM01

    Nomeação de Mr John William Young Strachan Samuel como diretor em 22/01/2015

    3 páginasAP01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2014

    6 páginasAA

    Satisfação total da garantia 3

    4 páginasMR04

    Declaração anual preparada até 01/03/2014 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital03/03/2014

    Estado do capital em 03/03/2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2013

    6 páginasAA

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Approval of documents 09/08/2013
    RES13

    Nomeação de Brian Ward May como diretor

    4 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 01/03/2013 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2012

    11 páginasAA

    Estado do capital em 24/10/2012

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração anual preparada até 01/03/2012 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2011

    11 páginasAA

    Declaração anual preparada até 01/03/2011 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    legacy

    6 páginasMG01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Contas anuais preparadas até 30/09/2010

    12 páginasAA

    Quem são os diretores de VHE HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Secretário
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    41291250014
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    West Yorkshire
    England
    Diretor
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish3909060002
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Diretor
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    91993060004
    BARKER, Roger Winston
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    Secretário
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    British59419910001
    GREASLEY, Antony Frederick
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    Secretário
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    British69165360001
    LITTLEHALES, Richard
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    British57288230002
    PARKINSON, John
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    British10307790002
    THOMSON, Brian Malcolm
    Manor House Bawtry Road
    Hatfield Woodhouse
    Doncaster
    South Yorkshire
    Secretário
    Manor House Bawtry Road
    Hatfield Woodhouse
    Doncaster
    South Yorkshire
    British5774340002
    BARKER, Roger Winston
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    Diretor
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    British59419910001
    BROADHEAD, Roy
    13 Crayburn Close
    HP8 4NZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Diretor
    13 Crayburn Close
    HP8 4NZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British9110780001
    COOMBE, Andrew Jackson
    45 Stumperlowe Crescent Road
    S10 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    Diretor
    45 Stumperlowe Crescent Road
    S10 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish33999960001
    DAWES, John Brian
    Holly Lodge
    Arkleby
    CA7 2BT Wigton
    Cumbria
    Diretor
    Holly Lodge
    Arkleby
    CA7 2BT Wigton
    Cumbria
    EnglandBritish10253750001
    FEAST, Roger
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    Diretor
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    British66800550001
    GERRARD, Paul Daniel
    Highwood Bryants Bottom Road
    HP16 0JT Great Missenden
    Buckinghamshire
    Diretor
    Highwood Bryants Bottom Road
    HP16 0JT Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish41702130001
    GERRARD, Paul Daniel
    Highwood Bryants Bottom Road
    HP16 0JT Great Missenden
    Buckinghamshire
    Diretor
    Highwood Bryants Bottom Road
    HP16 0JT Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish41702130001
    GREASLEY, Antony Frederick
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    Diretor
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish69165360001
    KING, Richard Anthony
    The Cross Johns Lane
    Blackley
    HX5 0TQ Elland
    West Yorkshire
    Diretor
    The Cross Johns Lane
    Blackley
    HX5 0TQ Elland
    West Yorkshire
    United KingdomBritish10844450001
    LAYCOCK, Michael
    33 Conniscliffe Road
    TS26 0BT Hartlepool
    Cleveland
    Diretor
    33 Conniscliffe Road
    TS26 0BT Hartlepool
    Cleveland
    British520680001
    LITTLEHALES, Richard
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    British57288230002
    MAY, Brian Ward
    Topcliffe
    YO7 3PB Thirsk
    Church Garth
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Topcliffe
    YO7 3PB Thirsk
    Church Garth
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish78419090001
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    138 King Charles Road
    KT5 8QN Surbiton
    Surrey
    Diretor
    138 King Charles Road
    KT5 8QN Surbiton
    Surrey
    United KingdomBritish1571200001
    PARKINSON, John
    Larch Wood
    Scarcroft
    LS14 3BW Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    Larch Wood
    Scarcroft
    LS14 3BW Leeds
    West Yorkshire
    British10307790003
    PEARSON, Valerie
    Phoenix House
    Hawthorn Park
    LS14 1PQ Leeds
    Diretor
    Phoenix House
    Hawthorn Park
    LS14 1PQ Leeds
    British82999480006
    SELLARS, Paul
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    Diretor
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    EnglandBritish50761250001
    STIFF, Stephen
    Holgate Road
    WF8 4ND Pontefract
    60
    West Yorkshire
    Diretor
    Holgate Road
    WF8 4ND Pontefract
    60
    West Yorkshire
    United KingdomBritish111161720001
    THOMSON, Brian Malcolm
    Amber Manor Farm
    Alice Head Road Stonedge
    S45 0DQ Ashover
    Derbyshire
    Diretor
    Amber Manor Farm
    Alice Head Road Stonedge
    S45 0DQ Ashover
    Derbyshire
    British5774340006
    TOPPING, Geoffrey Austen
    3 Blyton Close
    HP9 2LX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    3 Blyton Close
    HP9 2LX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British21525990001
    UNDERWOOD, Philip John
    3 Derry Hill
    Menston
    LS29 6NE Ilkley
    West Yorkshire
    Diretor
    3 Derry Hill
    Menston
    LS29 6NE Ilkley
    West Yorkshire
    British59420330008
    WALDRON, Brian Geoffrey
    Fir Tree Cottage 4 Chapel Lane
    Billingley
    S72 0HZ Barnsley
    South Yorkshire
    Diretor
    Fir Tree Cottage 4 Chapel Lane
    Billingley
    S72 0HZ Barnsley
    South Yorkshire
    GibraltarBritish4324630001

    VHE HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 23/02/2011
    Entregue em 25/02/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 25/02/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 12/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 05/01/2005
    Entregue em 20/01/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 20/01/2005Registro de uma garantia (395)
    • 14/01/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Criado em 19/11/1998
    Entregue em 21/11/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 21/11/1998Registro de uma garantia (395)
    • 14/01/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0