ISI DISTRIBUTION LTD

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaISI DISTRIBUTION LTD
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02478802
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ISI DISTRIBUTION LTD?

    • Outras atividades de serviços de tecnologia da informação (62090) / Informação e comunicação

    Onde fica ISI DISTRIBUTION LTD?

    Endereço do escritório registrado
    Redwood 2 Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Hampshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ISI DISTRIBUTION LTD?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    IQ SYS LIMITED05/10/200605/10/2006
    INTERQUAD SYSTEMS LIMITED29/12/200029/12/2000
    INTERQUAD DISTRIBUTION LIMITED14/05/199814/05/1998
    EXOCOM INTERNATIONAL LIMITED03/07/199003/07/1990
    POWERBAND LIMITED08/03/199008/03/1990

    Quais são as últimas contas de ISI DISTRIBUTION LTD?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2015

    Quais são as últimas submissões para ISI DISTRIBUTION LTD?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    8 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 10/08/2018

    9 páginasLIQ03

    Declaração de solvência

    4 páginasLIQ01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 11/08/2017

    LRESSP

    Estado do capital em 27/06/2017

    • Capital: GBP 100
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Share premium account cancelled 20/06/2017
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    Declaração de confirmação apresentada em 08/03/2017 com atualizações

    4 páginasCS01

    Declaração anual preparada até 08/03/2016 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital19/07/2016

    Estado do capital em 19/07/2016

    • Capital: GBP 1,100
    SH01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2015

    17 páginasAA

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Appointment of dirs 12/10/2015
    RES13

    Término da nomeação de Peter Hubbard como diretor em 29/06/2015

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr David Watts como diretor em 26/10/2015

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Howard Tuffnail como diretor em 26/10/2015

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Andy Gass como diretor em 26/10/2015

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2014

    19 páginasAA

    Declaração anual preparada até 08/03/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/06/2015

    Estado do capital em 02/06/2015

    • Capital: GBP 1,100
    SH01

    Término da nomeação de Paul Andrew Eccleston como diretor em 28/11/2014

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2013

    20 páginasAA

    Declaração anual preparada até 08/03/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital25/03/2014

    Estado do capital em 25/03/2014

    • Capital: GBP 1,100
    SH01

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/03/2014 para 30/06/2014

    3 páginasAA01

    Quem são os diretores de ISI DISTRIBUTION LTD?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    OLLIS, Rachel Anne
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretário
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    178574660001
    GASS, Andrew
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    Diretor
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    EnglandBritish49358720003
    TUFFNAIL, Howard
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    Diretor
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United KingdomCanadian202334610001
    WATTS, David
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    Diretor
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    EnglandBritish160214110001
    ARNETT, Edward Alan
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    Secretário
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    British84568350002
    HYAMS, Mitchell Spencer
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    Secretário
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    British13800580002
    JOHNSON, Ian Paul
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretário
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    British136279590001
    PENNELLS, John Richard
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    Secretário
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    British7347950001
    TRAINER, Martin John
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    Secretário
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    British124180840001
    ARNETT, Edward Alan
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    Diretor
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    British84568350002
    CORNWALL, Douglas Charles
    Domaine De La Roche
    Le Bigard
    GY8 0HT Forest
    Guernsey
    Channel Islands
    Diretor
    Domaine De La Roche
    Le Bigard
    GY8 0HT Forest
    Guernsey
    Channel Islands
    United KingdomBritish84669710001
    ECCLESTON, Paul Andrew
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish139879610001
    FANE, Sean Paul
    Nashgrove Lane
    Finchampstead
    RG40 4HG Wokingham
    131
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Nashgrove Lane
    Finchampstead
    RG40 4HG Wokingham
    131
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish67225450007
    HERRON, Bonnie Lea
    1959 Trotters Lane
    Stone Mountain
    30087 Georgia
    Usa
    Diretor
    1959 Trotters Lane
    Stone Mountain
    30087 Georgia
    Usa
    American16958430002
    HUBBARD, Peter
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish167795150001
    HYAMS, Mitchell Spencer
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    Diretor
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish13800580002
    JAMES, Philip John
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish118754760002
    JOHNSON, Ian Paul
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    Diretor
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136279590001
    MACPHERSON, William Robert George
    Benenden
    TN17 4LG Cranbrook
    Little Nineveh
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    Benenden
    TN17 4LG Cranbrook
    Little Nineveh
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish132097710001
    MARTIN, Christian John
    Kingswood House
    Tag Lane Wargrave
    RG10 9ST Reading
    Berkshire
    Diretor
    Kingswood House
    Tag Lane Wargrave
    RG10 9ST Reading
    Berkshire
    EnglandBritish113992220001
    MCCORMICK, John Edgar
    5275 Cameron Forest Parkway
    FOREIGN Alpharetti
    Georgia
    Usa
    Diretor
    5275 Cameron Forest Parkway
    FOREIGN Alpharetti
    Georgia
    Usa
    American16958460001
    MINNS, Gregory Leslie John
    113 Paddick Drive
    RG6 4HF Lower Earley
    Berkshire
    Diretor
    113 Paddick Drive
    RG6 4HF Lower Earley
    Berkshire
    United KingdomBritish72170360001
    PENNELLS, John Richard
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    Diretor
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    EnglandBritish7347950001
    RIGBY, James Peter
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish88633720001
    RIGBY, Peter, Sir
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish15654920006
    STRANGE, John Leland
    2714 Meadow Church Road
    FOREIGN Duluth
    Georgia
    Usa
    Diretor
    2714 Meadow Church Road
    FOREIGN Duluth
    Georgia
    Usa
    American16958470001
    TRAINER, Martin John
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    Diretor
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    EnglandBritish124180840001

    Quem são as pessoas com controle significativo de ISI DISTRIBUTION LTD?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Specialist Distribution Group (Sdg) Ltd
    Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AW Guildford
    Redwood 2
    England
    06/04/2016
    Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AW Guildford
    Redwood 2
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalEngland And Wales
    Local de registroEngland
    Número de registro1769690
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    ISI DISTRIBUTION LTD possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A fixed charge on book and other debts
    Criado em 04/11/2011
    Entregue em 10/11/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All book debts and other debts and monetary claims and any rent licence fees or other payments due from any lessee, licensee or occupier of any immovable property wherever.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 10/11/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 21/11/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal assignment
    Criado em 04/11/2011
    Entregue em 10/11/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any credit balance due under the contract (the contract monies).
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 10/11/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 21/11/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Criado em 04/11/2011
    Entregue em 09/11/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of fixed equitable charge all purchased debts which fail to vest effectively or absolutely in the security holder pursuant to the agreement see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transações
    • 09/11/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 21/11/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    All assets debenture
    Criado em 14/10/2010
    Entregue em 27/10/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transações
    • 27/10/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 12/11/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed & floating charge
    Criado em 15/05/2009
    Entregue em 27/05/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transações
    • 27/05/2009Registro de uma garantia (395)
    • 06/08/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 30/10/2007
    Entregue em 03/11/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland, as Security Trustee for the Finance Parties
    Transações
    • 03/11/2007Registro de uma garantia (395)
    • 09/05/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 03/06/2004
    Entregue em 05/06/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 05/06/2004Registro de uma garantia (395)
    • 13/11/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    All assets debenture
    Criado em 15/11/2000
    Entregue em 23/11/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transações
    • 23/11/2000Registro de uma garantia (395)
    • 21/12/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 02/11/2000
    Entregue em 07/11/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 07/11/2000Registro de uma garantia (395)
    • 21/12/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 05/05/1999
    Entregue em 13/05/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a guarantee agreement of even date and the deed
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Isc (Guernsey) Limited
    Transações
    • 13/05/1999Registro de uma garantia (395)
    • 21/12/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 03/02/1999
    Entregue em 16/02/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 3 february 1999
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Isc (Guernsey) Limited
    Transações
    • 16/02/1999Registro de uma garantia (395)
    • 13/05/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 28/01/1999
    Entregue em 02/02/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 02/02/1999Registro de uma garantia (395)
    • 21/12/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 21/12/1998
    Entregue em 23/12/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge over all book and other debts present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance and by way of floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    Pessoas com direito
    • Euro Sales Finance PLC
    Transações
    • 23/12/1998Registro de uma garantia (395)
    • 21/12/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    ISI DISTRIBUTION LTD possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    11/08/2017Início da liquidação
    16/01/2020Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profissional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profissional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0