SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 02486738 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?
- Outras pesquisas e desenvolvimentos experimentais em ciências naturais e engenharia (72190) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 1 Kingdom Street W2 6BD London United Kingdom |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| ROCHGRANGE LIMITED | 29/03/1990 | 29/03/1990 |
Quais são as últimas contas de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2021 |
Quais são as últimas submissões para SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Mark Gibbons como diretor em 08/11/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 28/06/2022 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2021 | 31 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Peter Michael Grubin como diretor em 01/03/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Kentaro Shirahata como diretor em 01/03/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Estado do capital em 11/11/2021
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 28/06/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2020 | 29 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mr Mark Gibbons como diretor em 30/11/2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Marc Stuart Page como diretor em 30/11/2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Nicholas Hugh Meryon Insall como diretor em 30/11/2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Sarah Lucy Charsley como diretor em 30/11/2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 28/06/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Shire Corporate Services Limited em 28/04/2020 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2019 para 31/03/2020 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Renúncia do auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2018 | 32 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 28/06/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Nicholas Hugh Meryon Insall como diretor em 28/02/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Quem são os diretores de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKEDA CORPORATE SERVICES LIMITED | Secretário | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom |
| 244206590002 | ||||||||||
| GRUBIN, Peter Michael | Diretor | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | England | American | 293835890001 | |||||||||
| PAGE, Marc Stuart | Diretor | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 277077440001 | |||||||||
| GUTHRIE, Anthony James | Secretário | Hampshire Int Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Lime Tree Way Hampshire | British | 131668010002 | ||||||||||
| HARRIS, Neil Charles | Secretário | Old Tiles Church Lane SP6 3LE Martin Hampshire | British | 96188470001 | ||||||||||
| MAY, Tatjana Anni Hilde | Secretário | Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | British | 75855670003 | ||||||||||
| MCLEAN, Andrew Firth | Secretário | Beech Cottage London Road RG27 8RN Hartley Wintney Hampshire | British | 55993260003 | ||||||||||
| MCPARTLAND, Peter | Secretário | The Forge House Church End SG8 8JN Barley Hertfordshire | British | 155226180001 | ||||||||||
| RUSSELL, Angus Charles | Secretário | High View Monks Well GU10 1RH Farnham Surrey | British | 52943380002 | ||||||||||
| STRAWBRIDGE, Oliver | Secretário | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | 202187490001 | |||||||||||
| CARRUTHERS, Fearghas Macgilp Kerr | Diretor | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 178667180002 | |||||||||
| CHARSLEY, Sarah Lucy | Diretor | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 239205090001 | |||||||||
| CLARKE, Janet | Diretor | Hainault Holt Way Hook RG27 9EW Basingstoke Hampshire | British | 14380770001 | ||||||||||
| CLEMENTS, Patrick Norris | Diretor | Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 122369120001 | |||||||||
| COLLINS, Clive John | Diretor | 9 Chanctonbury Close BN16 2JB Rustington West Sussex | British | 55993310001 | ||||||||||
| DAVIS, Trevor | Diretor | Monks Hill Oast TN27 8QJ Smarden Kent | United Kingdom | British | 37725830001 | |||||||||
| EMMENS, Matthew William | Diretor | Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | American | 88969740002 | ||||||||||
| FERDINANDO, Josephine Joan Christine | Diretor | Lime Tree Way Hampshire Int Business Park, Chineham RG24 8EP Basingstoke . Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 132556860001 | |||||||||
| GIBBONS, Mark | Diretor | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | England | South African | 248159240001 | |||||||||
| HARTLEY, Daniel William David | Diretor | Hampshire International Business Park RG24 8EP Basingstoke Hampshire | United Kingdom | Australian | 184526870001 | |||||||||
| INSALL, Nicholas Hugh Meryon | Diretor | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 248118390001 | |||||||||
| KANIS, John Anthony, Professor | Diretor | 3 Park Lane S10 2DU Sheffield South Yorkshire | British | 10424430001 | ||||||||||
| MCPARTLAND, Peter | Diretor | The Forge House Church End SG8 8JN Barley Hertfordshire | England | British | 155226180001 | |||||||||
| MILLER, Amanda | Diretor | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 186523040021 | |||||||||
| MURRAY, James Robert, Doctor | Diretor | Lamb House Ludwell SP7 9ND Shaftesbury Dorset | British | 46087170001 | ||||||||||
| RUS, Joseph | Diretor | 1 Palace Pier Court, Suite 801 Toronto Ontario M8v 3w9 Canada | Canadian | 95909400001 | ||||||||||
| RUSSELL, Angus Charles | Diretor | Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 52943380004 | |||||||||
| SHIRAHATA, Kentaro | Diretor | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | Japanese | 248114700001 | |||||||||
| SIMON, Henry | Diretor | 1 Telegraph Hill NW3 7NU London | British | 35022160001 | ||||||||||
| STAHEL, Rolf | Diretor | Neatham Sleepers Hill SO22 4NB Winchester Hampshire | United Kingdom | Swiss | 41392130001 | |||||||||
| STAMP, Stephen Antony | Diretor | Minto Cottage Rectory Lane Bentley GU10 5JS Farnham Surrey | British | 38572920003 | ||||||||||
| STRATFORD, Harry Thomas | Diretor | The Laws House TD11 3LU Duns Berwickshire | United Kingdom | British | 125826470001 | |||||||||
| TOTTEN, Joseph Wilson, Doctor | Diretor | Sycamore House Tile Barn Row Woolton Hill RG20 9TF Newbury Berkshire | British | 64168050001 | ||||||||||
| WEBB, Jonathan Ivan William | Diretor | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 220802930001 | |||||||||
| WILLIAMS, Stephen Philip | Diretor | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | England | British | 232177850001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shire Pharmaceuticals Group | 06/04/2016 | Kingdom Street W2 6BD London 1 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Criado em 23/12/1999 Entregue em 06/01/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All obligations (monetary or otherwise ) of the company to the chargee arising under or in connection with the amended and restated credit agreement dated 19TH november 1999, any interest rate swap,cap,collar or similar agreement entered into pursuant to the terms of the credit agreement, any promissory note payable to any lender under the credit agreement evidencing the agrregate indebtedness to any such lender ,any standby or commercial letters of credit any loan request any letter of credit request,the letter dated 19TH november 199 and any agreements defined therein | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed poll constituting secured loan notes 1995 | Criado em 19/12/1994 Entregue em 05/01/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the £10,000,000 10% fixed rate secured loan notes 1995 originally constituted by the deed poll or under the deed poll; and all reasonable costs, charges and expenses incurred under or in respect of the deed poll or the additional security documentation (as defined therein) by the noteholders or any by any receiver appointed under the deed poll or under the additional security documentation and all other monies properly paid by any such receiver | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0