SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED

SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02486738
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?

    • Outras pesquisas e desenvolvimentos experimentais em ciências naturais e engenharia (72190) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    1 Kingdom Street
    W2 6BD London
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ROCHGRANGE LIMITED29/03/199029/03/1990

    Quais são as últimas contas de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2021

    Quais são as últimas submissões para SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Término da nomeação de Mark Gibbons como diretor em 08/11/2022

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 28/06/2022 com atualizações

    4 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2021

    31 páginasAA

    Nomeação de Peter Michael Grubin como diretor em 01/03/2022

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Kentaro Shirahata como diretor em 01/03/2022

    1 páginasTM01

    Estado do capital em 11/11/2021

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 28/06/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2020

    29 páginasAA

    Nomeação de Mr Mark Gibbons como diretor em 30/11/2020

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Marc Stuart Page como diretor em 30/11/2020

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Nicholas Hugh Meryon Insall como diretor em 30/11/2020

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Sarah Lucy Charsley como diretor em 30/11/2020

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 28/06/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Detalhes do secretário alterados para Shire Corporate Services Limited em 28/04/2020

    1 páginasCH04

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2019 para 31/03/2020

    1 páginasAA01

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    Contas anuais preparadas até 31/12/2018

    32 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 28/06/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr Nicholas Hugh Meryon Insall como diretor em 28/02/2019

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    TAKEDA CORPORATE SERVICES LIMITED
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Secretário
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro11022500
    244206590002
    GRUBIN, Peter Michael
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    EnglandAmerican293835890001
    PAGE, Marc Stuart
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish277077440001
    GUTHRIE, Anthony James
    Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Lime Tree Way
    Hampshire
    Secretário
    Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Lime Tree Way
    Hampshire
    British131668010002
    HARRIS, Neil Charles
    Old Tiles
    Church Lane
    SP6 3LE Martin
    Hampshire
    Secretário
    Old Tiles
    Church Lane
    SP6 3LE Martin
    Hampshire
    British96188470001
    MAY, Tatjana Anni Hilde
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Secretário
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    British75855670003
    MCLEAN, Andrew Firth
    Beech Cottage
    London Road
    RG27 8RN Hartley Wintney
    Hampshire
    Secretário
    Beech Cottage
    London Road
    RG27 8RN Hartley Wintney
    Hampshire
    British55993260003
    MCPARTLAND, Peter
    The Forge House
    Church End
    SG8 8JN Barley
    Hertfordshire
    Secretário
    The Forge House
    Church End
    SG8 8JN Barley
    Hertfordshire
    British155226180001
    RUSSELL, Angus Charles
    High View
    Monks Well
    GU10 1RH Farnham
    Surrey
    Secretário
    High View
    Monks Well
    GU10 1RH Farnham
    Surrey
    British52943380002
    STRAWBRIDGE, Oliver
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Secretário
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    202187490001
    CARRUTHERS, Fearghas Macgilp Kerr
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish178667180002
    CHARSLEY, Sarah Lucy
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish239205090001
    CLARKE, Janet
    Hainault Holt Way
    Hook
    RG27 9EW Basingstoke
    Hampshire
    Diretor
    Hainault Holt Way
    Hook
    RG27 9EW Basingstoke
    Hampshire
    British14380770001
    CLEMENTS, Patrick Norris
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Diretor
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish122369120001
    COLLINS, Clive John
    9 Chanctonbury Close
    BN16 2JB Rustington
    West Sussex
    Diretor
    9 Chanctonbury Close
    BN16 2JB Rustington
    West Sussex
    British55993310001
    DAVIS, Trevor
    Monks Hill Oast
    TN27 8QJ Smarden
    Kent
    Diretor
    Monks Hill Oast
    TN27 8QJ Smarden
    Kent
    United KingdomBritish37725830001
    EMMENS, Matthew William
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Diretor
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    American88969740002
    FERDINANDO, Josephine Joan Christine
    Lime Tree Way
    Hampshire Int Business Park, Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    .
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Lime Tree Way
    Hampshire Int Business Park, Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    .
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish132556860001
    GIBBONS, Mark
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    EnglandSouth African248159240001
    HARTLEY, Daniel William David
    Hampshire International Business Park
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Diretor
    Hampshire International Business Park
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomAustralian184526870001
    INSALL, Nicholas Hugh Meryon
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish248118390001
    KANIS, John Anthony, Professor
    3 Park Lane
    S10 2DU Sheffield
    South Yorkshire
    Diretor
    3 Park Lane
    S10 2DU Sheffield
    South Yorkshire
    British10424430001
    MCPARTLAND, Peter
    The Forge House
    Church End
    SG8 8JN Barley
    Hertfordshire
    Diretor
    The Forge House
    Church End
    SG8 8JN Barley
    Hertfordshire
    EnglandBritish155226180001
    MILLER, Amanda
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish186523040021
    MURRAY, James Robert, Doctor
    Lamb House
    Ludwell
    SP7 9ND Shaftesbury
    Dorset
    Diretor
    Lamb House
    Ludwell
    SP7 9ND Shaftesbury
    Dorset
    British46087170001
    RUS, Joseph
    1 Palace Pier Court, Suite 801
    Toronto
    Ontario M8v 3w9
    Canada
    Diretor
    1 Palace Pier Court, Suite 801
    Toronto
    Ontario M8v 3w9
    Canada
    Canadian95909400001
    RUSSELL, Angus Charles
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    Diretor
    Hampshire International Business
    Park Chineham
    RG24 8EP Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish52943380004
    SHIRAHATA, Kentaro
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomJapanese248114700001
    SIMON, Henry
    1 Telegraph Hill
    NW3 7NU London
    Diretor
    1 Telegraph Hill
    NW3 7NU London
    British35022160001
    STAHEL, Rolf
    Neatham Sleepers Hill
    SO22 4NB Winchester
    Hampshire
    Diretor
    Neatham Sleepers Hill
    SO22 4NB Winchester
    Hampshire
    United KingdomSwiss41392130001
    STAMP, Stephen Antony
    Minto Cottage Rectory Lane
    Bentley
    GU10 5JS Farnham
    Surrey
    Diretor
    Minto Cottage Rectory Lane
    Bentley
    GU10 5JS Farnham
    Surrey
    British38572920003
    STRATFORD, Harry Thomas
    The Laws House
    TD11 3LU Duns
    Berwickshire
    Diretor
    The Laws House
    TD11 3LU Duns
    Berwickshire
    United KingdomBritish125826470001
    TOTTEN, Joseph Wilson, Doctor
    Sycamore House Tile Barn Row
    Woolton Hill
    RG20 9TF Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Sycamore House Tile Barn Row
    Woolton Hill
    RG20 9TF Newbury
    Berkshire
    British64168050001
    WEBB, Jonathan Ivan William
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish220802930001
    WILLIAMS, Stephen Philip
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish232177850001

    Quem são as pessoas com controle significativo de SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Shire Pharmaceuticals Group
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    England
    06/04/2016
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    1
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Unlimited Liability Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroEngland & Wales
    Número de registro2883758
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 23/12/1999
    Entregue em 06/01/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All obligations (monetary or otherwise ) of the company to the chargee arising under or in connection with the amended and restated credit agreement dated 19TH november 1999, any interest rate swap,cap,collar or similar agreement entered into pursuant to the terms of the credit agreement, any promissory note payable to any lender under the credit agreement evidencing the agrregate indebtedness to any such lender ,any standby or commercial letters of credit any loan request any letter of credit request,the letter dated 19TH november 199 and any agreements defined therein
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Dlj Capital Funding Inc.
    Transações
    • 06/01/2000Registro de uma garantia (395)
    • 02/01/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed poll constituting secured loan notes 1995
    Criado em 19/12/1994
    Entregue em 05/01/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the £10,000,000 10% fixed rate secured loan notes 1995 originally constituted by the deed poll or under the deed poll; and all reasonable costs, charges and expenses incurred under or in respect of the deed poll or the additional security documentation (as defined therein) by the noteholders or any by any receiver appointed under the deed poll or under the additional security documentation and all other monies properly paid by any such receiver
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The "Noteholders"
    Transações
    • 05/01/1995Registro de uma garantia (395)
    • 03/08/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0