LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED

LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaLLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02491595
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Agências de publicidade (73110) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o MSQ PARTNERS LIMITED
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    DVL SMITH (MSQH) LIMITED08/03/200608/03/2006
    CITIGATE DVL SMITH LIMITED09/08/200009/08/2000
    D V L SMITH GROUP LIMITED31/03/199831/03/1998
    D.V.L. SMITH LIMITED14/06/199314/06/1993
    D.V.L. SMITH & ASSOCIATES LIMITED10/04/199010/04/1990

    Quais são as últimas contas de LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até28/02/2015

    Quais são as últimas submissões para LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 10/04/2016 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital14/04/2016

    Estado do capital em 14/04/2016

    • Capital: GBP 380,000
    SH01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de 10 Rathbone Place London W1T 1HP England para C/O Browne Jacobson Llp 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA

    1 páginasAD02

    Os registos foram transferidos para o endereço do domicílio registado C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ

    1 páginasAD04

    Contas anuais preparadas até 28/02/2015

    17 páginasAA

    Declaração anual preparada até 10/04/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital10/04/2015

    Estado do capital em 10/04/2015

    • Capital: GBP 380,000
    SH01

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada 10 Rathbone Place London W1T 1HP

    1 páginasAD03

    O endereço de inspeção do registo foi alterado para 10 Rathbone Place London W1T 1HP

    1 páginasAD02

    Contas anuais preparadas até 28/02/2014

    18 páginasAA

    Memorando e estatutos

    10 páginasMA

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de alteração dos estatutos

    RES01
    capital

    Resoluções

    Various agreements as listed 16/07/2014
    RES13

    Satisfação total da garantia 4

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 3

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 5

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 024915950006

    4 páginasMR04

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Msq Partners Ltd 6 York Street London W1U 6PL para C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ em 13/08/2014

    1 páginasAD01

    Registo da garantia 024915950008, criada em 16/07/2014

    59 páginasMR01

    Registo da garantia 024915950007, criada em 16/07/2014

    55 páginasMR01

    Declaração anual preparada até 10/04/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital10/04/2014

    Estado do capital em 10/04/2014

    • Capital: GBP 380,000
    SH01

    Contas anuais preparadas até 28/02/2013

    17 páginasAA

    Registo da garantia 024915950006

    17 páginasMR01

    Nomeação de Mr Daniel Yardley como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Dean Wright como diretor

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SHAH, Ashish
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Secretário
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    164776630001
    REID, Peter David
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Diretor
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritish147274580002
    YARDLEY, Daniel John
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Diretor
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritish180507300001
    BRIGDEN, Colin John
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Secretário
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    147341370001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    Secretário
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    British76600500002
    CLARKE, Martin John
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    Secretário
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    British53461320002
    LEES, Jennifer Kathryn
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    Secretário
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    British24587010002
    NICHOLS, Richard Stephen
    3a Devonshire Road
    AL5 4TJ Harpenden
    Hertfordshire
    Secretário
    3a Devonshire Road
    AL5 4TJ Harpenden
    Hertfordshire
    British54128690001
    SMITH, Josephine Mary
    Waverley
    8 Pump Lane
    CM16 6PR Epping Green
    Essex
    Secretário
    Waverley
    8 Pump Lane
    CM16 6PR Epping Green
    Essex
    British96496420001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Secretário
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    British147948820001
    BROWN, Joseph
    16 Drayton Gardens
    Winchmore Hill
    N21 2NS London
    Diretor
    16 Drayton Gardens
    Winchmore Hill
    N21 2NS London
    EnglandBritish77616350001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    Diretor
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritish75720570001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    Diretor
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    EnglandBritish76600500002
    CONNAUGHTON, John
    10 Hawarden Road
    E17 6NS London
    Diretor
    10 Hawarden Road
    E17 6NS London
    British56652120002
    CONNAUGHTON, John
    111 Lindsey Street
    CM16 6RE Epping
    Essex
    Diretor
    111 Lindsey Street
    CM16 6RE Epping
    Essex
    British56652120001
    DEXTER, Andrew John
    1 Novara Row
    Calabria Road Highbury
    N5 1JL London
    Diretor
    1 Novara Row
    Calabria Road Highbury
    N5 1JL London
    United KingdomBritish33183620006
    FLETCHER, Jonathan
    25 Ronver Road
    Lee
    SE12 0NR London
    Diretor
    25 Ronver Road
    Lee
    SE12 0NR London
    British77616450001
    GROGAN, Aunia Judith
    44b Cecilia Road
    Hackney
    E8 2ER London
    Diretor
    44b Cecilia Road
    Hackney
    E8 2ER London
    British56652070001
    HURST, Katharine Louise Florence
    135 Widdenham Road
    N7 9SF London
    Diretor
    135 Widdenham Road
    N7 9SF London
    British93216430001
    MULHOLLAND, Gavin
    9 Lynton Avenue
    North Finchley
    N12 9JH London
    Diretor
    9 Lynton Avenue
    North Finchley
    N12 9JH London
    EnglandBritish93216470001
    NICHOLS, Richard Stephen
    15a Rothamsted Avenue
    AL5 2DD Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    15a Rothamsted Avenue
    AL5 2DD Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish54128690003
    SELMAN, Roger Malcolm
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    Diretor
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    United KingdomBritish10691510002
    SMITH, David Van Lloyd, Dr
    Flat 169 Free Trade Wharf
    340 The Highway
    E1W 3EU London
    Diretor
    Flat 169 Free Trade Wharf
    340 The Highway
    E1W 3EU London
    EnglandBritish26665360003
    SMITH, Josephine Mary
    Waverley
    8 Pump Lane
    CM16 6PR Epping Green
    Essex
    Diretor
    Waverley
    8 Pump Lane
    CM16 6PR Epping Green
    Essex
    British96496420001
    SOADY, Kevin James
    29 Richmond Avenue
    N1 0NB London
    Diretor
    29 Richmond Avenue
    N1 0NB London
    British61604720001
    STEEDS, Kevin Barrie
    20 Fortismere Avenue
    Muswell Hill
    N10 3BL London
    Diretor
    20 Fortismere Avenue
    Muswell Hill
    N10 3BL London
    British14119150003
    WHITE, Jonathan Christian
    80 Victory Road
    Wanstead
    E11 1UL London
    Diretor
    80 Victory Road
    Wanstead
    E11 1UL London
    British93041570001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Diretor
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    United KingdomBritish147948820001
    WORTHINGTON, David Howard
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Diretor
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritish23127210001
    WRIGHT, David Ernest
    The Priory
    23 Matham Road
    KT8 0SX East Molesey
    Surrey
    Diretor
    The Priory
    23 Matham Road
    KT8 0SX East Molesey
    Surrey
    British14119160001
    WRIGHT, Dean Anthony
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    Diretor
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    EnglandBritish159138180001

    LLOYD NORTHOVER BRAND COMMUNICATIONS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 16/07/2014
    Entregue em 21/07/2014
    Pendente
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Nvm Private Equity Limited
    Transações
    • 21/07/2014Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 16/07/2014
    Entregue em 18/07/2014
    Pendente
    Breve descrição
    Description of all registered intellectual property rights subject to this security can be found in schedule 5 of the debenture.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Agent for National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 18/07/2014Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 27/09/2013
    Entregue em 04/10/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transações
    • 04/10/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 02/09/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Supplemental debenture
    Criado em 06/02/2012
    Entregue em 23/02/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transações
    • 23/02/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 02/09/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Criado em 08/12/2011
    Entregue em 29/12/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Any sum standing to the credit of an account whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 29/12/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 02/09/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 08/12/2011
    Entregue em 20/12/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 20/12/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 02/09/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Accession deed
    Criado em 04/11/2005
    Entregue em 17/11/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transações
    • 17/11/2005Registro de uma garantia (395)
    • 22/12/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture deed
    Criado em 13/03/1998
    Entregue em 17/03/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 17/03/1998Registro de uma garantia (395)
    • 22/12/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0