INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Ativa |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 02502094 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY LIMITED?
- Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio
Onde fica INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY LIMITED?
Endereço do escritório registrado | The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
IMICO LIMITED | 27/06/1990 | 27/06/1990 |
BLOOMFORCE LIMITED | 15/05/1990 | 15/05/1990 |
Quais são as últimas contas de INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY LIMITED?
Vencido | Sim |
---|---|
Próximas contas | |
Próximo período contábil termina em | 31/12/2016 |
Próximas contas vencem em | 30/09/2017 |
Últimas contas | |
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2015 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY LIMITED?
Vencido | Sim |
---|---|
Última declaração de confirmação elaborada até | 15/05/2018 |
Próxima declaração de confirmação vence | 29/05/2018 |
Última declaração de confirmação | |
Próxima declaração de confirmação elaborada até | 15/05/2017 |
Vencido | Sim |
Quais são as últimas submissões para INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restauração por ordem judicial | 3 páginas | AC92 | ||||||||||
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 15/05/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de John Daniel Sheehan como diretor em 27/02/2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Kevin Patrick Bradley como diretor em 27/02/2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 15/05/2016 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de Ronald Matthew Defeo como diretor em 11/12/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 15/05/2015 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 15/05/2014 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 15/05/2013 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Kevin Patrick Bradley como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Phillip Widman como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 15/05/2012 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Ronald Matthew Defeo em 15/05/2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2010 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 15/05/2011 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de * C/O Denton Wilde Sapte Llp the Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE* em 24/05/2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de * 252 Upper Third Street Grafton Gate East Milton Keynes MK9 1DZ* em 06/08/2010 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Quem são os diretores de INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHEN, Eric I | Secretário | Burnham Hill Road Westport Connecticut, 06880 32 Fairfield Usa | American | 65582430009 | ||||||
COHEN, Eric I | Diretor | Burnham Hill Road Westport Connecticut, 06880 32 Fairfield Usa | United States | American | Director | 65582430009 | ||||
SHEEHAN, John Daniel | Diretor | 200 Nyala Farm Road 06880 Westport C/O Terex Corporation Usa | United States | American | Chief Financial Officer | 226001330001 | ||||
BAILLIE, Fergus Cumming | Secretário | 4 Abinger Gardens Murrayfield EH12 6DE Edinburgh Scotland | British | Company Director | 924340002 | |||||
BUCKLEY, Leslie Bertram | Secretário | 21 Cumberland Avenue Fixby HD2 2JJ Huddersfield West Yorkshire | British | 11338150001 | ||||||
HOPKINSON, Philip Michael | Secretário | The Hawthorns Park Road Colton Old Village LS15 9AJ Leeds West Yorkshire | British | 40744770001 | ||||||
BAILLIE, Fergus Cumming | Diretor | 4 Abinger Gardens Murrayfield EH12 6DE Edinburgh Scotland | British | Company Director | 924340002 | |||||
BARKER, James Edward | Diretor | The Old Vicarage Cragg Vale HX7 5TB Hebden Bridge West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 42890001 | ||||
BRADLEY, Kevin Patrick | Diretor | 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes The Pinnacle United Kingdom | Untied States Of America | American | Senior Vice President, Chief Financial Officer | 176590390001 | ||||
BROWN, Gordon | Diretor | Weston Moor Cottage Weston Moor Road, Weston LS21 2NB Harrogate | England | British | Company Director | 116221550001 | ||||
BUCHAN, William Strachan | Diretor | 14 Greenlaw Road Newton Mearns G77 6ND Glasgow Lanarkshire | British | Company Director | 6506130001 | |||||
BUCKLEY, Leslie Bertram | Diretor | 21 Cumberland Avenue Fixby HD2 2JJ Huddersfield West Yorkshire | British | Company Director | 11338150001 | |||||
DALRYMPLE, William | Diretor | 6 Conifer Place Kirkintilloch G66 4EJ Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Company Director | 1011000001 | ||||
DEFEO, Ronald Matthew | Diretor | Beachside Avenue Westport 45 Connecticut 06880 Usa | United States | American | Director | 94656950001 | ||||
GRAHAM, Steven Andrew | Diretor | Gillows Croft Shirley B90 4UH Solihull 12 West Midlands | United Kingdom | British | Tax Manager | 132334330001 | ||||
HALLALA, Mark John | Diretor | 52 Church Walk KT7 0NW Thames Ditton Surrey | British | Chartered Accountant | 37953240001 | |||||
KEMP, Charles Richard Foster | Diretor | 13 Lime Court Gipsy Lane SW15 5RJ London | British | Company Director | 20392890001 | |||||
ROBERTSON, Colin | Diretor | 4 Leemuir View ML8 4AN Carluke South Lanarkshire | British | Managing Director | 77076440001 | |||||
STEWART, Michael Gavin | Diretor | 22 Belmont Drive Giffnock G46 7PA Glasgow | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 59163490001 | ||||
WHALLEY, Jeffrey | Diretor | Broncroft Castle Broncroft SY7 9HL Craven Arms Shropshire | United Kingdom | British | Company Director | 1955430002 | ||||
WIDMAN, Phillip Charles | Diretor | 25 Old Stone Crossing West Simsbury Connecticut 06092 Usa | Usa | American | Director | 144249950001 | ||||
WILLS, David John | Diretor | 15 Kildare Gardens W2 5JS London | England | English | Company Director | 6523330001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Terex Holdings Uk Limited | 06/04/2016 | 170 Midsummer Boulevard MK9 1FE Milton Keynes The Pinnacle England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating charge | Criado em 24/01/1996 Entregue em 01/02/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Floating charge debenture | Criado em 21/12/1994 Entregue em 06/01/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a guarantee of even date | |
Breve descrição All the company's present and future undertaking and assets whatsoever and wheresoever but excluding the f/h premises k/a the former home office supply and transport supply and transport store t/no nyk 70538. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 01/07/1991 Entregue em 04/07/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Former home office supply and transport store marston moor, north yorkshire. T/n-nyk 70538 the benefit of all covenants and rights relating to the property plant and machinery implements utensils furniture and equipment fixtures and fittings. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 24/05/1991 Entregue em 05/06/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Freehold property k/A. Riffa depot poole in wharfedale, harrogate north yorkshire title no. Nyk 209893. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture & floating charge | Criado em 04/02/1991 Entregue em 07/02/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 04/02/1991 Entregue em 07/02/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Former home office supply & transport store marston moor tockwith north yorkshire. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
General charge | Criado em 08/11/1990 Entregue em 20/11/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 08/11/1990 Entregue em 19/11/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1,080,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descrição F/H the former home office supply and transport store marston moor north yorkshire. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0