NSIP (ETS) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaNSIP (ETS) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02504173
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de NSIP (ETS) LIMITED?

    • Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural (09100) / Exploração de minas e pedreiras

    Onde fica NSIP (ETS) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Suite 1, 3rd Floor 11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de NSIP (ETS) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CH4 PIPELINES LIMITED28/07/200328/07/2003
    CALENERGY GAS (PIPELINES) LIMITED08/12/199708/12/1997
    POWER TOWER LIMITED06/07/199006/07/1990
    HASTESPOT LIMITED21/05/199021/05/1990

    Quais são as últimas contas de NSIP (ETS) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2018

    Quais são as últimas submissões para NSIP (ETS) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Thomas Jack Robert Luypaert em 08/06/2020

    2 páginasCH01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2020 com atualizações

    4 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Thomas Jack Robert Luypaert em 30/01/2020

    2 páginasCH01

    Alteração dos detalhes de Kellas North Sea 2 Limited como pessoa com controlo significativo em 30/01/2020

    2 páginasPSC05

    Detalhes do diretor alterados para Mr Andrew David Hessell em 30/01/2020

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Guy Robert Maurice Appleton em 30/01/2020

    2 páginasCH01

    Endereço do domicílio registado alterado de 14 st. George Street London W1S 1FE United Kingdom para Suite 1, 3rd Floor 11-12 st James's Square London SW1Y 4LB em 04/02/2020

    1 páginasAD01

    Nomeação de Mr Thomas Jack Robert Luypaert como diretor em 30/01/2020

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Guillaume Jacques Robert Friedel como diretor em 30/01/2020

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Stephane Julien Ifker como diretor em 30/01/2020

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Mark John Crosbie como diretor em 30/01/2020

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Guillaume Jacques Robert Friedel em 01/08/2019

    2 páginasCH01

    Alteração dos detalhes de Antin North Sea 2 Limited como pessoa com controlo significativo em 16/09/2019

    2 páginasPSC05

    Contas anuais preparadas até 31/12/2018

    24 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2019 com atualizações

    4 páginasCS01

    Satisfação total da garantia 025041730011

    4 páginasMR04

    Segunda apresentação para a nomeação de Mr Mark John Crosbie como administrador

    6 páginasRP04AP01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Guillaume Jacques Robert Friedel em 20/06/2018

    2 páginasCH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2017

    25 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de 14 st George Street London London W1S 1FE para 14 st. George Street London W1S 1FE em 05/07/2018

    1 páginasAD01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    Alteração dos detalhes de Antin North Sea 2 Limited como pessoa com controlo significativo em 15/02/2018

    2 páginasPSC05

    Quem são os diretores de NSIP (ETS) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    APPLETON, Guy Robert Maurice
    7th Floor, The Silver Fin Building
    455 Union Street
    AB11 6DB Aberdeen
    Kellas Midstream Limited
    United Kingdom
    Diretor
    7th Floor, The Silver Fin Building
    455 Union Street
    AB11 6DB Aberdeen
    Kellas Midstream Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish156848840001
    HESSELL, Andrew David
    7th Floor, The Silver Fin Building
    455 Union Street
    AB11 6DB Aberdeen
    Kellas Midstream Limited
    United Kingdom
    Diretor
    7th Floor, The Silver Fin Building
    455 Union Street
    AB11 6DB Aberdeen
    Kellas Midstream Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish221140270001
    LUYPAERT, Thomas Jack Robert
    Throgmorton Avenue
    EC2N 2DL London
    12
    United Kingdom
    Diretor
    Throgmorton Avenue
    EC2N 2DL London
    12
    United Kingdom
    United KingdomFrench264133230002
    GILES, Gail Valerie
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    Secretário
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    British108926390001
    HOBDEN, Brian
    40 Woodburn Crescent
    AB15 8JX Aberdeen
    Secretário
    40 Woodburn Crescent
    AB15 8JX Aberdeen
    British81368370001
    KIRK, Philip Andrew
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    Secretário
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    British84103730001
    MISTRY, Bhavna
    37 Warren Road
    Whitton
    TW2 7DH Twickenham
    Middlesex
    Secretário
    37 Warren Road
    Whitton
    TW2 7DH Twickenham
    Middlesex
    British87625170001
    SPARKES, Michael Jack
    The Pantiles Main Street
    Thorney
    NG23 7BS Newark
    Nottinghamshire
    Secretário
    The Pantiles Main Street
    Thorney
    NG23 7BS Newark
    Nottinghamshire
    British43902400001
    WAITE, Simon Nicholas
    2 Chestnut Lane
    AB31 5PH Banchory
    Aberdeenshire
    Secretário
    2 Chestnut Lane
    AB31 5PH Banchory
    Aberdeenshire
    British117008750002
    CENTRICA SECRETARIES LIMITED
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Secretário
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro4049225
    146095800001
    WEIL, GOTSHAL & MANGES (LONDON) LLP
    Fetter Lane
    EC4A 1AY London
    110
    United Kingdom
    Secretário
    Fetter Lane
    EC4A 1AY London
    110
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registroOC400678
    199087250001
    ABEL, Gregory Edward
    4710 George Mills Parkway 402
    50265 West Des Moines
    Iowa
    United States
    Diretor
    4710 George Mills Parkway 402
    50265 West Des Moines
    Iowa
    United States
    UsaCanadian52806480009
    BEGBIE, Roderick Mcintosh
    11 Kepplestone Gardens
    AB15 4DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Diretor
    11 Kepplestone Gardens
    AB15 4DH Aberdeen
    Aberdeenshire
    British115205850001
    BRICKNELL, Bruce David Neil
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish184345640001
    CLAYTON, Marie-Louise
    309 North Deeside Road
    AB13 0DL Aberdeen
    Diretor
    309 North Deeside Road
    AB13 0DL Aberdeen
    British103782580001
    CONNOR, Phillip Eric
    Billy Hill House
    Stanley
    DL15 9QS Crook
    County Durham
    Diretor
    Billy Hill House
    Stanley
    DL15 9QS Crook
    County Durham
    EnglandEnglish72946860001
    CROSBIE, Mark John
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    Diretor
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    United KingdomBritish211079810001
    DAVIES, John George
    Cotchet Barn Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    Diretor
    Cotchet Barn Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    British54724650001
    DIXON, Ronald
    1 Berkley Avenue
    NE21 5NN Blaydon
    Tyne & Wear
    Diretor
    1 Berkley Avenue
    NE21 5NN Blaydon
    Tyne & Wear
    EnglandBritish2318270001
    FRIEDEL, Guillaume Jacques Robert
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    Diretor
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    United StatesFrench189459340023
    GILES, Gail Valerie
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    Diretor
    North Sundaysight
    Bellingham
    NE48 2JE Hexham
    Northumberland
    EnglandBritish108926390001
    GROVES, Alan
    37 Avondale Road
    Ponteland
    NE20 9NA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Diretor
    37 Avondale Road
    Ponteland
    NE20 9NA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British2318230001
    GUGEN, Francis Robert
    Down Street
    W1J 7AJ London
    7
    Diretor
    Down Street
    W1J 7AJ London
    7
    United KingdomBritish388450006
    HANAFIN, Vincent Mark
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Diretor
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United KingdomBritish131999620002
    IFKER, Stephane Julien
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    Diretor
    St. George Street
    W1S 1FE London
    14
    United Kingdom
    FranceFrench229631470001
    KIRK, Philip Andrew
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    Diretor
    5 Old Deer Park Gardens
    TW9 2TN Richmond
    Surrey
    British84103730001
    LE POIDEVIN, Andrew Daryl
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Diretor
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    EnglandBritish4958800007
    LINGE, Kenneth
    Drystones Heugh House Lane
    NE47 6ND Haydon Bridge
    Northumberland
    Diretor
    Drystones Heugh House Lane
    NE47 6ND Haydon Bridge
    Northumberland
    EnglandBritish52698930001
    LUMSDEN, Roy Andrew
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Diretor
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United KingdomBritish199053700001
    MORRIS, David Richard
    Churchfield 1 Top Street
    Wing
    LE15 8SE Oakham
    Leicestershire
    Diretor
    Churchfield 1 Top Street
    Wing
    LE15 8SE Oakham
    Leicestershire
    United KingdomBritish36692700001
    MURPHY, Jonathan David
    74 Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Diretor
    74 Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    Aberdeenshire
    British115205970001
    OZSANLAV, Richard
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish147826530002
    PICOTTE, Christopher
    200 Clarendon Street 55th Floor
    MA 02117 Boston
    Arclight Capital Partners Llc
    Usa
    Diretor
    200 Clarendon Street 55th Floor
    MA 02117 Boston
    Arclight Capital Partners Llc
    Usa
    American116230600001
    ROGER, Jonathan Leslie
    AB15
    Diretor
    AB15
    United KingdomBritish124423900001
    ROGER, Jonathan Leslie
    AB15
    Diretor
    AB15
    United KingdomBritish124423900001

    Quem são as pessoas com controle significativo de NSIP (ETS) LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    21/12/2017
    11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    Suite 1, 3rd Floor
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUnited Kingdom
    Local de registroCompanies House
    Número de registro10778448
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    06/04/2016
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Sim
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUnited Kingdom
    Local de registroCompanies House
    Número de registro3186121
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    NSIP (ETS) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 26/03/2018
    Entregue em 26/03/2018
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    N/A.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Rbc Europe Limited
    Transações
    • 26/03/2018Registro de uma garantia (MR01)
    • 02/04/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 24/01/2007
    Entregue em 31/01/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company or any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All of the chargor's rights to and title and interest from time to time in the whole of its property,assets,rights and revenues,whatsoever and wheresoever,present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transações
    • 31/01/2007Registro de uma garantia (395)
    • 13/08/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Bond and floating charge
    Criado em 22/01/2007
    Entregue em 31/01/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company or any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Floating charge over the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transações
    • 31/01/2007Registro de uma garantia (395)
    • 07/09/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 21/07/2006
    Entregue em 28/07/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company or any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the company's rights to and title and interest from time to time in the relevant project accounts, all account proceeds, by way of first floating charge all the company's rights to and title and interest from time to time in the whole of its property, assets, rights and revenues. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Abn Amro Bank N.V. (The Security Trustee)
    Transações
    • 28/07/2006Registro de uma garantia (395)
    • 07/09/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Third supplemental deed of amendment to a note purchase agreement dated 23 december 2003 and
    Criado em 27/01/2006
    Entregue em 09/02/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any group company to the senior finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    If any borrower or the issuer makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of all or any part of the junior liabilities or the subordianted liabilies or the junior lender or any subordianted lender recieves all or any amount in cash, the junior lender will hold any amount so received on trust for the collateral agent,. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Deutsche Bank Ag (The Collateral Agent)
    Transações
    • 09/02/2006Registro de uma garantia (395)
    • 28/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    First supplemental deed of amendment to a guarantee and debenture dated 23 december 2003 and
    Criado em 27/01/2006
    Entregue em 09/02/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company or CH4 energy limited to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Deutsche Bank Ag (The Collateral Agent)
    Transações
    • 09/02/2006Registro de uma garantia (395)
    • 28/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Second supplemental deed of amendment dated 23 december 2005
    Criado em 23/12/2005
    Entregue em 10/01/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the parent or the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Deutsche Bank Ag (The Collateral Agent)
    Transações
    • 10/01/2006Registro de uma garantia (395)
    • 28/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 23/12/2003
    Entregue em 13/01/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the parent or the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Deutsche Bank Ag
    Transações
    • 13/01/2004Registro de uma garantia (395)
    • 28/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 21/08/2003
    Entregue em 04/09/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • 3I Group PLC
    Transações
    • 04/09/2003Registro de uma garantia (395)
    • 18/05/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental debenture
    Criado em 01/07/1999
    Entregue em 14/07/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each borrower (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document to which such borrower is a party
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 14/07/1999Registro de uma garantia (395)
    • 18/04/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 05/06/1998
    Entregue em 22/06/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities of each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for each finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Breve descrição
    By way of first fixed charge all its respective present and future right and title to and interest in the charged assets by way of first floating charge all its assets and undertaking whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 22/06/1998Registro de uma garantia (395)
    • 18/04/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0