ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED

ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02508326
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED?

    • (6603) /

    Onde fica ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    KILN COTESWORTH STEWART LIMITED 18/03/199718/03/1997
    KILN COTESWORTH MEMBERS AGENCY LIMITED06/01/199406/01/1994
    KILN MEMBERS AGENCY LIMITED29/06/199029/06/1990
    FLOWFACTOR LIMITED04/06/199004/06/1990

    Quais são as últimas contas de ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2008

    Quais são as últimas submissões para ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    6 páginas4.71

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 28/07/2012

    7 páginas4.68

    Endereço do domicílio registado alterado de Fountain House C/O Argenta Private Capital Limited, 130 Fenchurch Street London EC3M 5DJ em 05/09/2011

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    5 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 29/07/2011

    LRESSP

    Término da nomeação de Ian Taylor como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 21/01/2011 com lista completa de acionistas

    14 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital24/01/2011

    Estado do capital em 24/01/2011

    • Capital: GBP 500,200
    SH01

    Declaração anual preparada até 21/01/2010 com lista completa de acionistas

    10 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Fiona Ann Blood em 21/01/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para William David Robson em 21/01/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para John Robert Robson em 21/01/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Antony John Smithson em 21/01/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Ian Auburn Cowing Taylor em 21/01/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Milka Jacoby em 21/01/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Andrew Michael Colcomb em 21/01/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Christopher John Rupert Fairs em 21/01/2010

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Robert Paul Flach em 21/01/2010

    2 páginasCH01

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2009 para 30/06/2010

    1 páginasAA01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2008

    17 páginasAA

    legacy

    7 páginas363a

    Contas anuais preparadas até 31/12/2007

    15 páginasAA

    legacy

    7 páginas363a

    Contas anuais preparadas até 31/12/2006

    16 páginasAA

    Quem são os diretores de ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    COLCOMB, Andrew Michael
    128 High Street
    Hadleigh
    IP7 5EL Ipswich
    Suffolk
    Secretário
    128 High Street
    Hadleigh
    IP7 5EL Ipswich
    Suffolk
    British81668440001
    BLOOD, Fiona Ann
    32 Vale Road
    KT10 0NJ Claygate
    Surrey
    Diretor
    32 Vale Road
    KT10 0NJ Claygate
    Surrey
    EnglandBritish75768690001
    BRAY, Jeremy Mark
    The High Beeches
    Handcross
    RH17 6QH West Sussex
    Diretor
    The High Beeches
    Handcross
    RH17 6QH West Sussex
    EnglandBritish23885670002
    COLCOMB, Andrew Michael
    128 High Street
    Hadleigh
    IP7 5EL Ipswich
    Suffolk
    Diretor
    128 High Street
    Hadleigh
    IP7 5EL Ipswich
    Suffolk
    United KingdomBritish81668440001
    FAIRS, Christopher John Rupert
    6 Tufa Close
    Walderslade Woods
    ME5 9LU Chatham
    Kent
    Diretor
    6 Tufa Close
    Walderslade Woods
    ME5 9LU Chatham
    Kent
    United KingdomBritish63723860002
    FLACH, Robert Paul
    4 Old Hatch Manor
    HA4 8QG Ruislip
    Middlesex
    Diretor
    4 Old Hatch Manor
    HA4 8QG Ruislip
    Middlesex
    EnglandBritish253187050001
    JACOBY, Milka
    14 Park Way
    Shenfield
    CM15 8LH Brentwood
    Essex
    Diretor
    14 Park Way
    Shenfield
    CM15 8LH Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish29062500001
    ROBSON, John Robert
    Melbourne Stud
    Ayton Green
    AL6 9BB Welwyn
    Hertfordshire
    Diretor
    Melbourne Stud
    Ayton Green
    AL6 9BB Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritish24465330001
    ROBSON, William David
    The Woods
    Hatfield Broadoak
    CM22 7BU Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Diretor
    The Woods
    Hatfield Broadoak
    CM22 7BU Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish7309190001
    SMITHSON, Antony John
    1 Cardwell Crescent
    Sunninghill
    SL5 9AW Ascot
    Berkshire
    Diretor
    1 Cardwell Crescent
    Sunninghill
    SL5 9AW Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish16035440001
    BUTLER, Roy Joseph
    Heydour,24 Glebe Road
    Purley On Thames
    RG8 8DP Reading
    Berkshire
    England
    Secretário
    Heydour,24 Glebe Road
    Purley On Thames
    RG8 8DP Reading
    Berkshire
    England
    British39597150001
    KAUNTZE, Ralph Anthony Charles
    Hansford House
    EX37 9ES Umberleigh
    North Devon
    Secretário
    Hansford House
    EX37 9ES Umberleigh
    North Devon
    British14338500002
    TAYLOR, Ian Auburn Cowing
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    Secretário
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    British4866920001
    AITCHISON, Peter John
    Upper Weston House
    Cot Lane, Chidham
    PO18 8SU Chichester
    West Sussex
    Diretor
    Upper Weston House
    Cot Lane, Chidham
    PO18 8SU Chichester
    West Sussex
    British3693350002
    BONNER, Alan James
    Widdington Hall Church Lane
    Widdington
    CB11 3SF Saffron Walden
    Essex
    Diretor
    Widdington Hall Church Lane
    Widdington
    CB11 3SF Saffron Walden
    Essex
    British36779200001
    BUTLER, Roy Joseph
    Heydour,24 Glebe Road
    Purley On Thames
    RG8 8DP Reading
    Berkshire
    England
    Diretor
    Heydour,24 Glebe Road
    Purley On Thames
    RG8 8DP Reading
    Berkshire
    England
    British39597150001
    COMBE, Kenneth Christian
    Ashlands Court
    SN16 9SR Malmesbury
    Wiltshire
    Diretor
    Ashlands Court
    SN16 9SR Malmesbury
    Wiltshire
    British3787020003
    DANN, David Linton
    Cuppes House Bells Lane
    Hoo
    ME3 9HT Rochester
    Kent
    Diretor
    Cuppes House Bells Lane
    Hoo
    ME3 9HT Rochester
    Kent
    British8646650001
    DUNKLEY, Christopher Leslie
    Knowle Hill House
    Ulcombe
    ME17 1ES Maidstone
    Kent
    Diretor
    Knowle Hill House
    Ulcombe
    ME17 1ES Maidstone
    Kent
    EnglandBritish7932240001
    FLEMING-WILLIAMS, Robert Andrew
    13 Woodborough Road
    SW15 6DY London
    Diretor
    13 Woodborough Road
    SW15 6DY London
    United KingdomBritish173325840001
    GABB, Anthony Hugh Samuel
    Updown House
    Hook Heath Road
    GU22 0QF Woking
    Surrey
    Diretor
    Updown House
    Hook Heath Road
    GU22 0QF Woking
    Surrey
    United KingdomBritish72717340002
    GILBART SMITH, Brian Martin
    The Coach House Twyford Road
    Waltham St Lawrence
    RG10 0HE Reading
    Berkshire
    Diretor
    The Coach House Twyford Road
    Waltham St Lawrence
    RG10 0HE Reading
    Berkshire
    EnglandBritish46668550001
    GRAVES, Adrian George
    The Old Vicarage
    Matching
    CM17 0QZ Harlow
    Essex
    Diretor
    The Old Vicarage
    Matching
    CM17 0QZ Harlow
    Essex
    EnglandUnited Kingdom36906810001
    GREEN, Jonathan Napier
    7 Earls Court Gardens
    SW5 0TD London
    Diretor
    7 Earls Court Gardens
    SW5 0TD London
    United KingdomBritish60228850001
    HARPER, Robert John
    Little Puxted
    Brenchley
    Tonbridge
    Kent
    Diretor
    Little Puxted
    Brenchley
    Tonbridge
    Kent
    British23885690001
    JUDD, Christopher
    Tendrings Farm
    Thaxted Road, Debden
    CB11 3LT Saffron Walden
    Essex
    Diretor
    Tendrings Farm
    Thaxted Road, Debden
    CB11 3LT Saffron Walden
    Essex
    British63845020002
    KAUNTZE, Ralph Anthony Charles
    Hansford House
    EX37 9ES Umberleigh
    North Devon
    Diretor
    Hansford House
    EX37 9ES Umberleigh
    North Devon
    British14338500002
    MARSHALL, Denis Alfred, Sir
    Redways
    Warfleet Road
    TQ6 9BZ Dartmouth
    Devon
    Diretor
    Redways
    Warfleet Road
    TQ6 9BZ Dartmouth
    Devon
    British105410001
    SHARP, Anthony Arthur Vivian
    Rookhurst House Colwell Lane
    RH17 7SR Haywards Heath
    West Sussex
    Diretor
    Rookhurst House Colwell Lane
    RH17 7SR Haywards Heath
    West Sussex
    British40355820001
    SHIPTON, John Keith
    Little Beadles
    Kings Avenue, Sandwich Bay
    CT13 9PG Sandwich
    Kent
    Diretor
    Little Beadles
    Kings Avenue, Sandwich Bay
    CT13 9PG Sandwich
    Kent
    EnglandBritish65780490001
    SOUTH, Anthony Ian Godfrey Charles
    Reightons, Houghton Green Lane
    Playden
    TN31 7PJ Rye
    East Sussex
    Diretor
    Reightons, Houghton Green Lane
    Playden
    TN31 7PJ Rye
    East Sussex
    British32778400003
    TAYLOR, Ian Auburn Cowing
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    Diretor
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    United KingdomBritish4866920001
    TAYLOR, Ian Auburn Cowing
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    Diretor
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    United KingdomBritish4866920001
    TAYLOR, John Joseph
    14 The Grove
    DA6 8HF Bexleyheath
    Kent
    Diretor
    14 The Grove
    DA6 8HF Bexleyheath
    Kent
    British3787030001
    WHITEHURST, David
    31 Sawyers Grove
    CM15 9BD Brentwood
    Essex
    Diretor
    31 Sawyers Grove
    CM15 9BD Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish3693340001

    ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Criado em 04/08/1998
    Entregue em 07/08/1998
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The deposit and all such rights to the repayment thereof as the company may at any time have under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement premier interest account 7024118.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 07/08/1998Registro de uma garantia (395)
    Deed of charge ("the deed") and made between the names and trustees (each defined therein) constituting the syndicate 33 1998 sterling borrowing group as chargors, hiscox syndicates limited and credit suisse first boston (the "bank") as chargee
    Criado em 22/01/1998
    Entregue em 03/02/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    A revolving loan facility in an aggregate amount of £100,000,000 or its equivalent from time to time in us dollars
    Breve descrição
    The trustees charge, by way of first floating charge, if and to the extent that such assets are or are liable in the future to become comprised in that part of the trust fund of the name in relation to which the managing agent has power to give directions all those particulars as detailed on form M395.
    Pessoas com direito
    • Credit Suisse First Boston
    Transações
    • 03/02/1998Registro de uma garantia (395)
    • 01/06/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge ("the deed") and made between the names and trustees (each defined therein) constituting the syndicate 33 1998 dollar borrowing group as chargors, hiscox syndicates limited and credit suisse first boston (the "bank") as chargee
    Criado em 22/01/1998
    Entregue em 03/02/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    A revolving loan facility in an aggregate amount £100,000,000 or it's equivalent from time to time in us dollars
    Breve descrição
    The trustees charge, by way of first floating charge if and to the extent that such assets are or liable in the future to become comprised in that part of the trust fund of the name in relation to which the managing agent has power to give directions all those particulars as detailed on form M395.
    Pessoas com direito
    • Credit Suisse First Boston
    Transações
    • 03/02/1998Registro de uma garantia (395)
    • 01/06/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    29/07/2011Início da liquidação
    08/01/2014Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Profissional
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0