ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED

ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02541313
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ATKINS ADVANTAGE SYSTEMS SOLUTIONS LIMITED20/03/200720/03/2007
    ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED05/01/200505/01/2005
    TA GROUP LIMITED15/03/199115/03/1991
    STEVTON (NO. 22) LIMITED19/09/199019/09/1990

    Quais são as últimas contas de ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2013

    Qual é o status da última declaração anual para ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Re dividend 11/12/2014
    RES13

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 05/01/2015

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração anual preparada até 20/09/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Término da nomeação de Alun Hughes Griffiths como diretor em 30/07/2014

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Alan James Cullens como diretor em 01/07/2014

    2 páginasAP01

    Contas preparadas até 31/03/2013

    4 páginasAA

    Declaração anual preparada até 20/09/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas preparadas até 31/03/2012

    4 páginasAA

    Declaração anual preparada até 20/09/2012 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Heath Stewart Drewett em 08/08/2012

    2 páginasCH01

    Nomeação de Mr Richard Webster como diretor em 01/01/2012

    2 páginasAP01

    Contas preparadas até 31/03/2011

    5 páginasAA

    Término da nomeação de Steven Johnson como diretor em 30/11/2011

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 20/09/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Nomeação de Steven Johnson como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Ian Purser como diretor

    1 páginasTM01

    Contas preparadas até 31/03/2010

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 20/09/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas preparadas até 31/03/2009

    11 páginasAA

    Quem são os diretores de ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BAKER, Helen Alice
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Secretário
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    British108742050002
    WEBSTER, Richard
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Secretário
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    British85595860003
    CULLENS, Alan James
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Diretor
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish189297280001
    DREWETT, Heath Stewart
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Diretor
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish167727030003
    WEBSTER, Richard
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Diretor
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish85595860003
    DAVIS, Philip Stephen James
    Hartland
    Woodside Drive
    RG18 9QD Hermitage
    Berkshire
    Secretário
    Hartland
    Woodside Drive
    RG18 9QD Hermitage
    Berkshire
    British71932630003
    MCMICHAEL, Peter John James
    99 Crookham Road
    Church Crookham
    GU51 5NP Fleet
    Hampshire
    Secretário
    99 Crookham Road
    Church Crookham
    GU51 5NP Fleet
    Hampshire
    British61866370001
    NICHOLLS, Michael Charles
    Dene Lodge
    63 The Street
    GU10 4QS Wrecclesham
    Surrey
    Secretário
    Dene Lodge
    63 The Street
    GU10 4QS Wrecclesham
    Surrey
    British82034810001
    STRUKELJ, Mark
    Glasnor Charters Road
    Sunningdale
    SL5 9QF Ascot
    Berkshire
    Secretário
    Glasnor Charters Road
    Sunningdale
    SL5 9QF Ascot
    Berkshire
    American41928460001
    THOMAS, Brian
    Camellia Lodge Longdown Road
    Lower Bourne
    GU10 3JU Farnham
    Surrey
    Secretário
    Camellia Lodge Longdown Road
    Lower Bourne
    GU10 3JU Farnham
    Surrey
    British7880860003
    WROE, Nigel Robert
    132 Henley Drive
    Frimley Green
    GU16 6JT Camberley
    Surrey
    Secretário
    132 Henley Drive
    Frimley Green
    GU16 6JT Camberley
    Surrey
    British38568880001
    BELL, Malcolm
    46 Beckside Gardens
    Chapel House
    NE5 1BQ Newcastle Upon Tyne
    Northumberland
    Diretor
    46 Beckside Gardens
    Chapel House
    NE5 1BQ Newcastle Upon Tyne
    Northumberland
    United KingdomBritish54168450001
    BRISTOW, Robert Philip, Dr
    86 Westfield Road
    GU22 9QA Woking
    Surrey
    Diretor
    86 Westfield Road
    GU22 9QA Woking
    Surrey
    EnglandBritish94953340001
    EARL, John Gilbert George
    7 Forest Crescent
    KT21 1JU Ashtead
    Surrey
    Diretor
    7 Forest Crescent
    KT21 1JU Ashtead
    Surrey
    British7880890001
    ENGLISH, Colin Nigel
    97 Clarence Road
    GU51 3RS Fleet
    Hampshire
    Diretor
    97 Clarence Road
    GU51 3RS Fleet
    Hampshire
    British54168540002
    GORMAN, Keith Michael Robert
    22 Haywarden Place
    Hartley Wintney
    RG27 8UA Basingstoke
    Hampshire
    Diretor
    22 Haywarden Place
    Hartley Wintney
    RG27 8UA Basingstoke
    Hampshire
    British47319860001
    GRIFFITHS, Alun Hughes
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Diretor
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    EnglandBritish47764900002
    GRINSTED, Noel William Marcus
    Tamarind House
    29 The Square
    PO14 4RT Titchfield
    Hampshire
    Diretor
    Tamarind House
    29 The Square
    PO14 4RT Titchfield
    Hampshire
    British18312850003
    ISOM, Byrd
    584 Parks Cross Roads
    Ch Rd
    27316 Ramseur Nc
    America
    Diretor
    584 Parks Cross Roads
    Ch Rd
    27316 Ramseur Nc
    America
    American69290680001
    JOHNSON, Steven
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Diretor
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish161365240001
    MACDONALD, John Malcolm Kenneth
    Ensor
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Diretor
    Ensor
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    British33673310001
    MACLEOD, Robert James
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Norther Farm
    Surrey
    Diretor
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Norther Farm
    Surrey
    United KingdomBritish90186680002
    MATHEW, Andrew Edwin
    1 Clare Mead
    Rowledge
    GU10 4BJ Farnham
    Surrey
    Diretor
    1 Clare Mead
    Rowledge
    GU10 4BJ Farnham
    Surrey
    British6661010001
    MCFALL, Godfrey
    Aspen Lodge
    78 Aldershot Road
    GU51 3FT Fleet
    Hampshire
    Diretor
    Aspen Lodge
    78 Aldershot Road
    GU51 3FT Fleet
    Hampshire
    British107285880001
    MCINNES, Alexander
    16 Brent Field Circle
    AB41 9DD Ellon
    Aberdeenshire
    Diretor
    16 Brent Field Circle
    AB41 9DD Ellon
    Aberdeenshire
    British6661020002
    MCMICHAEL, Peter John James
    99 Crookham Road
    Church Crookham
    GU51 5NP Fleet
    Hampshire
    Diretor
    99 Crookham Road
    Church Crookham
    GU51 5NP Fleet
    Hampshire
    British61866370001
    OGBORN, Alan Frederick
    22 Station Road
    NR34 9QJ Beccles
    Suffolk
    Diretor
    22 Station Road
    NR34 9QJ Beccles
    Suffolk
    British790970001
    PERCIVAL, David Robin
    11 Lamborne Close
    GU47 8JL Sandhurst
    Berkshire
    Diretor
    11 Lamborne Close
    GU47 8JL Sandhurst
    Berkshire
    EnglandBritish64840320001
    PURSER, Ian Robert
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Diretor
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish61343830005
    ROBINS, Geoffrey Alan, Dr
    Oakland House Oakland Road
    RG28 7HB Whitchurch
    Hampshire
    Diretor
    Oakland House Oakland Road
    RG28 7HB Whitchurch
    Hampshire
    United KingdomBritish54321770001
    ROBINS, Geoffrey Alan, Dr
    Oakland House Oakland Road
    RG28 7HB Whitchurch
    Hampshire
    Diretor
    Oakland House Oakland Road
    RG28 7HB Whitchurch
    Hampshire
    United KingdomBritish54321770001
    STRUKELJ, Mark
    Glasnor Charters Road
    Sunningdale
    SL5 9QF Ascot
    Berkshire
    Diretor
    Glasnor Charters Road
    Sunningdale
    SL5 9QF Ascot
    Berkshire
    American41928460001
    THOMAS, Brian
    Camellia Lodge Longdown Road
    Lower Bourne
    GU10 3JU Farnham
    Surrey
    Diretor
    Camellia Lodge Longdown Road
    Lower Bourne
    GU10 3JU Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish7880860003
    WHITE, Alan Alfred
    Craig Eunan House
    St Eunan's Road
    AB34 5HH Aboyne
    Aberdeenshire
    Diretor
    Craig Eunan House
    St Eunan's Road
    AB34 5HH Aboyne
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish1376100002
    WIGET, Paul
    Hirschistrasse 21
    6430 Schwyz
    Kt Schwyz
    Switzerland
    Diretor
    Hirschistrasse 21
    6430 Schwyz
    Kt Schwyz
    Switzerland
    Swiss41928420001

    ATKINS ADVANTAGE SYSTEM SOLUTIONS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture granted by the company,advantage business group limited and business mapping limited,now known as advantage business solutions limited, (together the "chargors")
    Criado em 15/02/2001
    Entregue em 02/03/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All indebtedness of the chargors (as defined) to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Fluor International Limited
    Transações
    • 02/03/2001Registro de uma garantia (395)
    • 02/02/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 15/02/2001
    Entregue em 27/02/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of first fixed charge all book and other debts both present and future and the benefit of all contracts policies of insurance in relation to such book and other debts by way of first floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company whatsoever and wheresoever.
    Pessoas com direito
    • Euro Sales Finance PLC
    Transações
    • 27/02/2001Registro de uma garantia (395)
    • 19/04/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 15/02/2001
    Entregue em 23/02/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Euro Sales Finance PLC
    Transações
    • 23/02/2001Registro de uma garantia (395)
    • 19/04/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 01/02/1991
    Entregue em 13/02/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 13/02/1991Registro de uma garantia
    • 03/03/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 01/02/1991
    Entregue em 07/02/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • 3I PLC
    Transações
    • 07/02/1991Registro de uma garantia
    • 19/03/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0