DIXON MOTOR HOLDINGS LIMITED

DIXON MOTOR HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaDIXON MOTOR HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaLiquidação
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02545627
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de DIXON MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    • (5010) /

    Onde fica DIXON MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Bdo Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de DIXON MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CITYAVON LIMITED03/10/199003/10/1990

    Quais são as últimas contas de DIXON MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    VencidoSim
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/12/2006
    Próximas contas vencem em31/10/2007
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2005

    Qual é o status da última declaração de confirmação para DIXON MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    VencidoSim
    Última declaração de confirmação elaborada até03/10/2016
    Próxima declaração de confirmação vence17/10/2016
    VencidoSim

    Qual é o status da última declaração anual para DIXON MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual
    VencidoSim

    Quais são as últimas submissões para DIXON MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Restauração por ordem judicial - anteriormente em liquidação voluntária de credores

    3 páginasREST-CVL

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    13 páginas4.72

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/07/2013

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/01/2013

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/07/2012

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/01/2012

    5 páginas4.68

    Notificação de cessação de atividade como liquidatário voluntário

    6 páginas4.40

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/07/2011

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/01/2011

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/07/2010

    5 páginas4.68

    legacy

    3 páginasMG02

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/01/2010

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/07/2009

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/01/2009

    23 páginas4.68

    Notificação de Constituição do Comité de Liquidação

    2 páginas4.48

    Declaração de negócios com formulário 2.14B

    5 páginas2.16B

    Aviso de mudança da administração para liquidação voluntária de credores

    6 páginas2.34B

    Resultado da reunião dos credores

    70 páginas2.23B

    Resultado da reunião dos credores

    4 páginas2.23B

    Certificado alterado de constituição do comitê de credores

    1 páginas2.26B

    legacy

    1 páginas288b

    Declaração de proposta do administrador

    68 páginas2.17B

    Nomeação de um administrador

    1 páginas2.12B

    legacy

    1 páginas287

    Quem são os diretores de DIXON MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CULLEN, Stephen Bernard
    14 Haweswater Drive
    Middleton
    M24 5GX Manchester
    Lancashire
    Diretor
    14 Haweswater Drive
    Middleton
    M24 5GX Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director112339610001
    HAINES, John Edward
    Green Hill
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Hampshire
    Diretor
    Green Hill
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Hampshire
    BritishCompany Director106170840001
    HOBSON, Garry
    Four Winds
    Sugar Lane
    HP1 2RT Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Diretor
    Four Winds
    Sugar Lane
    HP1 2RT Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector96262330001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Secretário
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    CUTHBERTSON, Garry
    8 Croft Park
    HU14 3JX North Ferriby
    North Humberside
    Secretário
    8 Croft Park
    HU14 3JX North Ferriby
    North Humberside
    BritishCompany Director54577250002
    DIMALINE, Brian Thomas
    73 Weardale
    HU7 6DJ Hull
    North Humberside
    Secretário
    73 Weardale
    HU7 6DJ Hull
    North Humberside
    British15271870001
    FRANKS, Ian Charles
    89 Swanland Road
    HU13 0NS Hessle
    North Humberside
    Secretário
    89 Swanland Road
    HU13 0NS Hessle
    North Humberside
    British71584820001
    KENT, Christopher Kenneth
    Stable Cottage
    Upton Road Clevelode
    WR13 6PB Malvern
    Worcestershire
    Secretário
    Stable Cottage
    Upton Road Clevelode
    WR13 6PB Malvern
    Worcestershire
    BritishCompany Director109770840004
    LEWIS, Derek John
    48 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    Secretário
    48 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    British34423910002
    BAILEY, Robert Andrew
    103 Wootton Road
    Kempson
    MK43 9BJ Bedford
    Bedfordshire
    Diretor
    103 Wootton Road
    Kempson
    MK43 9BJ Bedford
    Bedfordshire
    BritishBanker104106520001
    BEDFORD, Paul
    9 Preston Lane
    Great Preston
    LS26 8AT Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    9 Preston Lane
    Great Preston
    LS26 8AT Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director110773690001
    BOOTH, Thomas John
    Rose Farmhouse
    Seaton Ross
    YO42 4LZ York
    Diretor
    Rose Farmhouse
    Seaton Ross
    YO42 4LZ York
    BritishManaging Director104299390001
    BURROWS, Steven Richard
    205 Broom Lane
    S60 3NW Rotherham
    South Yorkshire
    Diretor
    205 Broom Lane
    S60 3NW Rotherham
    South Yorkshire
    BritishDirector71895270001
    CIULLO, Salvatore
    1 Birchwood Dell
    DN4 6SY Doncaster
    South Yorkshire
    Diretor
    1 Birchwood Dell
    DN4 6SY Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritishDirector105184160001
    CUTHBERTSON, Garry
    8 Croft Park
    HU14 3JX North Ferriby
    North Humberside
    Diretor
    8 Croft Park
    HU14 3JX North Ferriby
    North Humberside
    EnglandBritishCompany Director54577250002
    DIXON, Jamie Michael
    The Chapel
    Amen Lane Hotham
    York
    West Yorkshire
    Diretor
    The Chapel
    Amen Lane Hotham
    York
    West Yorkshire
    BritishCompany Director31568980002
    DIXON, Paul William Henry
    Mill Estate Hotham
    YO43 4UG Hotham
    Yorkshire
    Diretor
    Mill Estate Hotham
    YO43 4UG Hotham
    Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director153357310001
    DIXON, Simon Timothy
    Main Street
    Hotham
    YO43 4UF York
    St Oswaleds House
    North Yorkshire
    Diretor
    Main Street
    Hotham
    YO43 4UF York
    St Oswaleds House
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director101291990002
    DIXON, Sonia
    Silverdale 3 Hull Road
    HU16 4PA Cottingham
    North Humberside
    Diretor
    Silverdale 3 Hull Road
    HU16 4PA Cottingham
    North Humberside
    BritishCompany Director26717600001
    ELTON, Christopher Peter
    70b High Street
    Hook
    DN14 5NY Goole
    East Yorkshire
    Diretor
    70b High Street
    Hook
    DN14 5NY Goole
    East Yorkshire
    EnglandBritishAccountant47237180002
    KENT, Christopher Kenneth
    Stable Cottage
    Upton Road Clevelode
    WR13 6PB Malvern
    Worcestershire
    Diretor
    Stable Cottage
    Upton Road Clevelode
    WR13 6PB Malvern
    Worcestershire
    BritishCompany Director109770840004
    LAWSON BROWN, John
    The Brew House Hill Top Hall Farm
    Pannal
    HG3 1PA Harrogate
    North Yorkshire
    Diretor
    The Brew House Hill Top Hall Farm
    Pannal
    HG3 1PA Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director68292080001
    LYNDE, David
    Alder House Laburnum Farm Close
    Hessay
    YO26 8LG York
    Diretor
    Alder House Laburnum Farm Close
    Hessay
    YO26 8LG York
    GbrBritishCompany Director112339870001
    MARROW, Paul
    The Shutters 2 Nightjar Close
    Ewshot
    GU10 5TQ Farnham
    Surrey
    Diretor
    The Shutters 2 Nightjar Close
    Ewshot
    GU10 5TQ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishBanker85771600001
    PARKINSON, Alan Donald
    8 Pinchwell View
    Wickersley
    S66 1FP Rotherham
    South Yorkshire
    Diretor
    8 Pinchwell View
    Wickersley
    S66 1FP Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishBanker104435050001
    PEPPARD, Anthony Edward
    63 Green Lane
    Paddock Wood
    TN12 6BF Tonbridge
    Kent
    Diretor
    63 Green Lane
    Paddock Wood
    TN12 6BF Tonbridge
    Kent
    IrishManager76520410001
    RAMANATHAN, Shankar
    Mowson Hollow
    Worrall
    S35 0AD Sheffield
    3
    South Yorkshire
    Diretor
    Mowson Hollow
    Worrall
    S35 0AD Sheffield
    3
    South Yorkshire
    EnglandBritishBanker125663610001
    SPICKNELL, Mark Andrew
    88 Oakland Road
    DA6 7AL Bexleyheath
    Kent
    Diretor
    88 Oakland Road
    DA6 7AL Bexleyheath
    Kent
    EnglandBritishBanker104107710001
    STANWORTH, Mark
    45 Park Avenue
    Shelley
    HD8 8JY Huddersfield
    Diretor
    45 Park Avenue
    Shelley
    HD8 8JY Huddersfield
    EnglandBritishChartered Accountant67885350001
    TEALE, Andrew Richard
    98 The Stray Littlewold Lane
    HU15 2AL South Cave
    North Humberside
    Diretor
    98 The Stray Littlewold Lane
    HU15 2AL South Cave
    North Humberside
    BritishCompany Director75058100001

    DIXON MOTOR HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Fixed and floating security document
    Criado em 24/03/2006
    Entregue em 29/03/2006
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Psa Wholesale Limited
    Transações
    • 29/03/2006Registro de uma garantia (395)
    Fixed and floating security document
    Criado em 24/03/2006
    Entregue em 29/03/2006
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • General Motors Acceptance Corporation (UK) PLC
    Transações
    • 29/03/2006Registro de uma garantia (395)
    Fixed and floating security document
    Criado em 24/03/2006
    Entregue em 29/03/2006
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nissan Finance (GB) Limited
    Transações
    • 29/03/2006Registro de uma garantia (395)
    Fixed and floating security document
    Criado em 24/03/2006
    Entregue em 29/03/2006
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Rfs Limited
    Transações
    • 29/03/2006Registro de uma garantia (395)
    Fixed and floating security document
    Criado em 24/03/2006
    Entregue em 29/03/2006
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Fce Bank PLC
    Transações
    • 29/03/2006Registro de uma garantia (395)
    Fixed and floating security document
    Criado em 20/12/2005
    Entregue em 22/12/2005
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent (As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Transações
    • 22/12/2005Registro de uma garantia (395)
    • 03/04/2006Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 03/04/2006Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 03/04/2006Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 03/04/2006Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    Charge on vehicle stocks
    Criado em 20/12/2005
    Entregue em 21/12/2005
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of first fixed charge all such of the present and future propery and assets - rent hire charges etc, vehicles leased hired or sold, contracts deposited , title and interest, proceeds, insurance monies, benefits of guarantees indemnites and securities, debts, enforcement rights.
    Pessoas com direito
    • Fce Bank PLC
    Transações
    • 21/12/2005Registro de uma garantia (395)
    Supplemental debenture between dixon motors PLC certain of its subsidiaries (including the company) and the royal bank of scotland PLC as security agent and trustee for the lenders (as defined)
    Criado em 01/02/1999
    Entregue em 03/02/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each designated finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land and buildings on the south side of market street grimsby t/no: HS199863; f/h land k/a 271-291 bury new road and 8, 10 and 12 hilton street salford t/no: GM118716; f/h land k/a 206-206(a) great clowes street salford t/no: LA70372. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 03/02/1999Registro de uma garantia (395)
    • 06/12/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge on vehicle stocks
    Criado em 01/04/1998
    Entregue em 04/04/1998
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All new ford motor vehicles in posession of the borrower and all proceeds of sale thereof please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Ford Credit Europe PLC
    Transações
    • 04/04/1998Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 01/04/1998
    Entregue em 04/04/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Ford Credit Europe PLC
    Transações
    • 04/04/1998Registro de uma garantia (395)
    • 30/04/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental debenture
    Criado em 03/11/1997
    Entregue em 21/11/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee on any account whatsoever and under each designated finance document (as therein defined) except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Agent and Trustee for the Lenders)
    Transações
    • 21/11/1997Registro de uma garantia (395)
    • 06/12/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture (as supplemented by a deed dated 21ST august 1997 and supplemental debenture dated 13TH november 1997)
    Criado em 30/07/1997
    Adquirido em 20/02/1998
    Entregue em 25/02/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined in the syndicated revolving credit facility agreement dated 30TH july 1997) ("the revolving credit agreement") and to each lender (as defined in the revolving credit agreement) under each designated finance document (as defined in the debenture)
    Breve descrição
    All of the undertaking and assets of dixon vehicle sales limited relating to or used in the business (as defined in the agreement of even date). See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent and Trustee for the Lenders
    Transações
    • 25/02/1998Registro de uma aquisição (400)
    • 21/08/1998Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 06/12/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture (as supplemented by a supplemental debenture dated 3RD november 1997)
    Criado em 30/07/1997
    Adquirido em 31/12/1997
    Entregue em 14/01/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and/or each lender (as defined) under each designated finance document (as defined in the debenture)
    Breve descrição
    All of undertaking and assets of ferry car sales (hull) limited relating to or used in its business (as defined in the agreement dated 31ST december 1997; the "ferry agreement") including (without limitation) those assets and rights referred to in clause 2 of the ferry agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent and Trustee for the Lenders
    Transações
    • 14/01/1998Registro de uma aquisição (400)
    • 21/08/1998Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 06/12/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 30/07/1997
    Entregue em 15/08/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee as security agent and trustee for the lenders (as therein defined) on any account whatsoever and under each designated finance document (as therein defined) except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985
    Breve descrição
    By way of first legal mortgage: f/h land and buildings on the south west side of bradford road birstall t/n WYK421359; f/h land on the south west side of courtney street kingston upon hull t/n HS171081; f/h land k/a imperial garage clarence street kingston upon hull t/n HS230527, for details of further property charged please refer to form M395. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 15/08/1997Registro de uma garantia (395)
    • 06/12/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 23/11/1995
    Entregue em 02/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    All those monies which may from time to time be owing to dixon motor holdings limited by volkswagen group united kingdom limited in respect of refunds of monies paid by or by the direction of dixon motor holdings limited to volkswagen group united kingdom limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis.
    Pessoas com direito
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transações
    • 02/12/1995Registro de uma garantia (395)
    • 31/07/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal mortgage
    Criado em 26/09/1995
    Entregue em 05/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H property k/a land and buildings on the east side of range lane halifax west yorkshire t/n wyk 557086 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 05/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 01/03/1993
    Entregue em 09/03/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land at holderness road kingston upon hull t/nos part HS98896,part HS36710,part HS122630, part HS14763 together with all the transfer's right tile and interest in subsoil in the closed section of waller street kingston upon hull and/or the proceeds of sale thereof assigns the goodwill of the business, together with the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 09/03/1993Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 22/05/1992
    Entregue em 29/05/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land at beverly road,walkington,beverly,east yorkshire,humberside title no.HS122514 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 29/05/1992Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 22/05/1992
    Entregue em 29/05/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land at cowthey street hull,kingston upon hull humberside title no.HS171081 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 29/05/1992Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 22/05/1992
    Entregue em 29/05/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land at victoria street,grimsby,kingston-upon-hull humberside title no.HS86461 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 29/05/1992Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 22/05/1992
    Entregue em 29/05/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Sovereign garage,clarence street,hull,great grimsby,humberside title no.HS199870AND/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 29/05/1992Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 22/05/1992
    Entregue em 29/05/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land adjoining foster street and stoneferry road hull kingston upon hull title no.190247 And/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 29/05/1992Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 22/05/1992
    Entregue em 29/05/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Regency garage clarence street kingston upon hull,humberside title no.HS187606 and HS38609 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 29/05/1992Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 22/05/1992
    Entregue em 28/05/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 28/05/1992Registro de uma garantia (395)
    • 30/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 22/05/1992
    Entregue em 27/05/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H regency garage,naylor's row/shore street,kingston upon hull title no.HS38609 and HS187606.
    Pessoas com direito
    • 3I Group PLC
    Transações
    • 27/05/1992Registro de uma garantia (395)
    • 11/09/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    DIXON MOTOR HOLDINGS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    26/07/2007Início da administração
    30/01/2008Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    James Joseph Bannon
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Profissional
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Francis Graham Newton
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 City Square
    LS1 2DP Leeds
    Profissional
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 City Square
    LS1 2DP Leeds
    Toby Scott Underwood
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 City Square
    LS1 2DP Leeds
    Profissional
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 City Square
    LS1 2DP Leeds
    2
    DataTipo
    30/01/2008Início da liquidação
    09/12/2013Data de dissolução
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Francis Graham Newton
    Bdo Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds
    Profissional
    Bdo Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds
    Toby Scott Underwood
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds
    Profissional
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds
    James Joseph Bannon
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Profissional
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0