CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS
Visão geral
| Nome da empresa | CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada por garantia sem capital social |
| Número da empresa | 02551116 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS?
- Atividades de outras organizações de membros n.e.c. (94990) / Outras atividades de serviços
Onde fica CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS?
| Endereço do escritório registrado | C/O Cox Costello Langwood House 63-81 High Street WD3 1EQ Rickmansworth Hertfordshire |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 30/06/2016 |
Quais são as últimas submissões para CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 30/06/2016 | 7 páginas | AA | ||
Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2015 para 30/06/2016 | 1 páginas | AA01 | ||
Término da nomeação de Ian Anthony Charles Parkin como diretor em 27/10/2015 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaração anual preparada até 23/10/2015, não foi fornecida lista de membros | 5 páginas | AR01 | ||
Término da nomeação de Ann Fellows, M.B.E. como secretário em 30/06/2015 | 1 páginas | TM02 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mr John Campbell em 19/10/2015 | 2 páginas | CH01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mr Ian Anthony Charles Parkin em 19/10/2015 | 2 páginas | CH01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mr Neil Andrew Brown em 19/10/2015 | 2 páginas | CH01 | ||
Nomeação de Mr Robert Kenneth Thompson como diretor em 03/12/2014 | 2 páginas | AP01 | ||
Endereço do domicílio registado alterado de Confederation House Thornes Office Park Denby Dale Road Wakefield West Yorkshire WF2 7AN para C/O Cox Costello Langwood House 63-81 High Street Rickmansworth Hertfordshire WD3 1EQ em 16/11/2015 | 1 páginas | AD01 | ||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/12/2014 | 4 páginas | AA | ||
Segunda apresentação de AR01 previamente entregue à Companies House elaborado em 23/10/2013 | 21 páginas | RP04 | ||
Segunda apresentação de AR01 previamente entregue à Companies House elaborado em 23/10/2012 | 23 páginas | RP04 | ||
Término da nomeação de Gavin Anthony Styles como diretor em 03/12/2014 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Simon Byway como diretor em 28/11/2014 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Derek Mark Harrington como diretor em 24/11/2014 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaração anual preparada até 23/10/2014, não foi fornecida lista de membros | 5 páginas | AR01 | ||
Nomeação de Mr Gavin Anthony Styles como diretor em 02/06/2012 | 2 páginas | AP01 | ||
Endereço do domicílio registado alterado de , Conferderation House, Thornes Office Park, Denby Dale Road, Wakefield, WF2 7AN para Confederation House Thornes Office Park Denby Dale Road Wakefield West Yorkshire WF2 7AN em 05/11/2014 | 1 páginas | AD01 | ||
Nomeação de Mr Simon Byway como diretor em 01/07/2012 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Thomas John Allchurch como diretor em 09/10/2014 | 1 páginas | TM01 | ||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/12/2013 | 4 páginas | AA | ||
Quem são os diretores de CONFEDERATION OF UK COAL PRODUCERS?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN, Neil Andrew | Diretor | Langwood House 63-81 High Street WD3 1EQ Rickmansworth C/O Cox Costello Hertfordshire England | United Kingdom | British | 172615700001 | |||||
| CAMPBELL, John | Diretor | Langwood House 63-81 High Street WD3 1EQ Rickmansworth C/O Cox Costello Hertfordshire England | United Kingdom | British | 191409340002 | |||||
| THOMPSON, Robert Kenneth | Diretor | Langwood House 63-81 High Street WD3 1EQ Rickmansworth C/O Cox Costello Hertfordshire England | Wales | British | 156919650001 | |||||
| FELLOWS, M.B.E., Ann | Secretário | Langwood House 63-81 High Street WD3 1EQ Rickmansworth C/O Cox Costello Hertfordshire England | British | 39346050005 | ||||||
| GARNESS, Melvin | Secretário | 11 The Drive DN22 6SD Retford Nottinghamshire | British | 18761260001 | ||||||
| ALLCHURCH, Thomas John | Diretor | c/o Confederation Of Uk Coal Producers Thornes Office Park Denby Dale Road WF2 7AN Wakefield Confederation House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 59108210004 | |||||
| BEATTIE, Robert James | Diretor | The Mount House The Mount Farm EH35 5NN Ormiston East Lothian | British | 61571490001 | ||||||
| BREWER, David | Diretor | Stanley House 161 Chelsea Road S11 9BQ Sheffield | England | British | 62261620002 | |||||
| BREWER, David | Diretor | Stanley House 161 Chelsea Road S11 9BQ Sheffield | England | British | 62261620002 | |||||
| BROWN, James Scott | Diretor | Kirklands Of Damside PH3 1EU Auchterarder Perthshire | Scotland | British | 255210001 | |||||
| BUDGE, Richard John | Diretor | Conferderation House Thornes Office Park WF2 7AN Denby Dale Road Wakefield | United Kingdom | British | 27948060002 | |||||
| BYWAY, Simon | Diretor | Harworth Park, Blyth Road Harworth DN11 8DB Doncaster Harworth Park South Yorkshire England | England | British | 178514550001 | |||||
| CAIRNS, Philip | Diretor | Conferderation House Thornes Office Park WF2 7AN Denby Dale Road Wakefield | United Kingdom | British | 127894480003 | |||||
| CAVE, Philip John | Diretor | c/o Confederation Of Uk Coal Producers Thornes Office Park Denby Dale Road WF2 7AN Wakefield Confederation House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 108806440003 | |||||
| CHANCE, John Charles | Diretor | Linden Farm Bullbridge Hill Fritchley DE56 2FL Belper Derbyshire | British | 43220520001 | ||||||
| CLARKE, Robert Anthony | Diretor | 44 Leadhall Lane HG2 9NE Harrogate North Yorkshire | British | 3221280001 | ||||||
| CRABB, Niall Crawford | Diretor | 24 Ancrum Road EH22 3AJ Dalkeith Midlothian | British | 67196950004 | ||||||
| CRABB, Niall Crawford | Diretor | The Paddock Arleston Lane Wellington TF1 2LY Telford Shropshire | British | 67196950001 | ||||||
| CROSLAND, Ian Maxwell | Diretor | The Falls High Street Silkstone S75 4JN Barnsley South Yorkshire | British | 55221540001 | ||||||
| DEVINE, Iain James | Diretor | Pontefract Road Ackworth WF7 7EU Pontefract Paddock House West Yorkshire United Kingdom | England | British | 87925400001 | |||||
| FENTON, Guy James | Diretor | Loanhead Farmhouse Guildtown PH2 6DF Perth | Scotland | British | 52045430003 | |||||
| GARNER, Philip Edward | Diretor | c/o Confederation Of Uk Coal Producers Thornes Office Park Denby Dale Road WF2 7AN Wakefield Confederation House West Yorkshire United Kingdom | England | British | 120193760001 | |||||
| GILBERTSON, Alan Seaton | Diretor | 39 Castle Street Warkworth NE65 0UN Morpeth Northumberland | British | 69796870001 | ||||||
| GODFREY, Colin Leonard | Diretor | Liddell House Silver Street South Cerney GL7 5TS Cirencester Gloucestershire | United Kingdom | British | 48286090001 | |||||
| GOLIGHTLY, Andrew Philip | Diretor | 11 Spring Gardens West Auckland DL14 9SL Bishop Auckland County Durham | British | 64156970002 | ||||||
| HARRINGTON, Derek Mark | Diretor | Thornes Office Park Denby Dale Road WF2 7AN Wakefield Confederation House West Yorkshire England | England | British | 127775390001 | |||||
| HINKLEY, Geoffrey Andrew | Diretor | 6 Reigate Hill Close RH2 9PG Reigate Surrey | British | 37928390001 | ||||||
| HUGHES, James | Diretor | 1 Strethill Road Coalbrookdale TF8 7DP Telford Salop | British | 69658440001 | ||||||
| HUNT, Melvyn William Benoit | Diretor | The Old Barn 1 Grange Court High Grange DL15 8AZ Crook County Durham | United Kingdom | British | 16763200002 | |||||
| IKE, Henry Max | Diretor | 6 Hutton Close Nether Poppleton YO26 6PJ York North Yorkshire | Dutch | 67313250001 | ||||||
| LEVACK, Richard John | Diretor | Craighead Whistleberry Road G72 0TH Blantyre Glasgow | British | 22998090002 | ||||||
| MCGLEN, Christopher Andrew | Diretor | Conferderation House Thornes Office Park WF2 7AN Denby Dale Road Wakefield | United Kingdom | British | 110428450001 | |||||
| MCMEEKIN, Peter Henry Hubert | Diretor | 11 Barn Mead Theydon Bois CM16 7ET Epping Essex | British | 31080540001 | ||||||
| O'BRIEN, Patrick Sampson | Diretor | The Pantiles Main Street Hayton DN22 9LH Retford Nottinghamshire | British | 52186290001 | ||||||
| PARKIN, Ian Anthony Charles | Diretor | Langwood House 63-81 High Street WD3 1EQ Rickmansworth C/O Cox Costello Hertfordshire England | England | British | 18214980001 |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0