IMAGO 2014 LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaIMAGO 2014 LIMITED
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02575558
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de IMAGO 2014 LIMITED?

    • Comércio grossista de equipamentos e componentes eletrónicos e de telecomunicações (46520) / Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

    Onde fica IMAGO 2014 LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Odyssey Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de IMAGO 2014 LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    IMAGO 2014 PLC19/09/201419/09/2014
    IMAGO GROUP PLC05/03/200405/03/2004
    IMAGO MICRO LIMITED10/07/199110/07/1991
    DIPLEMA 245 LIMITED21/01/199121/01/1991

    Quais são as últimas contas de IMAGO 2014 LIMITED?

    VencidoSim
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em30/09/2020
    Próximas contas vencem em30/06/2021
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2019

    Qual é o status da última declaração de confirmação para IMAGO 2014 LIMITED?

    VencidoSim
    Última declaração de confirmação elaborada até21/01/2020
    Próxima declaração de confirmação vence04/02/2020
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até21/01/2019
    VencidoSim

    Quais são as últimas submissões para IMAGO 2014 LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Restauração por ordem judicial

    4 páginasAC92

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Contas de micro-entidade preparadas até 30/09/2019

    2 páginasAA

    Contas de micro-entidade preparadas até 30/09/2018

    2 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 21/01/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 30/09/2017

    5 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 21/01/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Detalhes do secretário alterados para Mrs Kay Vickerage em 12/12/2017

    1 páginasCH03

    Endereço do domicílio registado alterado de "Genesis" Snelsmore Common Newbury RG14 3BG England para Odyssey Westridge Highclere Newbury RG20 9PX em 12/12/2017

    1 páginasAD01

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 30/09/2016

    3 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 21/01/2017 com atualizações

    6 páginasCS01

    Contas consolidadas preparadas até 30/09/2015

    25 páginasAA

    Nomeação de Mrs Kay Vickerage como diretor em 01/04/2016

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 21/01/2016 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital26/01/2016

    Estado do capital em 26/01/2016

    • Capital: GBP 51,984.1
    SH01

    Contas consolidadas preparadas até 30/09/2014

    35 páginasAA

    Declaração anual preparada até 21/01/2015 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital22/01/2015

    Estado do capital em 22/01/2015

    • Capital: GBP 51,984.1
    SH01

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/07/2014 para 30/09/2014

    1 páginasAA01

    Satisfação total da garantia 12

    4 páginasMR04

    Certificado de mudança de nome e re-registo de sociedade anónima para sociedade limitada

    1 páginasCERT11

    Re-registo do memorando e estatutos

    44 páginasMAR

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de re-registo

    RES02

    Re-registo de uma sociedade anónima para uma sociedade de responsabilidade limitada

    1 páginasRR02

    Quem são os diretores de IMAGO 2014 LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    VICKERAGE, Kay
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    Secretário
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    British12466950002
    GEORGE, Andrew
    54 Wentworth Gardens
    GU34 2BJ Alton
    Hampshire
    Diretor
    54 Wentworth Gardens
    GU34 2BJ Alton
    Hampshire
    EnglandBritish115104730001
    VICKERAGE, Ian Geoffrey
    Snelsmore Common
    RG14 3BG Newbury
    "Genesis"
    Berkshire
    England
    Diretor
    Snelsmore Common
    RG14 3BG Newbury
    "Genesis"
    Berkshire
    England
    EnglandBritish24979700003
    VICKERAGE, Kay
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    Diretor
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    EnglandBritish207223290001
    WEBSTER, Martin
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    Secretário nomeado
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    British900005040001
    JONES, Kevin Gareth Brown
    52 Cartmel Drive
    Woodley
    RG5 3NG Reading
    Diretor
    52 Cartmel Drive
    Woodley
    RG5 3NG Reading
    British62807710002
    REARDON, Jonathan Andrew
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    Diretor nomeado
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    British900005030001
    WEBSTER, Martin
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    Diretor nomeado
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    British900005040001
    WRIGHT, Andrew John
    Acre Edge
    Longton By Passage, Walmer Bridge
    PR4 5RE Preston
    Lancashire
    Diretor
    Acre Edge
    Longton By Passage, Walmer Bridge
    PR4 5RE Preston
    Lancashire
    EnglandBritish70446280001
    ZABOURA, Margaret
    15 Whiteknights Road
    RG6 7BY Reading
    Berkshire
    Diretor
    15 Whiteknights Road
    RG6 7BY Reading
    Berkshire
    British60020330001
    ZARAIAH, Ralph
    31 Sycamore Close
    Garston
    WD2 6DF Watford
    Hertfordshire
    Diretor
    31 Sycamore Close
    Garston
    WD2 6DF Watford
    Hertfordshire
    British45893470001

    Quem são as pessoas com controle significativo de IMAGO 2014 LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Mr Ian Geoffrey Vickerage
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    14/04/2016
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    Não
    Nacionalidade: British
    País de residência: England
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 25% mas não mais de 50% das ações da empresa.
    Mrs Kay Vickerage
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    14/04/2016
    Westridge
    Highclere
    RG20 9PX Newbury
    Odyssey
    England
    Não
    Nacionalidade: British
    País de residência: England
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 25% mas não mais de 50% das ações da empresa.

    IMAGO 2014 LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    All assets debenture
    Criado em 31/01/2012
    Entregue em 02/02/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transações
    • 02/02/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 24/09/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 10/08/2004
    Entregue em 28/08/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 28/08/2004Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Fixed and floating charge
    Criado em 02/10/2003
    Entregue em 18/10/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transações
    • 18/10/2003Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Fixed and floating charge
    Criado em 16/07/2003
    Entregue em 19/07/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transações
    • 19/07/2003Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Criado em 21/11/2000
    Entregue em 30/11/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The account with the bank denominated in sterlimg designated lloyds tsb PLC re imago micro limited and now numbered 7559424, all deposits with the bank's treasury division in the name of the bank re the company.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 30/11/2000Registro de uma garantia (395)
    • 16/09/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Charge
    Criado em 02/10/2000
    Entregue em 04/10/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 28 september 2000 (as defined)
    Breve descrição
    Fixed charge upon all book and other debts present and future and all things in action, floating charge the stock in trade and the whole of the charged assets described above.
    Pessoas com direito
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transações
    • 04/10/2000Registro de uma garantia (395)
    • 13/09/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deposit deed
    Criado em 02/12/1999
    Entregue em 11/12/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and lease of even date
    Breve descrição
    All the companys right title benefit and interest in and to the account in which the deposit of £11,940.35 is held together with a sum equivalent to vat thereon.
    Pessoas com direito
    • Britel Developments (Thatcham) Limited
    Transações
    • 11/12/1999Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deposit deed
    Criado em 02/12/1999
    Entregue em 09/12/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 2 december 1999
    Breve descrição
    £11,940 due or to become due from the company to the chargee.
    Pessoas com direito
    • Britel Developments (Thatcham) Limited
    Transações
    • 09/12/1999Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2014Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    • 16/09/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Charge by way of debenture
    Criado em 10/02/1998
    Entregue em 14/02/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Close Invoice Finance Limited
    Transações
    • 14/02/1998Registro de uma garantia (395)
    • 13/09/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 28/04/1994
    Entregue em 11/05/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financing agreement or on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge over all book debts and other debts other than such debts as the factor may have specifically agreed in writing to exclude from such charge. Floating charge on all book debts and other debts of the company which are not charged by way of fixed charge.
    Pessoas com direito
    • Close Invoice Financing Limited
    Transações
    • 11/05/1994Registro de uma garantia (395)
    • 04/02/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Single debenture
    Criado em 17/03/1994
    Entregue em 23/03/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 23/03/1994Registro de uma garantia (395)
    • 04/02/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 04/08/1991
    Entregue em 15/08/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    (Including trade fixtures) (see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 15/08/1991Registro de uma garantia
    • 29/04/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0