APACHE UK LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | APACHE UK LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 02586435 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de APACHE UK LIMITED?
- Extração de petróleo bruto (06100) / Exploração de minas e pedreiras
Onde fica APACHE UK LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 27-28 Eastcastle Street London W1W 8DH |
|---|---|
| Endere ço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de APACHE UK LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| NOVUS UK (HARRIET) LIMITED | 07/07/1995 | 07/07/1995 |
| MONUMENT OIL (AUSTRALIA) LIMITED | 17/02/1992 | 17/02/1992 |
| SECAB OIL LIMITED | 15/03/1991 | 15/03/1991 |
| ALNERY NO. 1065 LIMITED | 27/02/1991 | 27/02/1991 |
Quais são as últimas contas de APACHE UK LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2020 |
Quais são as últimas submissões para APACHE UK LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2020 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Ross Michael Littlewood como diretor em 17/05/2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Ryan John James Chelte como diretor em 17/05/2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2019 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Timothy Richard Custer como diretor em 01/04/2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Jon Anthony Graham como diretor em 01/04/2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Ryan John James Chelte como diretor em 01/04/2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Ms Susan Greig como diretor em 01/04/2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Kenneth Hoyt Neupert como diretor em 01/04/2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2018 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2019 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2017 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2018 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2016 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2017 com atualizações | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Jon Anthony Graham como diretor em 01/04/2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Cory Lin Loegering como diretor em 01/04/2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado do capital em 21/12/2016
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
Quem são os diretores de APACHE UK LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secretário | Eastcastle Street W1W 8DH London 27-28 United Kingdom | 38636470004 | |||||||
| CUSTER, Timothy Richard | Diretor | Eastcastle Street W1W 8DH London 27-28 United Kingdom | United States | American | 265498400001 | |||||
| GREIG, Susan | Diretor | Eastcastle Street W1W 8DH London 27-28 United Kingdom | Scotland | British | 268697430001 | |||||
| LITTLEWOOD, Ross Michael | Diretor | Eastcastle Street W1W 8DH London 27-28 United Kingdom | United Kingdom | British | 285461910001 | |||||
| NEUPERT, Kenneth Hoyt | Diretor | Eastcastle Street W1W 8DH London 27-28 United Kingdom | United States | American | 268697420001 | |||||
| SAUER, Jon William | Diretor | 19 Cleerebrook Place 77382 The Woodlands Texas United States | United States | American | 88461340001 | |||||
| GOODWIN, Keith John | Secretário | 24 Esher Avenue KT12 2TA Walton On Thames Surrey | British | 44556890001 | ||||||
| HORNABROOK, James Trevor | Secretário | Middle Luxton Upottery EX14 9PA Honiton Devon | British | 11673550001 | ||||||
| PEPER, Cheri Lynette | Secretário | 8503 Braes Meadow Drive Houston Texas 77071 Usa | American | 59487280001 | ||||||
| STEER, Janette Lesley | Secretário | 16 Foxberry Road Brockley SE4 2SP London | British | 5200300001 | ||||||
| AIREY, Elisabeth Patricia | Diretor | 20 St Jamess Walk EC1R 0AP London | England | British | 107419680001 | |||||
| CHAMBERS, Thomas Patrick | Diretor | 27-28 Eastcastle Street London W1W 8DH | United States | American | 159261770001 | |||||
| CHELTE, Ryan John James | Diretor | Eastcastle Street W1W 8DH London 27-28 United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 268697440001 | |||||
| CRAVEN WALKER, Antony | Diretor | Square Du Val De La Cambre 3 1050 Bruxelles Belgium | British | 70900640001 | ||||||
| CRUM, John Alan | Diretor | 5341 Fayette Houston Texas Tx 77056 U.S.A. | American | 71107080011 | ||||||
| EICHLER, Rodney John | Diretor | South Niagra Circle Centennial 7267 Colorado 80112 United States | United States | American | 139236410001 | |||||
| FARRIS, George Steven | Diretor | 2606 Autumn Lake Drive Katy Texas 77450 Usa | American | 59487240001 | ||||||
| GOODWIN, Keith John | Diretor | 24 Esher Avenue KT12 2TA Walton On Thames Surrey | British | 44556890001 | ||||||
| GRAHAM, Jon Anthony | Diretor | 27-28 Eastcastle Street London W1W 8DH | United Kingdom | American | 228915630001 | |||||
| GUEST, James William | Diretor | Ash Farm Schoolhouse Lane Horsmonden TN12 8BJ Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 11673540001 | |||||
| HORNABROOK, James Trevor | Diretor | Middle Luxton Upottery EX14 9PA Honiton Devon | England | British | 11673550001 | |||||
| HOUSE, James Lynn | Diretor | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United States | American | 243265990001 | |||||
| KOBIASHVILI, Zurab Shakro | Diretor | 7 East Sunlight Forest Drive The Woodlands Texas 77381 Usa | American | 59487250001 | ||||||
| LEON ALONSO, Alfonso | Diretor | 27-28 Eastcastle Street London W1W 8DH | United States | Spanish | 191203250001 | |||||
| LOEGERING, Cory Lin | Diretor | 27-28 Eastcastle Street London W1W 8DH | United Kingdom | British | 200294400001 | |||||
| PATRICK, John Alexander | Diretor | Marley Mere Marley Lane GU27 3PZ Haslemere Surrey | British | 92558480001 | ||||||
| PLANK, Roger Barton | Diretor | 307 Teakwood Drive Houston Texas 77024 Usa | Usa | American | 59487200002 | |||||
| PRICE, Floyd Ray | Diretor | 4808 Laurel Street Bellaire Texas 77401 Usa | American | 59487230001 | ||||||
| VINGOE, Philip Arthur, Dr | Diretor | Bluebell Corner Deadhearn Lane HP8 4HG Chalfont St. Giles Buckinghamshire | Uk | British | 116452230001 | |||||
| VOYTOVICH, Thomas Edward | Diretor | 27-28 Eastcastle Street London W1W 8DH | United States Of America | American | 184028140001 | |||||
| WILLIAMS, Robert Charles, Dr | Diretor | Apt 2301 Observatory Tower 168 Kent Street Sydney New South Wales 2000 Australia | British | 44317420002 |
Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para APACHE UK LIMITED?
| Notificado em | Cessado em | Declaração |
|---|---|---|
| 01/06/2017 | A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa. |
APACHE UK LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Criado em 20/02/1998 Entregue em 26/02/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Payment of the rents reserved by and performance of the company's obligations in an underlease dated 20 february 1998 made between the city of london real property company limited and novus UK (harriet) limited | |
Breve descrição The sum of £10,312.50. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Fixed and floating equitable charge executed outside the united kingdom and comprising property situated outside the united kingdom | Criado em 26/07/1995 Entregue em 16/08/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company (formerly known as monument oil (australia) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the finance documents as defined therein | |
Breve descrição All the right title estate and interest of the company in the harriet interest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| An agreement to grant a charge | Criado em 13/06/1995 Entregue em 29/06/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All amounts due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the finance documents (as defined) | |
Breve descrição All the present and future right title estate and interest of the borrower in the harriet interest all insurances and the policies constituting the insurances proceeds of sale choses in action the borrower's books of account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0