TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 02587396 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
- Seguros não-vida (65120) / Atividades financeiras e de seguros
Onde fica TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Cast House Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| TRAVELLERS PROTECTION SERVICES LIMITED | 20/09/1994 | 20/09/1994 |
| GRAND UK INSURANCE SERVICES LIMITED | 01/03/1991 | 01/03/1991 |
Quais são as últimas contas de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2016 |
Quais são as últimas submissões para TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/03/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2016 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Satisfação total da garantia 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Nomeação de Mrs Penny Fullerton como secretário em 24/03/2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Stephen Blott como secretário em 24/03/2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/03/2016 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de Peter John Hubbard como diretor em 29/02/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Stephen Blott como secretário em 01/11/2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Jeffrey Christopher Orton como secretário em 01/11/2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2015 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/03/2015 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2014 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/03/2014 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de Michael Warren como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Michael Warren como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Jeffrey Christopher Orton como secretário | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Penelope Fullerton como secretário | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Mr Ryan Mark Gill como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mrs Penelope Jane Fullerton como secretário | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Stacey Zaczkiewicz como secretário | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2013 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/03/2013 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Quem são os diretores de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULLERTON, Penny | Secretário | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 206865730001 | |||||||
| BEALES, Karen Anne | Diretor | Marling Road Ainley Top HD2 2EE Huddersfield The Chalet Uk | England | British | 135540180002 | |||||
| GILL, Ryan Mark | Diretor | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 184068890001 | |||||
| SMITH, Malachy Paul | Diretor | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | Ireland | Irish | 262619320001 | |||||
| BLOOM, Colin Preston Paul | Secretário | 27 Woodfields Stradbroke IP21 5JQ Eye Suffolk | British | 21182260001 | ||||||
| BLOTT, Stephen | Secretário | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 202286490001 | |||||||
| BLOTT, Stephen | Secretário | Low Wood Wilsden BD15 0JS Bradford 30 West Yorkshire England | British | 139352410001 | ||||||
| FULLERTON, Penelope Jane | Secretário | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 184069960001 | |||||||
| LAWRENCE, Christopher | Secretário | Dunelm House 47b The Street NR13 5AA Brundall Norfolk | British | 90712300001 | ||||||
| ORTON, Jeffrey Christopher | Secretário | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 185565520001 | |||||||
| THORLEY, Anne | Secretário | 51 Mill Lane NR17 2NW Attleborough Norfolk | British | 26486150002 | ||||||
| WARMAN, Paul Jonathan | Secretário | The Old Rectory Horsey NR29 4EF Great Yarmouth Norfolk | British | 25255550003 | ||||||
| WARMAN, Paul Jonathan | Secretário | The Old Rectory Horsey NR29 4EF Great Yarmouth Norfolk | British | 25255550003 | ||||||
| ZACZKIEWICZ, Stacey | Secretário | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 170325190001 | |||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Secretário | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||
| PRIMARY GROUP SERVICES LIMITED | Secretário | 10 King William Street EC4N 7TW London | 107712310001 | |||||||
| ASPROU, Caroline Anna | Diretor | Highnoon Woodbastwick Road, Blofield Heath NR13 4QH Norwich Norfolk | British | 76073630001 | ||||||
| BELL, Graeme Paul | Diretor | 6 Moule Rise LS25 2PH Garforth West Yorkshire | England | British | 100163980001 | |||||
| CAMM, Suzanne Mary | Diretor | The Old Coach House Norwich Road Reepham NR10 4JN Norwich Norfolk | British | 80914120002 | ||||||
| FRANCIS, Timothy John | Diretor | Farm End Topcroft NR35 2BB Bungay Norfolk | British | 80914650001 | ||||||
| HARNBY, Alastair John | Diretor | Dene Bank BD16 4AR Bingley 21 West Yorkshire Uk | United Kingdom | British | 172070220002 | |||||
| HUBBARD, Peter John | Diretor | Sevenleaze Lane Edge GL6 6NL Stroud Huddaknoll House Gloucestershire United Kingdom | England | British | 28375870003 | |||||
| JAMES, Philip William Henry | Diretor | Hampton Head 9 Peppercorn Lane Southampton Sn 04 Bermuda | England | British | 33901640008 | |||||
| LAIRD, Oliver Walter | Diretor | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | United Kingdom | British | 233726140001 | |||||
| LAWRENCE, Christopher | Diretor | Dunelm House 47b The Street NR13 5AA Brundall Norfolk | British | 90712300001 | ||||||
| MARLEY, Nicholas James | Diretor | 6 The Brambles Woodside SW19 7AY London | United Kingdom | British | 113304050001 | |||||
| MCGUIRE, Elisabeth Mary | Diretor | 3 Landfall House Springvale PO34 5AN Seaview Isle Of Wight | British | 80914390001 | ||||||
| MEDDES, Kenneth Sydney | Diretor | Hillside Townhill Bramham LS23 6QD Wetherby | United Kingdom | British | 11486330002 | |||||
| NICHOL, Duncan Kirkbride, Sir | Diretor | 1 Pipers Close CH60 9LJ Heswall Merseyside | United Kingdom | British | 85618250001 | |||||
| POSNER, Howard Michael | Diretor | Stocks Lane HX2 6PR Luddenden Eaves House Halifax | United Kingdom | British | 139631580001 | |||||
| RIVETT, Paul Geoffrey Leo | Diretor | Westfield Place Whinburgh Road, Westfield NR19 1QJ Dereham Norfolk | British | 67188630001 | ||||||
| ROLFE, Timothy Paul | Diretor | 9 Overhill CR6 9JR Warlingham Surrey | England | British | 107872640001 | |||||
| SMITH, Paul Kenneth | Diretor | 4 Merchant Exchange Bridge Street YO1 6LT York North Yorkshire | United Kingdom | British | 126031290001 | |||||
| SMYTH, Timothy John | Diretor | 2 Knoll Road RH4 3EW Dorking Surrey | United Kingdom | British | 77794000002 | |||||
| THORLEY, Anne | Diretor | 51 Mill Lane NR17 2NW Attleborough Norfolk | British | 26486150002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uk General Insurance Limited | 06/04/2016 | Gibraltar Island Road Old Mill Business Park LS10 1RJ Leeds Cast House England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Criado em 28/02/2007 Entregue em 15/03/2007 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due of each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição First fixed charge all shares in any group company,all of its investments now or subsequently belonging to it held by an. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Charge of deposit | Criado em 24/12/2004 Entregue em 31/12/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Deposit initially of £50,000 credited to account designation 68126255 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0