THE NICE PUB COMPANY LIMITED

THE NICE PUB COMPANY LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTHE NICE PUB COMPANY LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02588139
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de THE NICE PUB COMPANY LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica THE NICE PUB COMPANY LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de THE NICE PUB COMPANY LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até29/04/2018

    Quais são as últimas submissões para THE NICE PUB COMPANY LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    11 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/01/2021

    10 páginasLIQ03

    Declaração de solvência

    5 páginasLIQ01

    Endereço do domicílio registado alterado de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom para Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU em 30/01/2020

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 16/01/2020

    LRESSP

    Declaração de confirmação apresentada em 06/03/2019 com atualizações

    4 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 29/04/2018

    10 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 06/03/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    Término da nomeação de Kirk Dyson Davis como diretor em 31/01/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Richard Smothers como diretor em 31/01/2018

    2 páginasAP01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/04/2017

    9 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 06/03/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 01/05/2016

    11 páginasAA

    Nomeação de Lindsay Anne Keswick como secretário em 25/04/2016

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Claire Susan Stewart como secretário em 25/04/2016

    1 páginasTM02

    Endereço do domicílio registado alterado de Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ para Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT em 07/03/2016

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 04/03/2016 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital07/03/2016

    Estado do capital em 07/03/2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 22/08/2015

    3 páginasAA

    Término da nomeação de Jonathan Robert Langford como diretor em 26/01/2016

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Daryl Antony Kelly como diretor em 26/01/2016

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Lucy Jane Bell como diretor em 26/01/2016

    1 páginasTM01

    Nomeação de Kirk Dyson Davis como diretor em 21/12/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Henry Jones como secretário em 04/12/2015

    1 páginasTM02

    Quem são os diretores de THE NICE PUB COMPANY LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Secretário
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    207524230001
    SMOTHERS, Richard
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Diretor
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector242658700001
    FREEMAN, Charles Truscott
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    Secretário
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    BritishDirector67008750001
    HALDENBY, Martin Jonathan
    67 Wilson Street
    HU10 7AJ Anlaby
    East Yorkshire
    Secretário
    67 Wilson Street
    HU10 7AJ Anlaby
    East Yorkshire
    British33479480001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592300001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Secretário
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    LUNT, Simon William
    7 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    North Humberside
    Secretário
    7 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    North Humberside
    British35566230001
    PRATT, Kenneth Leslie Thomas
    8 Stratton Park
    Swanland
    HU14 3NN North Ferriby
    North Humberside
    Secretário
    8 Stratton Park
    Swanland
    HU14 3NN North Ferriby
    North Humberside
    BritishCompany Director24300100001
    PRATT, Kenneth Leslie Thomas
    Jubilee Lodge 7 Walnut Grove
    East Bridgford
    NG13 8NS Nottingham
    Secretário
    Jubilee Lodge 7 Walnut Grove
    East Bridgford
    NG13 8NS Nottingham
    British24300100006
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172445180001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secretário
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181021610001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Secretário
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    British34191470001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Secretário
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    WATKINS, Simon Andrew
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    Secretário
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    British34048840002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretário nomeado
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector164754670001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant152083750001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector158484730001
    DE MIGUEL, Fiona Margaret
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    Diretor
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretariat Executive42996540002
    DUFFILL, Clare Marianne
    27 Churston Close
    162-164 Tulse Hill
    SW2 3BX London
    Diretor
    27 Churston Close
    162-164 Tulse Hill
    SW2 3BX London
    BritishCompany Secretariat Assisant71005690002
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141395280001
    FREEMAN, Charles Truscott
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector67008750001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector170184800001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Diretor
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritishDirector47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant86246470001
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector135408140001
    LUNT, Simon William
    7 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    North Humberside
    Diretor
    7 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    North Humberside
    BritishSolicitor35566230001
    MAPP, Derek
    Dunston Hole Farm Dunston Road
    Newbold
    S41 9RL Chesterfield
    Derbyshire
    Diretor
    Dunston Hole Farm Dunston Road
    Newbold
    S41 9RL Chesterfield
    Derbyshire
    BritishDirector-Retail12473610001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Diretor
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector42019620001
    MCQUARTER, Mark
    14 Townsend Drive
    AL3 5RQ St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    14 Townsend Drive
    AL3 5RQ St Albans
    Hertfordshire
    BritishManaging Director57915140001

    Quem são as pessoas com controle significativo de THE NICE PUB COMPANY LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    06/04/2016
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro2673413
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    THE NICE PUB COMPANY LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Guarantee and debenture
    Criado em 03/09/2000
    Entregue em 15/09/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the beneficiaries under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H l/h property k/a peacock inn 714 stannington nr sheffield t/no syk 344618 and SYK356684 ark tavern chesterfield road brimington chesterfield derbyshire t/no DY253380 and DY270253 together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Cibc World Markets PLC (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transações
    • 15/09/2000Registro de uma garantia (395)
    • 13/03/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 06/01/1995
    Entregue em 14/01/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a guarantee and debenture dated 10/3/94
    Breve descrição
    F/H land k/a the travellers rest public house intake lane pogmoor t/no SYK349003.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 14/01/1995Registro de uma garantia (395)
    • 02/12/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 10/03/1994
    Entregue em 14/03/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the facilities agreement and/or the swap agreements (as defined therein)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Lenders and the Swap Counterparties (As Defined Therein)
    Transações
    • 14/03/1994Registro de uma garantia (395)
    • 02/12/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 10/03/1994
    Entregue em 14/03/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All moneys standing to the credit of the accounts of the companies as per form 395.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 14/03/1994Registro de uma garantia (395)
    • 31/08/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Letter of charge
    Criado em 21/04/1993
    Entregue em 24/04/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All moneys standing to the credit of the account or accounts of the company by way of fixed and specific charge.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 24/04/1993Registro de uma garantia (395)
    • 08/04/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 06/05/1992
    Entregue em 22/05/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement and/or any of the financing documents (as defined)
    Breve descrição
    See 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 22/05/1992Registro de uma garantia (395)
    • 09/04/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 06/05/1992
    Entregue em 19/05/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company or any other group company to the chargee under the terms of the facility agreement and/or any of the financing documents (as defined) or pursuant to tthe trading agreement
    Breve descrição
    See form 395 and continuation sheets relevant to this charge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Scottish & Newcastle PLC or Any Other Member of the Scottish & Newcastle PLC Group of Companies
    Transações
    • 19/05/1992Registro de uma garantia (395)
    • 08/04/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    THE NICE PUB COMPANY LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    16/01/2020Início da liquidação
    25/04/2022Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Profissional
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Profissional
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0